MORRISON SHAND CONSTRUCTION LIMITED

MORRISON SHAND CONSTRUCTION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMORRISON SHAND CONSTRUCTION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02426459
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MORRISON SHAND CONSTRUCTION LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MORRISON SHAND CONSTRUCTION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Lancaster House Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Cambridgeshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MORRISON SHAND CONSTRUCTION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SHAND CIVIL ENGINEERING LIMITED 26 set 198926 set 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di MORRISON SHAND CONSTRUCTION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per MORRISON SHAND CONSTRUCTION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    6 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 nov 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    6 pagineAA

    Nomina di Awg Corporate Services Limited come segretario in data 22 feb 2021

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Elizabeth Ann Horlock Clarke come segretario in data 22 feb 2021

    1 pagineTM02

    Nomina di Wayne Paul Young come amministratore in data 15 feb 2021

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 nov 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del segretario cambiati per Elizabeth Ann Horlock Clarke il 18 nov 2020

    1 pagineCH03

    Modifica dei dettagli di Wave Holdings Limited come persona con controllo significativo il 11 mar 2020

    2 paginePSC05

    Modifica dei dettagli di Morco (3) Limited come persona con controllo significativo il 26 set 2019

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 nov 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Jonathan David Forster il 08 nov 2019

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Morco (3) Limited come persona con controllo significativo il 18 gen 2019

    2 paginePSC05

    Modifica dei dettagli di Morco (3) Limited come persona con controllo significativo il 18 gen 2019

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 nov 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 nov 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Claire Tytherleigh Russell come amministratore in data 28 lug 2016

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di MORRISON SHAND CONSTRUCTION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AWG CORPORATE SERVICES LIMITED
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Segretario
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione12618899
    270129230001
    FORSTER, Jonathan David
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishAccountant101812460002
    RUSSELL, Claire Tytherleigh
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    EnglandBritishLawyer105433380001
    YOUNG, Wayne Paul
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant264531200001
    CLARKE, Elizabeth Ann Horlock
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    Segretario
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    198551320001
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Segretario
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Segretario
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    MORRISON, John
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    Segretario
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    BritishSecretary1500260013
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Segretario
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Segretario
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    ALDRED, Andrew Charles
    4 Stanford Way
    Walton
    S42 7NH Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    4 Stanford Way
    Walton
    S42 7NH Chesterfield
    Derbyshire
    BritishCompany Director32078000001
    ANDERSON, Mark Stephen
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    Amministratore
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director122463830003
    BARN, Alistair Melville
    34 Hay Street
    PH1 5HS Perth
    Perthshire
    Amministratore
    34 Hay Street
    PH1 5HS Perth
    Perthshire
    BritishDirector1087370001
    CLARKE, Elizabeth Ann Horlock
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishChartered Secretary203580340001
    CROSON, Roger Archibald
    Belfit House 18 Nethermoor Road
    Wingerworth
    S42 6LJ Chesterfield
    Derbyshire
    England
    Amministratore
    Belfit House 18 Nethermoor Road
    Wingerworth
    S42 6LJ Chesterfield
    Derbyshire
    England
    BritishManaging Director4350003
    FIRTH, Patrick
    The Cottage
    High Street
    PE28 0AB Ellington Huntingdon
    Cambs
    Amministratore
    The Cottage
    High Street
    PE28 0AB Ellington Huntingdon
    Cambs
    BritishSolicitor85034900001
    GILLESPIE, Kenneth
    15 Craigs Bank
    EH12 8HD Edinburgh
    Amministratore
    15 Craigs Bank
    EH12 8HD Edinburgh
    EnglandBritishDirector77321980001
    HAMPSON, Michael David
    Anglian House
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Cambs
    Amministratore
    Anglian House
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Cambs
    BritishCompany Director105084640001
    HEATHERSHAW, Peter Anthony
    1 Limecroft View
    Wingerworth
    S42 6NR Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    1 Limecroft View
    Wingerworth
    S42 6NR Chesterfield
    Derbyshire
    BritishDirector20068550001
    HOWELL, Keith Martin
    Lynehurst Carlops Road
    EH46 7DS West Linton
    Peeblesshire
    Amministratore
    Lynehurst Carlops Road
    EH46 7DS West Linton
    Peeblesshire
    BritishFinance Director1499960006
    JEFFS, David John
    17 Old Mill Lane
    Clifford
    LS23 6LE Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    17 Old Mill Lane
    Clifford
    LS23 6LE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director3812460001
    JEFFS, David John
    17 Old Mill Lane
    Clifford
    LS23 6LE Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    17 Old Mill Lane
    Clifford
    LS23 6LE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director3812460001
    LE LORRAIN, Michael Robert
    Orchard House
    3 Lea Brooks Close
    PE28 2RA Warboys
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Orchard House
    3 Lea Brooks Close
    PE28 2RA Warboys
    Cambridgeshire
    EnglandBritishDirector93716830003
    LOWE, Richard Alexander
    Cherry Tree 29 The View
    Alwoodley
    LS17 7NF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Cherry Tree 29 The View
    Alwoodley
    LS17 7NF Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector32078010001
    MORRISON, Alexander Fraser
    Wester House 4 Wester Coates Gardens
    EH12 5LT Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    Wester House 4 Wester Coates Gardens
    EH12 5LT Edinburgh
    Lothian
    BritishDirector Of Companies4330001
    MORRISON, John
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    Amministratore
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    BritishSecretary1500260013
    NILSSON, Lars Ingvar
    Stora Fiskaregaten 9e
    S 222 24
    FOREIGN Lund
    Sweden
    Amministratore
    Stora Fiskaregaten 9e
    S 222 24
    FOREIGN Lund
    Sweden
    SwedishDirector76837160001
    O'DELL, Robert James
    12 Wensley Grove
    HG2 8AH Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    12 Wensley Grove
    HG2 8AH Harrogate
    North Yorkshire
    BritishCompany Director Quantity Surv6337720001
    RUSSELL, Claire Tytherleigh
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    EnglandBritishLawyer105433380001
    SALT, Anthony Charles
    Sepycoe Farm
    Longford
    DE6 3DR Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    Sepycoe Farm
    Longford
    DE6 3DR Ashbourne
    Derbyshire
    BritishCommercial Director34136380001
    TALLANT, Kenneth
    Brambles, 9 The Park
    Mayfield
    DE6 2HT Ashbourne
    Derby
    Amministratore
    Brambles, 9 The Park
    Mayfield
    DE6 2HT Ashbourne
    Derby
    EnglandBritishQuantity Surveyor124187000001
    TAYLOR, Brian
    29 Station Road
    Castle Donington
    DE74 2NJ Derby
    Amministratore
    29 Station Road
    Castle Donington
    DE74 2NJ Derby
    BritishCompany Director34136880001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    Amministratore
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Secretary135181230001
    WALSH, Stephen
    589 London Road
    Davenham
    CW9 8LN Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    589 London Road
    Davenham
    CW9 8LN Northwich
    Cheshire
    EnglandBritishDirector60529360002
    WARRACK, Anne Victoria Mary
    The White Cottage
    153 Bridge Street, Whddon
    SG8 5SP Royston
    Herts
    Amministratore
    The White Cottage
    153 Bridge Street, Whddon
    SG8 5SP Royston
    Herts
    United KingdomBritishCompany Secretary123157220001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MORRISON SHAND CONSTRUCTION LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Wave Holdings Limited
    15 Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    C/O Brodies Llp
    Scotland
    06 apr 2016
    15 Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    C/O Brodies Llp
    Scotland
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom (Scotland)
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneUnited Kingdom (Scotland)
    Numero di registrazioneSc218929
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MORRISON SHAND CONSTRUCTION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 07 apr 1992
    Consegnato il 10 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 set 1993Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 23 ott 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 20 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 06 feb 1992
    Consegnato il 20 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 set 1993Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 23 ott 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 20 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0