CARE IN BATHING LTD

CARE IN BATHING LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCARE IN BATHING LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02426566
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CARE IN BATHING LTD?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CARE IN BATHING LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 20-21 Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CARE IN BATHING LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PREMIER BATHROOMS LTD.17 ott 199517 ott 1995
    GULLYMERE LIMITED26 set 198926 set 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di CARE IN BATHING LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 ago 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per CARE IN BATHING LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 apr 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Sotos Constantinides come amministratore in data 30 ott 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Michael Murray come amministratore in data 18 ott 2023

    1 pagineTM01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 ago 2022

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 apr 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 ago 2021

    3 pagineAA

    Nomina di Stephen Michael Murray come amministratore in data 18 ott 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jeremy Simon Ling come amministratore in data 16 nov 2021

    1 pagineTM01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 ago 2020

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ago 2019

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 apr 2020 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Jeremy Simon Ling come amministratore in data 01 dic 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Lawrence Edward Warriner come amministratore in data 17 feb 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Kevin Bage come amministratore in data 31 gen 2020

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Premier House Hewell Road Enfield Redditch Worcestershire B97 6BW a Unit 20-21 Padgets Lane Redditch B98 0RA in data 29 ago 2019

    1 pagineAD01

    legacy

    6 pagineRP04CS01

    Bilancio redatto al 31 ago 2018

    25 pagineAA

    Cessazione di Mobility Bathing Group Limited come persona con controllo significativo il 31 ago 2018

    3 paginePSC07

    Chi sono gli amministratori di CARE IN BATHING LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CONSTANTINIDES, Sotos
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    Amministratore
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    United KingdomBritish124622460002
    ELLIS, Lee Richard
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    Amministratore
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    EnglandBritish199559150001
    FARMILOE, Gordon Trevarthen
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Segretario
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    British48633500003
    FARMILOE, Gordon Trevarthen
    Perry Mill Farm
    Perry Mill Lane
    B98 6RR Bradley Green Redditch
    Segretario
    Perry Mill Farm
    Perry Mill Lane
    B98 6RR Bradley Green Redditch
    British48633500003
    BAGE, Kevin Bruce
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    Amministratore
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    EnglandBritish212484210001
    CHAPMAN, Richard Anthony
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish141406650001
    ELLIS, Steven
    Rose Cottage
    Main Street
    WR10 2LX Bishampton
    Worcestershire
    Amministratore
    Rose Cottage
    Main Street
    WR10 2LX Bishampton
    Worcestershire
    British84557420001
    FARMILOE, Gordon Trevarthen
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish150955160001
    FARMILOE, Gordon Trevarthen
    Perry Mill Farm
    Perry Mill Lane
    B98 6RR Bradley Green Redditch
    Amministratore
    Perry Mill Farm
    Perry Mill Lane
    B98 6RR Bradley Green Redditch
    EnglandBritish48633500003
    FARMILOE, Malcolm Patrick
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish5663680011
    FARMILOE, Malcolm Patrick
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    United KingdomBritish5663680009
    FARMILOE, Philip Geoffrey
    Manor Cottage
    Abbots Morton
    WR7 4NA Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Manor Cottage
    Abbots Morton
    WR7 4NA Worcester
    Worcestershire
    United KingdomBritish23681750002
    GARDNER, John William
    9 Caynham Close
    Winyates West
    B98 0JF Redditch
    Amministratore
    9 Caynham Close
    Winyates West
    B98 0JF Redditch
    British53982190004
    HARVEY, Paul Andrew
    1 Manor Road
    B80 7NA Studley
    Warwickshire
    Amministratore
    1 Manor Road
    B80 7NA Studley
    Warwickshire
    EnglandEnglish50633130002
    HOWE, Michael
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish32724080002
    HURFURT, Gareth John
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish112699190001
    JUSTICE, Kevin Thomas
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    United KingdomBritish189302640001
    LING, Jeremy Simon
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    Amministratore
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    EnglandBritish267364260001
    MOSEDALE, Michael John
    44 Luddington Road
    B92 9QH Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    44 Luddington Road
    B92 9QH Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish14506050002
    MURRAY, Stephen Michael
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Units 20-21
    England
    Amministratore
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Units 20-21
    England
    EnglandBritish290563950001
    NEWBROOK, David
    5 Wasdale Court
    WR4 9YT Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    5 Wasdale Court
    WR4 9YT Worcester
    Worcestershire
    British28917950001
    PRICE, Richard Duncan
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish111545180001
    VAUGHAN, Andrew Derek
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish174693630001
    WARRINER, Lawrence Edward
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    Amministratore
    Padgets Lane
    B98 0RA Redditch
    Unit 20-21
    England
    United KingdomBritish119997720001
    WATSON, Andrew Terence
    12 Battenhall Road
    WR5 2BL Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    12 Battenhall Road
    WR5 2BL Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish107091420001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CARE IN BATHING LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Hewell Road
    B97 6BW Redditch
    Premier House
    England
    31 ago 2018
    Hewell Road
    B97 6BW Redditch
    Premier House
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05522263
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Hewell Road
    B97 6BW Redditch
    Premier House
    England
    06 apr 2016
    Hewell Road
    B97 6BW Redditch
    Premier House
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione10097440
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Hc1264 Limited
    Hewell Road
    Enfield
    B97 6BW Redditch
    Premier House
    Worcester
    06 apr 2016
    Hewell Road
    Enfield
    B97 6BW Redditch
    Premier House
    Worcester
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleThe Law Of England And Wales
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies
    Numero di registrazione10097440
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    CARE IN BATHING LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 21 feb 2018
    Consegnato il 05 mar 2018
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lonsdale Capital Partners LLP
    Transazioni
    • 05 mar 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 21 feb 2018
    Consegnato il 22 feb 2018
    In corso
    Breve descrizione
    The freehold property known as unit 1, enfield industrial estate, hewell road, redditch, B97 6BG and registered at the land registry with title number HW110381.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent)
    Transazioni
    • 22 feb 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 04 ott 2016
    Consegnato il 06 ott 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All that freehold property known as premier house, unit 1 enfield industrial estate, hewell road, redditch, worcestershire B97 6BG registered at the land registry under title number HW110381.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 26 feb 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 20 lug 2016
    Consegnato il 20 lug 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    A fixed and floating charge over all assets.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 20 lug 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 26 feb 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 26 mag 2016
    Consegnato il 31 mag 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Unit 1, enfield industrial estate, hewell road, redditch, B97 6BG. Title number HW110381.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Catalyst Business Finance LTD
    Transazioni
    • 31 mag 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 15 apr 2016
    Consegnato il 26 apr 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Catalyst Business Finance LTD
    Transazioni
    • 26 apr 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 11 mar 2015
    Consegnato il 13 mar 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Unit 1 enfield industrial estate hewell road redditch t/n HW110381.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Bank of New York Mellon London Branch as Security Trustee (As Security Trustee for Each of the Secured Parties)
    Transazioni
    • 13 mar 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 27 ott 2011
    Consegnato il 02 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H properties at unit 16 vigo place hayward industrial estate aldridge t/n WM884026, gainsborough house brickyard road aldridge and unit 16 vigo place hayward industrial estate aldridge west midlands and any buildings, fixtures, fittings, fixed plant or machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Trustee
    Transazioni
    • 02 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Omnibus letter of set-off
    Creato il 24 ott 2011
    Consegnato il 28 ott 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 01 apr 2011
    Consegnato il 18 apr 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property at unit 1 enfield industrial estate, hewell road, redditch t/no HW110381 and any buildings, fixtures, fittings, fixed plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Trustee
    Transazioni
    • 18 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 01 apr 2011
    Consegnato il 18 apr 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether for its own account or as trustee for the secured parties or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Trustee
    Transazioni
    • 18 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 20 mar 2007
    Consegnato il 04 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Philip Farmiloe
    Transazioni
    • 04 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 mar 2007
    Consegnato il 04 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 08 mar 2006
    Consegnato il 22 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a unit 1, enfield industrial estate, hewell road, redditch t/no HW110381. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 08 mar 2006
    Consegnato il 22 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 30 set 1999
    Consegnato il 13 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 1, enfield industrial estate hewell road redditch worcestershire t/n HW110381.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 nov 1998
    Consegnato il 22 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The f/h property k/a unit 1 enfield industrial estate hewell road redditch t/n HW110381.
    Persone aventi diritto
    • Philip Geoffrey Farmiloe
    Transazioni
    • 22 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 nov 1998
    Consegnato il 22 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000 and all other monies due or to become due from the company under the debenture
    Brevi particolari
    The f/h property k/a unit 1 enfield industrial estate hewell road redditch t/n HW110381. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Philip Geoffrey Farmiloe
    Transazioni
    • 22 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 mar 1995
    Consegnato il 29 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £30,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Philip Geoffrey Farmiloe
    Transazioni
    • 29 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 nov 1993
    Consegnato il 16 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £10,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Floating charge on the undertaking property and uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Philip Geoffrey Farmiloe
    Transazioni
    • 16 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 mag 1993
    Consegnato il 09 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0