PINDAR PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPINDAR PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 02428709
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PINDAR PLC?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PINDAR PLC?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Kpmg Llp 1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PINDAR PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PINDAR GRAPHICS PLC17 nov 198917 nov 1989
    METROTAB PUBLIC LIMITED COMPANY 03 ott 198903 ott 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di PINDAR PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per PINDAR PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 11 gen 2013

    31 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 15 gen 2013

    31 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 13 nov 2012

    33 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 13 mag 2012

    33 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Bilancio annuale redatto al 12 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 apr 2012

    Stato del capitale al 16 apr 2012

    • Capitale: GBP 2,000,000
    SH01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 25 gen 2012

    44 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    75 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    36 pagine2.16B

    Cessazione della carica di Jenna Holliday come segretario

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Thornburgh Road Eastfield Scarborough North Yorkshire YO11 3UY in data 03 ago 2011

    1 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    31 pagineMG01

    legacy

    31 pagineMG01

    Cessazione della carica di Andrew Holmes come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    5 pagineMG01

    Bilancio consolidato redatto al 30 set 2010

    27 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2009

    26 pagineAA

    Nomina di Mr Andrew Charles David Holmes come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di PINDAR PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PINDAR, George Thomas Ventress
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    Amministratore
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    United KingdomBritish1020460001
    PINDAR, George Andrew
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    Amministratore
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    EnglandBritish1120570003
    HOLLIDAY, Jenna Louise
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    Segretario
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    British136386570001
    NOAKES, David Anthony
    21 Town Street
    Old Malton
    YO17 7HB Malton
    North Yorkshire
    Segretario
    21 Town Street
    Old Malton
    YO17 7HB Malton
    North Yorkshire
    British54380850004
    WHITTAKER, Paul Meredith Allen
    Martin Garth
    86 Hutton Buscel
    YO13 9LN Scarborough
    North Yorkshire
    Segretario
    Martin Garth
    86 Hutton Buscel
    YO13 9LN Scarborough
    North Yorkshire
    British29811100001
    WOOLLEY, Heather Caroline
    25 Mayville Avenue
    YO12 7NW Scarborough
    North Yorkshire
    Segretario
    25 Mayville Avenue
    YO12 7NW Scarborough
    North Yorkshire
    British38563500003
    BROUGHAM, Martyn
    2 Sawyers Walk
    Dunnington
    YO19 5SJ York
    North Yorkshire
    Amministratore
    2 Sawyers Walk
    Dunnington
    YO19 5SJ York
    North Yorkshire
    British60080800002
    COWLEY, Christian Anthony
    59 Station Road
    Scholes
    LS15 4BY Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    59 Station Road
    Scholes
    LS15 4BY Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish27271120001
    DALTON, Andrew Leslie
    Kirby House Farm
    Kirby Knowle
    YO7 2JF Thirsk
    North Yorkshire
    Amministratore
    Kirby House Farm
    Kirby Knowle
    YO7 2JF Thirsk
    North Yorkshire
    EnglandBritish116104960001
    DUGGLEBY, Paul Neil
    Lowgill
    LA2 8PS Lancaster
    Mill Bridge Barn
    United Kingdom
    Amministratore
    Lowgill
    LA2 8PS Lancaster
    Mill Bridge Barn
    United Kingdom
    United KingdomBritish42924780005
    GRAY, Richard David
    1 West Parade
    NR2 3DN Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    1 West Parade
    NR2 3DN Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish56284200002
    HOLMES, Andrew Charles David
    Thornburgh Road
    Eastfield
    YO11 3UY Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Thornburgh Road
    Eastfield
    YO11 3UY Scarborough
    North Yorkshire
    United KingdomBritish64104370003
    LONGBOTHAM, David George
    34 Water Lane
    Dunnington
    YO1 5NS York
    N Yorkshire
    Amministratore
    34 Water Lane
    Dunnington
    YO1 5NS York
    N Yorkshire
    British24899320001
    LUMBY, Richard Stephen
    30 North Street
    Scalby
    YO13 0RP Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    30 North Street
    Scalby
    YO13 0RP Scarborough
    North Yorkshire
    British5653290001
    MCFIE SNEDDON, Mark
    11 Oriel Close
    Walkington
    HU17 8YD Beverley
    North Humberside
    Amministratore
    11 Oriel Close
    Walkington
    HU17 8YD Beverley
    North Humberside
    British71831240001
    NIVEN, Fraser Irvine
    30 Bonaly Avenue
    EH13 0ET Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    30 Bonaly Avenue
    EH13 0ET Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish1245890002
    O'SULLIVAN, Paul Joseph
    Robin Hill
    Ravenscar
    Y013 ONA Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Robin Hill
    Ravenscar
    Y013 ONA Scarborough
    North Yorkshire
    British39741380001
    PALFREY, David Gwyn
    Bay Horse Cottage
    19 Main Street Ebberston
    YO13 9NR Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Bay Horse Cottage
    19 Main Street Ebberston
    YO13 9NR Scarborough
    North Yorkshire
    British1209930001
    PINDAR, George Andrew
    Southend House
    Burniston
    YO13 0HP Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Southend House
    Burniston
    YO13 0HP Scarborough
    North Yorkshire
    British1120570001
    STREET, Nigel
    19 New Walk Terrace
    YO10 4BG York
    North Yorkshire
    Amministratore
    19 New Walk Terrace
    YO10 4BG York
    North Yorkshire
    British60080730002
    WHITE, John
    St Johns Cottage
    8 East Avenue Scalby
    YO13 0QE Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    St Johns Cottage
    8 East Avenue Scalby
    YO13 0QE Scarborough
    North Yorkshire
    British5503640001
    WILKINSON, Peter James
    Bridgewater House 16 Station Road
    Scalby
    YO13 0PU Scarborough
    Amministratore
    Bridgewater House 16 Station Road
    Scalby
    YO13 0PU Scarborough
    EnglandBritish70519070001

    PINDAR PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Chattels mortgage
    Creato il 19 mag 2011
    Consegnato il 27 mag 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    With full title guarantee assigns the items of equipment and/or other chattels described or referred to in the schedule being 4 sets of 5 bays adjustable botless steel pallet racking, vacuumatic counter and mettler toledo electronic scale and remote platform (for details of all other equipment charged, please refer to the MG01 document).
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Chattel mortgage
    Creato il 19 mag 2011
    Consegnato il 27 mag 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of a specific first charge all right, title and interest in and to the equipment being 4 sets of 5 bays adjustable boltless steel pallet racking, vacuumatic counter and mettler toledo electronic scale and remote platform (for details of all other equipment charged, please refer to the MG01 document).
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Equipment Finance (UK) Limited and Hsbc Asset Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 27 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal assignment
    Creato il 06 mag 2011
    Consegnato il 07 mag 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Chattel mortgage
    Creato il 16 giu 2004
    Consegnato il 21 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Heidelberg - five colour printing press / s/no: 537137; heidelberg - five colour printing press / s/no: 540261; heidelberg - five colour printing press / s/no: 537749; muller - saddle stitching machine / s/no: 91.06593/42.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 21 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 apr 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 29 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Floating charge
    Creato il 05 dic 2003
    Consegnato il 06 dic 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the undertaking, all assets now owned or hereafter acquired including the stock in trdae and its uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transazioni
    • 06 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattels mortgage
    Creato il 28 dic 2000
    Consegnato il 28 dic 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto or any part thereof muller martini tempo saddle stitcher equipped with four type 416 feeders streatmfeeders 3738, card folder 344, rapido stacker into FW67/FJK41 filmwrapping line and cohiba palletiser s/n SAP368060.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 28 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 14 feb 2000
    Consegnato il 17 feb 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under an agreement for the purchase of debts
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement (including the associated rights as defined in the agreement) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transazioni
    • 17 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 11 feb 2000
    Consegnato il 15 feb 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 15 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 09 giu 1999
    Consegnato il 15 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £5,217,250 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    One new man roland and web offset printing press type lithoman iv serial no 27666 with all accessories and component parts and all improvements and renewals with all books manuals and handbooks technical data drawings schedules and other documentation.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 15 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 13 gen 1995
    Consegnato il 13 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    One new heidelberg 102 speedmaster five colour offset press model 102F + l cp tronic controlled 72 x 102CM with coating system, complete with CPC1-03 alcolor dampening and CPC4 plate registration device, serial no: 537137 together with ancillary equipment. One new CPC3-s plate image reader serial no: 0057 together with ancillary equipment.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 13 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattels mortgage
    Creato il 04 gen 1995
    Consegnato il 04 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule. One new heidelberg harris web offset press model M600, serial no:mc Y0057 no. 51, together with ancillary equipment, serial nos:0044 da, 0218 ma, 28 0006010, 180193, 197.01.0080& 550051 6/94. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 04 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 09 lug 1991
    Consegnato il 10 lug 1991
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 1991Registrazione di un'ipoteca

    PINDAR PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 lug 2011Inizio dell'amministrazione
    15 gen 2013Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Granville Firmin
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Praticante
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Praticante
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Praticante
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0