HARLOSH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHARLOSH LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02429046
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HARLOSH LIMITED?

    • Sviluppo di software per le imprese e per uso domestico (62012) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova HARLOSH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HARLOSH LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HARLOSH ASSOCIATES LIMITED04 ott 198904 ott 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di HARLOSH LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per HARLOSH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    10 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2023 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Roger Newman come amministratore in data 01 set 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2021

    21 pagineAA

    Cessazione della carica di Patrick Michael Byrne come amministratore in data 31 lug 2021

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2020

    19 pagineAA

    Cessazione della carica di Christopher Andrew Mills come amministratore in data 11 dic 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Spencer Doman come amministratore in data 05 ott 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Terence Alexander Baxter come amministratore in data 30 ott 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Catherine Elizabeth Rowe come amministratore in data 07 set 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Christopher Andrew Mills come amministratore in data 31 lug 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Roger Newman come amministratore in data 31 lug 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Iestyn David Evans come amministratore in data 19 giu 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Catherine Elizabeth Rowe come amministratore in data 04 mag 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Ian David Larkin come amministratore in data 31 dic 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2019

    20 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di HARLOSH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AGARWAL, Vivek Satish
    Nanakramguda
    Sertingampally
    500 032 Hyderabad
    Flat No. 303
    India
    Amministratore
    Nanakramguda
    Sertingampally
    500 032 Hyderabad
    Flat No. 303
    India
    IndiaIndian237485530001
    WALLACE, Aileen
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    ScotlandBritish201422060001
    BEBB, Dafydd Llywelyn
    Imperial Way
    NP10 8UH Newport
    Imperial House
    Wales
    Segretario
    Imperial Way
    NP10 8UH Newport
    Imperial House
    Wales
    188311470001
    GORDON, Alison Jayne
    Longshadow Barn
    Marston Hill
    GL7 5LF Cirencester
    Glos
    Segretario
    Longshadow Barn
    Marston Hill
    GL7 5LF Cirencester
    Glos
    British6874870002
    JENKINS, Philip
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    Segretario
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    Welsh10866140001
    SMITH, Martin
    4 Ballard Road
    BH19 1NG Swanage
    Dorset
    Segretario
    4 Ballard Road
    BH19 1NG Swanage
    Dorset
    British10568450002
    ALLEY, William Michael
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    EnglandBritish186347120001
    BAXTER, Terence Alexander
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritish195623390001
    BYRNE, Patrick Michael
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritish127876200001
    DOMAN, Andrew Spencer
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    EnglandAustralian131618880001
    EARLEY, Martin John Raymond
    The Cottage
    Poplar Farm, Dunfield
    GL7 4HE Fairford
    Gloucestershire
    Amministratore
    The Cottage
    Poplar Farm, Dunfield
    GL7 4HE Fairford
    Gloucestershire
    British19312960003
    EVANS, Iestyn David
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish181858390001
    GORDON, Alison Jayne
    Longshadow Barn
    Marston Hill
    GL7 5LF Cirencester
    Glos
    Amministratore
    Longshadow Barn
    Marston Hill
    GL7 5LF Cirencester
    Glos
    British6874870002
    GORDON, Richard Mcarthur
    Longshadow Barn
    Marston Hill
    GL7 5LF Cirencester
    Glos
    Amministratore
    Longshadow Barn
    Marston Hill
    GL7 5LF Cirencester
    Glos
    British6874880002
    HALL, Jerry
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    New ZealandBritish129050910001
    HALL, Jerry
    115 Merlin Park
    Portishead
    BS20 8RL Bristol
    Avon
    Amministratore
    115 Merlin Park
    Portishead
    BS20 8RL Bristol
    Avon
    British103493520001
    HAWKINS, David Grant
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish6114280002
    HEATH, David William
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritish161757780001
    HUNT, John
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    EnglandBritish176403430001
    LARKIN, Ian David, Mr.
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    EnglandIrish187338620001
    MARSHALL, Claire
    16 Falkner Close
    SN8 1UG Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    16 Falkner Close
    SN8 1UG Marlborough
    Wiltshire
    British103175620002
    MILLS, Christopher Andrew
    Imperial Way
    Coedkernew
    NP10 8UH Newport
    Target Group
    Wales
    Amministratore
    Imperial Way
    Coedkernew
    NP10 8UH Newport
    Target Group
    Wales
    EnglandBritish271899540001
    NEWMAN, Roger
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    EnglandBritish273582760001
    ROBERTSON, Steven Andrew
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    EnglandBritish201552830001
    ROMANIW, David Charles Mark
    9 Ascot Drive
    SA12 8YL Port Talbot
    West Glamorgan
    Amministratore
    9 Ascot Drive
    SA12 8YL Port Talbot
    West Glamorgan
    United KingdomBritish18198220003
    ROWE, Catherine Elizabeth
    Imperial Way
    Coedkernew
    NP10 8UH Newport
    Target Group
    Wales
    Amministratore
    Imperial Way
    Coedkernew
    NP10 8UH Newport
    Target Group
    Wales
    EnglandBritish122647690002
    RUDOLF, James De Montjoie
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish134487640001
    SMITH, Martin
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritish10568450002
    SMITH, Martin
    4 Ballard Road
    BH19 1NG Swanage
    Dorset
    Amministratore
    4 Ballard Road
    BH19 1NG Swanage
    Dorset
    United KingdomBritish10568450002
    SNOW, James Robert Ballintine
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Target House
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritish245145750001
    TAGLIAFERRI, Mark Lee
    Flat 2
    105 Cadogan Gardens
    SW3 2RF London
    Amministratore
    Flat 2
    105 Cadogan Gardens
    SW3 2RF London
    United KingdomBritish,American106792270001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HARLOSH LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Target Group Limited
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    5-19
    Wales
    06 apr 2016
    Cowbridge Road East
    CF11 9AU Cardiff
    5-19
    Wales
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneWales, Uk
    Autorità legaleThe Companies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House England And Wales
    Numero di registrazione1208137
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    HARLOSH LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second ranking debenture
    Creato il 29 feb 2012
    Consegnato il 19 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title interest and benefit from time to time present and future in to under and in respect of all specific contracts all present and future investments and all specific insurances fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Robin Holding Sarl
    Transazioni
    • 19 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security deposit deed
    Creato il 01 giu 2009
    Consegnato il 17 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Deposit of £10,325.
    Persone aventi diritto
    • Julian Hulbert Mowbray Jackson
    Transazioni
    • 17 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security depost deed
    Creato il 28 feb 2006
    Consegnato il 11 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit of £10,325 in an interest bearing bank account.
    Persone aventi diritto
    • Julian Hulbert Mowbray Jackson
    Transazioni
    • 11 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security deposit deed
    Creato il 04 ott 2002
    Consegnato il 09 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Rent deposit of £3,525.
    Persone aventi diritto
    • Julian Hulbert Mowbray Jackson
    Transazioni
    • 09 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security deposit deed
    Creato il 11 set 2001
    Consegnato il 19 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date
    Brevi particolari
    The deposit of £14,500 in an interest bearing account at barclays bank PLC, 28 market place, cirencester GL7 2NP or in the chargee's solicitors' halifax professionals account.
    Persone aventi diritto
    • Julian Hulbert Mowbray Jackson
    Transazioni
    • 19 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security deposit deed
    Creato il 25 set 1998
    Consegnato il 01 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 25 september 1998
    Brevi particolari
    The deposit of £3,000 in an interest bearing bank account at barclays bank PLC 28 market place cirencester GL7 2NP.
    Persone aventi diritto
    • Julian Hulbert Mowbray Jackson
    Transazioni
    • 01 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 ott 1997
    Consegnato il 21 ott 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0