HARLOSH LIMITED
Panoramica
| Nome della società | HARLOSH LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02429046 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HARLOSH LIMITED?
- Sviluppo di software per le imprese e per uso domestico (62012) / Informazione e comunicazione
Dove si trova HARLOSH LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Target House Cowbridge Road East CF11 9AU Cardiff South Glamorgan |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HARLOSH LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| HARLOSH ASSOCIATES LIMITED | 04 ott 1989 | 04 ott 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HARLOSH LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per HARLOSH LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 10 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2023 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Roger Newman come amministratore in data 01 set 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2021 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Patrick Michael Byrne come amministratore in data 31 lug 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2020 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Andrew Mills come amministratore in data 11 dic 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Spencer Doman come amministratore in data 05 ott 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Terence Alexander Baxter come amministratore in data 30 ott 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Catherine Elizabeth Rowe come amministratore in data 07 set 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Christopher Andrew Mills come amministratore in data 31 lug 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Roger Newman come amministratore in data 31 lug 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Iestyn David Evans come amministratore in data 19 giu 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Catherine Elizabeth Rowe come amministratore in data 04 mag 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian David Larkin come amministratore in data 31 dic 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2019 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di HARLOSH LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGARWAL, Vivek Satish | Amministratore | Nanakramguda Sertingampally 500 032 Hyderabad Flat No. 303 India | India | Indian | 237485530001 | |||||
| WALLACE, Aileen | Amministratore | Target House Cowbridge Road East CF11 9AU Cardiff South Glamorgan | Scotland | British | 201422060001 | |||||
| BEBB, Dafydd Llywelyn | Segretario | Imperial Way NP10 8UH Newport Imperial House Wales | 188311470001 | |||||||
| GORDON, Alison Jayne | Segretario | Longshadow Barn Marston Hill GL7 5LF Cirencester Glos | British | 6874870002 | ||||||
| JENKINS, Philip | Segretario | Target House Cowbridge Road East CF11 9AU Cardiff South Glamorgan | Welsh | 10866140001 | ||||||
| SMITH, Martin | Segretario | 4 Ballard Road BH19 1NG Swanage Dorset | British | 10568450002 | ||||||
| ALLEY, William Michael | Amministratore | Target House Cowbridge Road East CF11 9AU Cardiff South Glamorgan | England | British | 186347120001 | |||||
| BAXTER, Terence Alexander | Amministratore | Target House Cowbridge Road East CF11 9AU Cardiff South Glamorgan | United Kingdom | British | 195623390001 | |||||
| BYRNE, Patrick Michael | Amministratore | Target House Cowbridge Road East CF11 9AU Cardiff South Glamorgan | United Kingdom | British | 127876200001 | |||||
| DOMAN, Andrew Spencer | Amministratore | Target House Cowbridge Road East CF11 9AU Cardiff South Glamorgan | England | Australian | 131618880001 | |||||
| EARLEY, Martin John Raymond | Amministratore | The Cottage Poplar Farm, Dunfield GL7 4HE Fairford Gloucestershire | British | 19312960003 | ||||||
| EVANS, Iestyn David | Amministratore | Target House Cowbridge Road East CF11 9AU Cardiff South Glamorgan | Wales | British | 181858390001 | |||||
| GORDON, Alison Jayne | Amministratore | Longshadow Barn Marston Hill GL7 5LF Cirencester Glos | British | 6874870002 | ||||||
| GORDON, Richard Mcarthur | Amministratore | Longshadow Barn Marston Hill GL7 5LF Cirencester Glos | British | 6874880002 | ||||||
| HALL, Jerry | Amministratore | Target House Cowbridge Road East CF11 9AU Cardiff South Glamorgan | New Zealand | British | 129050910001 | |||||
| HALL, Jerry | Amministratore | 115 Merlin Park Portishead BS20 8RL Bristol Avon | British | 103493520001 | ||||||
| HAWKINS, David Grant | Amministratore | Target House Cowbridge Road East CF11 9AU Cardiff South Glamorgan | Wales | British | 6114280002 | |||||
| HEATH, David William | Amministratore | Target House Cowbridge Road East CF11 9AU Cardiff South Glamorgan | United Kingdom | British | 161757780001 | |||||
| HUNT, John | Amministratore | Target House Cowbridge Road East CF11 9AU Cardiff South Glamorgan | England | British | 176403430001 | |||||
| LARKIN, Ian David, Mr. | Amministratore | Target House Cowbridge Road East CF11 9AU Cardiff South Glamorgan | England | Irish | 187338620001 | |||||
| MARSHALL, Claire | Amministratore | 16 Falkner Close SN8 1UG Marlborough Wiltshire | British | 103175620002 | ||||||
| MILLS, Christopher Andrew | Amministratore | Imperial Way Coedkernew NP10 8UH Newport Target Group Wales | England | British | 271899540001 | |||||
| NEWMAN, Roger | Amministratore | Target House Cowbridge Road East CF11 9AU Cardiff South Glamorgan | England | British | 273582760001 | |||||
| ROBERTSON, Steven Andrew | Amministratore | Target House Cowbridge Road East CF11 9AU Cardiff South Glamorgan | England | British | 201552830001 | |||||
| ROMANIW, David Charles Mark | Amministratore | 9 Ascot Drive SA12 8YL Port Talbot West Glamorgan | United Kingdom | British | 18198220003 | |||||
| ROWE, Catherine Elizabeth | Amministratore | Imperial Way Coedkernew NP10 8UH Newport Target Group Wales | England | British | 122647690002 | |||||
| RUDOLF, James De Montjoie | Amministratore | Target House Cowbridge Road East CF11 9AU Cardiff South Glamorgan | Wales | British | 134487640001 | |||||
| SMITH, Martin | Amministratore | Target House Cowbridge Road East CF11 9AU Cardiff South Glamorgan | United Kingdom | British | 10568450002 | |||||
| SMITH, Martin | Amministratore | 4 Ballard Road BH19 1NG Swanage Dorset | United Kingdom | British | 10568450002 | |||||
| SNOW, James Robert Ballintine | Amministratore | Target House Cowbridge Road East CF11 9AU Cardiff South Glamorgan | United Kingdom | British | 245145750001 | |||||
| TAGLIAFERRI, Mark Lee | Amministratore | Flat 2 105 Cadogan Gardens SW3 2RF London | United Kingdom | British,American | 106792270001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di HARLOSH LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Group Limited | 06 apr 2016 | Cowbridge Road East CF11 9AU Cardiff 5-19 Wales | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
HARLOSH LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Second ranking debenture | Creato il 29 feb 2012 Consegnato il 19 mar 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right title interest and benefit from time to time present and future in to under and in respect of all specific contracts all present and future investments and all specific insurances fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security deposit deed | Creato il 01 giu 2009 Consegnato il 17 giu 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Deposit of £10,325. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security depost deed | Creato il 28 feb 2006 Consegnato il 11 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The deposit of £10,325 in an interest bearing bank account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security deposit deed | Creato il 04 ott 2002 Consegnato il 09 ott 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Rent deposit of £3,525. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security deposit deed | Creato il 11 set 2001 Consegnato il 19 set 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date | |
Brevi particolari The deposit of £14,500 in an interest bearing account at barclays bank PLC, 28 market place, cirencester GL7 2NP or in the chargee's solicitors' halifax professionals account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security deposit deed | Creato il 25 set 1998 Consegnato il 01 ott 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 25 september 1998 | |
Brevi particolari The deposit of £3,000 in an interest bearing bank account at barclays bank PLC 28 market place cirencester GL7 2NP. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 13 ott 1997 Consegnato il 21 ott 1997 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0