COX PLASTICS TECHNOLOGIES LIMITED

COX PLASTICS TECHNOLOGIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOX PLASTICS TECHNOLOGIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02429408
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COX PLASTICS TECHNOLOGIES LIMITED?

    • (2524) /

    Dove si trova COX PLASTICS TECHNOLOGIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Pc Cox Turnpike Industrial Estate
    Turnpike Road
    RG14 2LR Newbury
    Berkshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COX PLASTICS TECHNOLOGIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ARK PLASTIC PRODUCTS LIMITED05 ott 198905 ott 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di COX PLASTICS TECHNOLOGIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per COX PLASTICS TECHNOLOGIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 giu 2010

    Stato del capitale al 23 giu 2010

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    17 pagineAA

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine403a

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    legacy

    6 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    13 pagineAA

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2006

    6 pagineAA

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2005

    6 pagineAA

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    30 pagine395

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    4 pagine395

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    7 pagine363s

    Memorandum e Statuto

    10 pagineMA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed ark plastic products LIMITED\certificate issued on 07/06/06
    2 pagineCERTNM

    Chi sono gli amministratori di COX PLASTICS TECHNOLOGIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CRAWFORD, Peter
    Flintwall Cottage
    Ashmansworth
    RG20 9SS Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Flintwall Cottage
    Ashmansworth
    RG20 9SS Newbury
    Berkshire
    British116054670001
    CRAWFORD, Peter
    Flintwall Cottage
    Ashmansworth
    RG20 9SS Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Flintwall Cottage
    Ashmansworth
    RG20 9SS Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish116054670001
    LUMB, Frederick Jan
    24 High Street
    Great Cheverell
    SN10 5TH Devizes
    Wiltshire
    Amministratore
    24 High Street
    Great Cheverell
    SN10 5TH Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish53013890002
    BARBER, Andrew Kevin
    4 The Smithy
    NN3 3PL Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    4 The Smithy
    NN3 3PL Northampton
    Northamptonshire
    British17925340003
    JAMESON, Robert Anthony
    4 Barbers Wood Road
    HP12 4EP High Wycombe
    Buckinghamshire
    Segretario
    4 Barbers Wood Road
    HP12 4EP High Wycombe
    Buckinghamshire
    British15014980001
    BARBER, Andrew Kevin
    4 The Smithy
    NN3 3PL Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    4 The Smithy
    NN3 3PL Northampton
    Northamptonshire
    British17925340003
    BARBER, Keith
    24 Manor Plc
    Nether Heyford
    NN7 3NN
    Northants
    Amministratore
    24 Manor Plc
    Nether Heyford
    NN7 3NN
    Northants
    British17925350001
    JAMESON, Robert Anthony
    4 Barbers Wood Road
    HP12 4EP High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    4 Barbers Wood Road
    HP12 4EP High Wycombe
    Buckinghamshire
    British15014980001
    PORTER, David
    6 Kenwin Close
    Stratton St Margaret
    SN3 4NY Swindon
    Wiltshire
    Amministratore
    6 Kenwin Close
    Stratton St Margaret
    SN3 4NY Swindon
    Wiltshire
    British58295100001

    COX PLASTICS TECHNOLOGIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and debenture
    Creato il 27 nov 2007
    Consegnato il 06 dic 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Venture Finance PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 17 gen 2007
    Consegnato il 20 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the plant, machinery, chattels and/or other equipment specified in the schedule being, demag ergotech 250-840 NC4 vdu moulding machine s/no:878-0329, demag ergotech 250-840 NC4 vdu moulding machine s/no:878-0574, 2 off isolator switches, for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 lug 2000
    Consegnato il 26 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 gen 1990
    Consegnato il 18 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 01 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0