OFQUEST LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOFQUEST LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02429501
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OFQUEST LIMITED?

    • (3614) /

    Dove si trova OFQUEST LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Begbies Traynor 9th Floor
    Bond Court
    LS1 2JZ Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OFQUEST LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DESKING SYSTEMS LIMITED17 ott 199117 ott 1991
    WELLPAY LIMITED05 ott 198905 ott 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di OFQUEST LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2007

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per OFQUEST LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per OFQUEST LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    16 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 giu 2014

    21 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 giu 2014

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 dic 2013

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 giu 2013

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 dic 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 giu 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 dic 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 lug 2013

    18 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 giu 2012

    17 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 giu 2011

    5 pagine4.68

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 18 giu 2010

    16 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    16 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 11 gen 2010

    14 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 11 lug 2009

    11 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    12 pagine2.16B

    Risultato della riunione dei creditori

    33 pagine2.23B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    32 pagine2.17B

    legacy

    2 pagine288b

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di OFQUEST LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRAYSHAW, Neil Andrew
    3 Finchley Lane
    OX6 8AE Bicester
    Oxfordshire
    Amministratore
    3 Finchley Lane
    OX6 8AE Bicester
    Oxfordshire
    EnglandBritishOperations Director59805060001
    OFQUEST DIRECTOR LIMITED
    Irton House
    Warpsgrove Lane, Chalgrove
    OX44 7TH Oxford
    Amministratore
    Irton House
    Warpsgrove Lane, Chalgrove
    OX44 7TH Oxford
    101569120002
    BARKER, James Edward
    The Old Vicarage
    Cragg Vale
    HX7 5TB Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Segretario
    The Old Vicarage
    Cragg Vale
    HX7 5TB Hebden Bridge
    West Yorkshire
    British42890001
    BENNETT, Phillip James
    Grove House Daw Lane
    Horbury
    WF4 5DR Wakefield
    West Yorkshire
    Segretario
    Grove House Daw Lane
    Horbury
    WF4 5DR Wakefield
    West Yorkshire
    BritishCompany Director113393520001
    KING, Lorna
    Slade Road
    Stokenchurch
    HP14 3QH High Wycombe
    34
    Buckinghamshire
    Segretario
    Slade Road
    Stokenchurch
    HP14 3QH High Wycombe
    34
    Buckinghamshire
    British130153660001
    GWB SECRETARY LIMITED
    Crossley House
    Hopwood Lane
    HX1 5EB Halifax
    West Yorkshire
    Segretario
    Crossley House
    Hopwood Lane
    HX1 5EB Halifax
    West Yorkshire
    83825250001
    OFQUEST SECRETARY LIMITED
    Irton House
    Warpsgrove Lane, Chalgrove
    OX44 7TH Oxford
    Segretario
    Irton House
    Warpsgrove Lane, Chalgrove
    OX44 7TH Oxford
    86085190002
    ALLEN, Christopher Taylor
    65 Seven Acres
    OX9 3JQ Thame
    Oxfordshire
    Amministratore
    65 Seven Acres
    OX9 3JQ Thame
    Oxfordshire
    BritishFinancial Director45256100001
    ATKIN, John Dudley
    Manor Farm
    Marston St Lawrence
    OX17 2DA Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Manor Farm
    Marston St Lawrence
    OX17 2DA Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishFinance Director47046270004
    BARKER, James Edward
    The Old Vicarage
    Cragg Vale
    HX7 5TB Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Cragg Vale
    HX7 5TB Hebden Bridge
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector42890001
    BENNETT, Phillip James
    Grove House Daw Lane
    Horbury
    WF4 5DR Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Grove House Daw Lane
    Horbury
    WF4 5DR Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director113393520001
    DUFFY, Francis Patrick
    33 Tithebarn Road
    L34 0EU Knowsley Village
    Merseyside
    Amministratore
    33 Tithebarn Road
    L34 0EU Knowsley Village
    Merseyside
    EnglandBritishDirector151944930001
    GARTLAND, Anthony
    Broad Carr House
    Broad Carr Lane
    HX4 9BS Holywell Green
    Halifax
    Amministratore
    Broad Carr House
    Broad Carr Lane
    HX4 9BS Holywell Green
    Halifax
    United KingdomBritishDirector27652170001
    HADLEY, David John
    76 Old High Street The Slade
    Headington
    OX3 7HW Oxford
    Amministratore
    76 Old High Street The Slade
    Headington
    OX3 7HW Oxford
    BritishDesign & Development Officer55574880002
    HEATHER, Brian Hersee
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector40164810001
    HEATHER, Brian Hersee
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    9 Gledhow Park Crescent
    Chapel Allerton
    LS7 4JY Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant40164810001
    HOYLE, Richard John
    Millstones Milner Lane
    Greetland
    HX4 8HP Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    Millstones Milner Lane
    Greetland
    HX4 8HP Halifax
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector43591930001
    IRWIN, John David
    Seeleys Orchard 39 Penn Road
    HP9 2LN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Seeleys Orchard 39 Penn Road
    HP9 2LN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director59361420001
    LAWSON, Ian Bruce
    15 Moorlands
    Westwood Drive
    LS29 9QZ Ilkley
    Yorkshire
    Amministratore
    15 Moorlands
    Westwood Drive
    LS29 9QZ Ilkley
    Yorkshire
    EnglandBritishDirector79170680001
    MCDOUGALL, Andrew
    The Old School
    School Lane
    NG13 9ES Whatton In The Vale
    Nottinghamshire
    Amministratore
    The Old School
    School Lane
    NG13 9ES Whatton In The Vale
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector154053860001
    MILLS, Lawrence Anthony
    15 Mayfield Drive
    Brayton
    YO8 9JZ Selby
    North Yorkshire
    Amministratore
    15 Mayfield Drive
    Brayton
    YO8 9JZ Selby
    North Yorkshire
    United KingdomBritishSales Director165378540001
    PENTLAND, Ian William
    Steadwell House
    Church End
    MK18 5NU Leckhampstead
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Steadwell House
    Church End
    MK18 5NU Leckhampstead
    Buckinghamshire
    BritishDirector33480180001
    ROE, David
    12 St George's Street
    PE9 2BJ Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    12 St George's Street
    PE9 2BJ Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritishDirector80567360002
    STANTON, Michael John
    16 Duxford Close
    B97 5BY Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    16 Duxford Close
    B97 5BY Redditch
    Worcestershire
    United KingdomBritishSales And Marketing Director114566620001
    WARD, Alan John
    6 Donegal Close
    Caversham
    RG4 5DT Reading
    Berkshire
    Amministratore
    6 Donegal Close
    Caversham
    RG4 5DT Reading
    Berkshire
    EnglandBritishDirector70124690001
    WHALLEY, Jeffrey
    Broncroft Castle
    Broncroft
    SY7 9HL Craven Arms
    Shropshire
    Amministratore
    Broncroft Castle
    Broncroft
    SY7 9HL Craven Arms
    Shropshire
    United KingdomBritishDirector1955430002
    WOODALL, Michael David
    Glovers Cottage Reigate Hill
    RH2 9PN Reigate
    Surrey
    Amministratore
    Glovers Cottage Reigate Hill
    RH2 9PN Reigate
    Surrey
    BritishDirector4777030001
    ZAVOS, Theodore
    Under Hill House Hundon Road
    Barnardiston
    CB9 7TJ Haverhill
    Suffolk
    Amministratore
    Under Hill House Hundon Road
    Barnardiston
    CB9 7TJ Haverhill
    Suffolk
    EnglandBritishDirector50583170001

    OFQUEST LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 30 apr 2008
    Consegnato il 14 mag 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Gartland Whalley & Barker Limited
    Transazioni
    • 14 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 06 mar 2007
    Consegnato il 09 mar 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gartland Whalley and Barker PLC
    Transazioni
    • 09 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 05 ago 2005
    Consegnato il 24 ago 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Gartland Whalley and Barker PLC
    Transazioni
    • 24 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Equitable mortgage of shares
    Creato il 04 dic 2000
    Consegnato il 14 dic 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in connection with the corporate guarantee
    Brevi particolari
    Shares in any relevant company and all dividends interest etc. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 14 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 04 dic 2000
    Consegnato il 09 dic 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 09 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 12 mag 2000
    Consegnato il 18 mag 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 07 apr 2000
    Consegnato il 08 apr 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 x new stefani edgebander s/no.AH1003262.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 08 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 12 giu 1998
    Consegnato il 16 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company and/or systems furniture limited and/or cooper & palmer limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 20 ott 1994
    Consegnato il 08 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 ott 1992
    Consegnato il 14 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Premises off eastview terrace, north street, langley mill, derbyshire t/no. DY228442.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 ott 1992
    Consegnato il 13 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 ref. M367C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 ott 1991
    Consegnato il 18 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Crossley House Holdings Limited
    Transazioni
    • 18 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 20 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    OFQUEST LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    12 gen 2009Inizio dell'amministrazione
    29 giu 2010Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Rob Sadler
    Begbies Traynor
    9th Floor
    LS1 2JZ Bond Court
    Leeds
    Praticante
    Begbies Traynor
    9th Floor
    LS1 2JZ Bond Court
    Leeds
    Robert Alexander Henry Maxwell
    Begbies Traynor
    9th Floor
    Bond Court
    Leeds Ls1 2jz
    Praticante
    Begbies Traynor
    9th Floor
    Bond Court
    Leeds Ls1 2jz
    2
    DataTipo
    29 giu 2010Inizio della liquidazione
    09 mar 2015Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Rob Sadler
    Begbies Traynor
    9th Floor
    LS1 2JZ Bond Court
    Leeds
    Praticante
    Begbies Traynor
    9th Floor
    LS1 2JZ Bond Court
    Leeds
    Robert Alexander Henry Maxwell
    9th Floor Bond Court
    LS1 2JZ Leeds
    Praticante
    9th Floor Bond Court
    LS1 2JZ Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0