OFQUEST LIMITED
Panoramica
Nome della società | OFQUEST LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02429501 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di OFQUEST LIMITED?
- (3614) /
Dove si trova OFQUEST LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Begbies Traynor 9th Floor Bond Court LS1 2JZ Leeds West Yorkshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di OFQUEST LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
DESKING SYSTEMS LIMITED | 17 ott 1991 | 17 ott 1991 |
WELLPAY LIMITED | 05 ott 1989 | 05 ott 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di OFQUEST LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 ott 2007 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per OFQUEST LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per OFQUEST LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori | 16 pagine | 4.72 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 giu 2014 | 21 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 giu 2014 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 dic 2013 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 giu 2013 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 dic 2012 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 giu 2012 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 dic 2011 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 lug 2013 | 18 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 giu 2012 | 17 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 giu 2011 | 5 pagine | 4.68 | ||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 18 giu 2010 | 16 pagine | 2.24B | ||
Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori | 16 pagine | 2.34B | ||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 11 gen 2010 | 14 pagine | 2.24B | ||
Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione | 1 pagine | 2.31B | ||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 11 lug 2009 | 11 pagine | 2.24B | ||
Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B | 12 pagine | 2.16B | ||
Risultato della riunione dei creditori | 33 pagine | 2.23B | ||
Dichiarazione della proposta dell'amministratore | 32 pagine | 2.17B | ||
legacy | 2 pagine | 288b | ||
Nomina di un amministratore | 1 pagine | 2.12B | ||
legacy | 1 pagine | 287 | ||
legacy | 1 pagine | 288b | ||
legacy | 2 pagine | 288a | ||
Chi sono gli amministratori di OFQUEST LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAYSHAW, Neil Andrew | Amministratore | 3 Finchley Lane OX6 8AE Bicester Oxfordshire | England | British | Operations Director | 59805060001 | ||||
OFQUEST DIRECTOR LIMITED | Amministratore | Irton House Warpsgrove Lane, Chalgrove OX44 7TH Oxford | 101569120002 | |||||||
BARKER, James Edward | Segretario | The Old Vicarage Cragg Vale HX7 5TB Hebden Bridge West Yorkshire | British | 42890001 | ||||||
BENNETT, Phillip James | Segretario | Grove House Daw Lane Horbury WF4 5DR Wakefield West Yorkshire | British | Company Director | 113393520001 | |||||
KING, Lorna | Segretario | Slade Road Stokenchurch HP14 3QH High Wycombe 34 Buckinghamshire | British | 130153660001 | ||||||
GWB SECRETARY LIMITED | Segretario | Crossley House Hopwood Lane HX1 5EB Halifax West Yorkshire | 83825250001 | |||||||
OFQUEST SECRETARY LIMITED | Segretario | Irton House Warpsgrove Lane, Chalgrove OX44 7TH Oxford | 86085190002 | |||||||
ALLEN, Christopher Taylor | Amministratore | 65 Seven Acres OX9 3JQ Thame Oxfordshire | British | Financial Director | 45256100001 | |||||
ATKIN, John Dudley | Amministratore | Manor Farm Marston St Lawrence OX17 2DA Banbury Oxfordshire | England | British | Finance Director | 47046270004 | ||||
BARKER, James Edward | Amministratore | The Old Vicarage Cragg Vale HX7 5TB Hebden Bridge West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 42890001 | ||||
BENNETT, Phillip James | Amministratore | Grove House Daw Lane Horbury WF4 5DR Wakefield West Yorkshire | England | British | Company Director | 113393520001 | ||||
DUFFY, Francis Patrick | Amministratore | 33 Tithebarn Road L34 0EU Knowsley Village Merseyside | England | British | Director | 151944930001 | ||||
GARTLAND, Anthony | Amministratore | Broad Carr House Broad Carr Lane HX4 9BS Holywell Green Halifax | United Kingdom | British | Director | 27652170001 | ||||
HADLEY, David John | Amministratore | 76 Old High Street The Slade Headington OX3 7HW Oxford | British | Design & Development Officer | 55574880002 | |||||
HEATHER, Brian Hersee | Amministratore | 9 Gledhow Park Crescent Chapel Allerton LS7 4JY Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 40164810001 | ||||
HEATHER, Brian Hersee | Amministratore | 9 Gledhow Park Crescent Chapel Allerton LS7 4JY Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Accountant | 40164810001 | ||||
HOYLE, Richard John | Amministratore | Millstones Milner Lane Greetland HX4 8HP Halifax West Yorkshire | England | British | Director | 43591930001 | ||||
IRWIN, John David | Amministratore | Seeleys Orchard 39 Penn Road HP9 2LN Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | Company Director | 59361420001 | ||||
LAWSON, Ian Bruce | Amministratore | 15 Moorlands Westwood Drive LS29 9QZ Ilkley Yorkshire | England | British | Director | 79170680001 | ||||
MCDOUGALL, Andrew | Amministratore | The Old School School Lane NG13 9ES Whatton In The Vale Nottinghamshire | England | British | Director | 154053860001 | ||||
MILLS, Lawrence Anthony | Amministratore | 15 Mayfield Drive Brayton YO8 9JZ Selby North Yorkshire | United Kingdom | British | Sales Director | 165378540001 | ||||
PENTLAND, Ian William | Amministratore | Steadwell House Church End MK18 5NU Leckhampstead Buckinghamshire | British | Director | 33480180001 | |||||
ROE, David | Amministratore | 12 St George's Street PE9 2BJ Stamford Lincolnshire | United Kingdom | British | Director | 80567360002 | ||||
STANTON, Michael John | Amministratore | 16 Duxford Close B97 5BY Redditch Worcestershire | United Kingdom | British | Sales And Marketing Director | 114566620001 | ||||
WARD, Alan John | Amministratore | 6 Donegal Close Caversham RG4 5DT Reading Berkshire | England | British | Director | 70124690001 | ||||
WHALLEY, Jeffrey | Amministratore | Broncroft Castle Broncroft SY7 9HL Craven Arms Shropshire | United Kingdom | British | Director | 1955430002 | ||||
WOODALL, Michael David | Amministratore | Glovers Cottage Reigate Hill RH2 9PN Reigate Surrey | British | Director | 4777030001 | |||||
ZAVOS, Theodore | Amministratore | Under Hill House Hundon Road Barnardiston CB9 7TJ Haverhill Suffolk | England | British | Director | 50583170001 |
OFQUEST LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and debenture | Creato il 30 apr 2008 Consegnato il 14 mag 2008 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari All property and assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creato il 06 mar 2007 Consegnato il 09 mar 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari All property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creato il 05 ago 2005 Consegnato il 24 ago 2005 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari All property and assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Equitable mortgage of shares | Creato il 04 dic 2000 Consegnato il 14 dic 2000 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in connection with the corporate guarantee | |
Brevi particolari Shares in any relevant company and all dividends interest etc. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 04 dic 2000 Consegnato il 09 dic 2000 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 12 mag 2000 Consegnato il 18 mag 2000 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattel mortgage | Creato il 07 apr 2000 Consegnato il 08 apr 2000 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 1 x new stefani edgebander s/no.AH1003262. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 12 giu 1998 Consegnato il 16 giu 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies and liabilities due or to become due from the company and/or systems furniture limited and/or cooper & palmer limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Single debenture | Creato il 20 ott 1994 Consegnato il 08 nov 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 02 ott 1992 Consegnato il 14 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Premises off eastview terrace, north street, langley mill, derbyshire t/no. DY228442. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 02 ott 1992 Consegnato il 13 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari See form 395 ref. M367C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 09 ott 1991 Consegnato il 18 ott 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
OFQUEST LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In amministrazione |
| ||||||||||||||||||||||
2 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0