CLAREMONT GARMENTS LIMITED

CLAREMONT GARMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCLAREMONT GARMENTS LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02429682
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di CLAREMONT GARMENTS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CLAREMONT GARMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Courtaulds Building
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CLAREMONT GARMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    J.R. TEXTILES LONDON (1989) LIMITED05 ott 198905 ott 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di CLAREMONT GARMENTS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 giu 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mar 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CLAREMONT GARMENTS LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al15 giu 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma29 giu 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al15 giu 2024
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per CLAREMONT GARMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Roger Ian Harry Broadberry come amministratore in data 08 mag 2024

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Roger Ian Harry Broadberry come segretario in data 08 mag 2024

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2023

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Roger Ian Harry Broadberry come amministratore in data 02 ago 2023

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Roger Ian Harry Broadberry come segretario in data 02 ago 2023

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Roger Ian Harry Broadberry come segretario in data 12 lug 2023

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Roger Ian Harry Broadberry come amministratore in data 12 lug 2023

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2022

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2021

    7 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017

    7 pagineAA

    Notifica di Claremont Garments (Holdings) Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Roger Ian Harry Broadberry come segretario in data 01 nov 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Huit Holdings (Uk) Limited come segretario in data 31 ott 2016

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di CLAREMONT GARMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HUIT HOLDINGS (UK) LIMITED
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione5785822
    136235800001
    BLAKE, John Martin
    1 Somerton Avenue
    TW9 4QP Richmond
    Surrey
    Segretario
    1 Somerton Avenue
    TW9 4QP Richmond
    Surrey
    British18972710001
    BROADBERRY, Roger Ian Harry
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    Segretario
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    312012930001
    BROADBERRY, Roger Ian Harry
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    Segretario
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    217565890001
    CATTERMOLE, Carolyn Tracy
    81 Cranbrook Road
    Chiswick
    W4 2LJ London
    Segretario
    81 Cranbrook Road
    Chiswick
    W4 2LJ London
    British53026290001
    CLARKE, Melanie Anne
    21 Bankside Close
    CV3 4GD Coventry
    West Midlands
    Segretario
    21 Bankside Close
    CV3 4GD Coventry
    West Midlands
    BritishChartered Secretary68681710001
    DRING, Susan Mary
    1 Ferens Close
    The Sands
    DH1 1JX Durham
    Co Durham
    Segretario
    1 Ferens Close
    The Sands
    DH1 1JX Durham
    Co Durham
    British27228120002
    JAGUN, Ayotola
    4e Bassett Road
    W10 6JJ London
    Segretario
    4e Bassett Road
    W10 6JJ London
    BritishChartered Secretary77729230001
    KELLY, Susan Kathleen
    43 Southview
    Clifton Road
    SW19 4QU London
    Segretario
    43 Southview
    Clifton Road
    SW19 4QU London
    BritishChartered Secretary71087960003
    RUBENSTEIN, Howard Justin
    10 Cyprus Avenue
    Finchley
    N3 1ST London
    Segretario
    10 Cyprus Avenue
    Finchley
    N3 1ST London
    BritishCompany Secretary And Legal Co66642870003
    RUSS, Neil Andrew
    Archdale House
    87 Wanlip Road
    LE7 1PB Syston
    Leicestershire
    Segretario
    Archdale House
    87 Wanlip Road
    LE7 1PB Syston
    Leicestershire
    BritishFinancial Controller118426120001
    WILSON, Julia Ruth
    5 Northwood Rise
    DE6 1BF Ashbourne
    Derbyshire
    Segretario
    5 Northwood Rise
    DE6 1BF Ashbourne
    Derbyshire
    BritishFinancial Controller73543180001
    HUIT HOLDINGS (UK) LIMITED
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione5785822
    136235800001
    BOBROFF, Anthony Pierre
    14 Batchworth Lane
    HA6 3AT Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    14 Batchworth Lane
    HA6 3AT Northwood
    Middlesex
    BritishDirector36168250001
    BROADBERRY, Roger Ian Harry
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    Amministratore
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    EnglandBritishGroup Financial Accountant126443750002
    BROADBERRY, Roger Ian Harry
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    Amministratore
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    EnglandBritishFinancial Accountant126443750002
    CATTERMOLE, Carolyn Tracy
    81 Cranbrook Road
    Chiswick
    W4 2LJ London
    Amministratore
    81 Cranbrook Road
    Chiswick
    W4 2LJ London
    BritishSolicitor53026290001
    CLARKE, Melanie Anne
    21 Bankside Close
    CV3 4GD Coventry
    West Midlands
    Amministratore
    21 Bankside Close
    CV3 4GD Coventry
    West Midlands
    BritishChartered Secretary68681710001
    DONNELLY, David John, Mr.
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    Amministratore
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    ScotlandBritishNone110847310002
    DRING, Susan Mary
    1 Ferens Close
    The Sands
    DH1 1JX Durham
    Co Durham
    Amministratore
    1 Ferens Close
    The Sands
    DH1 1JX Durham
    Co Durham
    BritishChartered Accountant27228120002
    DUFFY, Hugh Brian
    Highwood
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Highwood
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    BritishChief Executive91979290001
    ELLIS, Michael
    3 The Paddocks
    Peasehill
    DE5 3QR Ripley
    Derbyshire
    Amministratore
    3 The Paddocks
    Peasehill
    DE5 3QR Ripley
    Derbyshire
    United KingdomBritishFinance Director82849150002
    GILLIATT, John Mowbray
    9 Banbury Road
    CV37 7HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    9 Banbury Road
    CV37 7HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    ScotlandBritishChief Executive169894800001
    HAMILTON, Nicholas Ian
    South Hill House
    Smiths Lane, Ditcheat
    BA4 6PP Shepton Mallet
    Somerset
    Amministratore
    South Hill House
    Smiths Lane, Ditcheat
    BA4 6PP Shepton Mallet
    Somerset
    BritishChartered Accountant65558940001
    HANDLEY, Helen Kay
    6 Daniels Lane
    CR6 9ET Warlingham
    Surrey
    Amministratore
    6 Daniels Lane
    CR6 9ET Warlingham
    Surrey
    BritishSolicitor109816110001
    JAGUN, Ayotola
    4e Bassett Road
    W10 6JJ London
    Amministratore
    4e Bassett Road
    W10 6JJ London
    BritishChartered Secretary77729230001
    JENKINS, Stephen Adrian
    Mill Farm House Barkston Road
    Marston
    NG32 2HN Grantham
    Lincolnshire
    Amministratore
    Mill Farm House Barkston Road
    Marston
    NG32 2HN Grantham
    Lincolnshire
    BritishChartered Accountant49738660002
    KELLY, Susan Kathleen
    43 Southview
    Clifton Road
    SW19 4QU London
    Amministratore
    43 Southview
    Clifton Road
    SW19 4QU London
    EnglandBritishChartered Secretary71087960003
    LLEWELLYN, Stephen Michael
    Portman Close
    W1H 6BS London
    22-25
    England
    Amministratore
    Portman Close
    W1H 6BS London
    22-25
    England
    United KingdomBritishChief Executive Officer146726750001
    MASON, David
    4 Durham Road
    Sedgefield
    TS21 3DW Stockton On Tees
    Cleveland
    Amministratore
    4 Durham Road
    Sedgefield
    TS21 3DW Stockton On Tees
    Cleveland
    BritishManufacturing Director32996850002
    MCGARVEY, David
    3 Loudwater Ridge
    Loudwater
    WD3 4AR Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 Loudwater Ridge
    Loudwater
    WD3 4AR Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Director9220530004
    MCWILLIAMS, Michael Joseph
    Scotland Head House
    Winlaton
    NE21 6PL Blaydon
    Tyne And Wear
    Amministratore
    Scotland Head House
    Winlaton
    NE21 6PL Blaydon
    Tyne And Wear
    BritishAccountant38800080001
    MILLER, Graham Anthony
    Muddle Cottage
    Hare Lane Blindley Heath
    RH7 6JB Lingfield
    Surrey
    Amministratore
    Muddle Cottage
    Hare Lane Blindley Heath
    RH7 6JB Lingfield
    Surrey
    BritishCommercial Director32996900001
    PITSILLOS, Marios
    17 Meadowsweet Hill
    Bingham
    NG13 8TS Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    17 Meadowsweet Hill
    Bingham
    NG13 8TS Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishChartered Accountant64722090002
    POLEG, Eliaz
    20 Tedworth Square
    SW3 4DY London
    Amministratore
    20 Tedworth Square
    SW3 4DY London
    French And IsraeliCeo82549490001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CLAREMONT GARMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEngland
    Luogo di registrazioneUnited Kingdom
    Numero di registrazione00320013
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CLAREMONT GARMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 13 giu 1997
    Consegnato il 19 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that l/h property k/a or being land and buildings on the west side of highgate lane dearne t/no.SYK252843.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 giu 1997
    Consegnato il 19 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that l/h property k/a or being unit BT102/2B middlefields industrial estate south shields t/no.TY119450.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 giu 1997
    Consegnato il 19 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that l/h property k/a or being land and buildings on the north side of ennerdale road blyth t/no. ND44307.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 giu 1997
    Consegnato il 19 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that l/h property k/a or being land and buildings on the south west side of pilling street and land and buildings on the north west side of back st george's street t/nos.LA328872 and GM72049.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 giu 1997
    Consegnato il 19 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a or being land on the east side of north street t/no.SYK13091.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 giu 1997
    Consegnato il 19 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a or being land and buildings on the west side of eldon street south shields t/no. TY146999.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 giu 1997
    Consegnato il 19 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that the f/h property k/a or being 8 burdon drive peterlee t/no.DU202573.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 giu 1997
    Consegnato il 19 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a or being 3 cook way north west industrial estate peterlee county durham t/no. DU106547.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 giu 1997
    Consegnato il 19 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a or being land and buildings lying to the north east of durham road craghead stanley t/no.DU209454.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 giu 1997
    Consegnato il 19 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that l/h property k/a or being unit BT61/3 rekendyke industrial estate west walpole street south shields t/nos.TY153703 and TY164629.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 giu 1997
    Consegnato il 19 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a or being unit BT79/3 greenfields industrial estate west auckland t/no.DU205777.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 giu 1997
    Consegnato il 19 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that the f/h property k/a or being land and buildings on the south side of northfield way newton aycliffe t/no.DU110228.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 giu 1997
    Consegnato il 19 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that the f/h property k/a or being land and buildings on the east side of easington way peterlee t/no.DU98612.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 giu 1997
    Consegnato il 19 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 gen 1993
    Consegnato il 18 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Please see doc M476C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 07 gen 1993
    Consegnato il 19 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from claremont garments (holdings ) PLC to the chargee under the terms of a sterling guarantee facility letter dated 18TH june 1992
    Brevi particolari
    Please see doc M109L for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transazioni
    • 19 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 gen 1993
    Consegnato il 15 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Please see doc M265C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 06 lug 1992
    Acquisito il 07 gen 1993
    Consegnato il 26 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee and debenture and all other obligations of claremont garments (holdings) PLC under the terms of a sterling guarantee facility letter dated 18TH june 1992 secured on property acquired by claremont garments limited on the 7TH january 1993.
    Brevi particolari
    Please see doc M194C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transazioni
    • 26 gen 1993Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 01 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 lug 1991
    Acquisito il 07 gen 1993
    Consegnato il 26 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Please see doc M195C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 gen 1993Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 01 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 lug 1991
    Acquisito il 07 gen 1993
    Consegnato il 26 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Please see doc M196C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 gen 1993Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 01 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0