CLAREMONT GARMENTS LIMITED
Panoramica
Nome della società | CLAREMONT GARMENTS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02429682 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CLAREMONT GARMENTS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova CLAREMONT GARMENTS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | The Courtaulds Building 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CLAREMONT GARMENTS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
J.R. TEXTILES LONDON (1989) LIMITED | 05 ott 1989 | 05 ott 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CLAREMONT GARMENTS LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 30 giu 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 mar 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CLAREMONT GARMENTS LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 15 giu 2025 |
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 29 giu 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 15 giu 2024 |
Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per CLAREMONT GARMENTS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Roger Ian Harry Broadberry come amministratore in data 08 mag 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Roger Ian Harry Broadberry come segretario in data 08 mag 2024 | 1 pagine | TM02 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2023 | 7 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Roger Ian Harry Broadberry come amministratore in data 02 ago 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Roger Ian Harry Broadberry come segretario in data 02 ago 2023 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Roger Ian Harry Broadberry come segretario in data 12 lug 2023 | 1 pagine | TM02 | ||
Cessazione della carica di Roger Ian Harry Broadberry come amministratore in data 12 lug 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2022 | 7 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2021 | 7 pagine | AA | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019 | 7 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018 | 7 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017 | 7 pagine | AA | ||
Notifica di Claremont Garments (Holdings) Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016 | 7 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Roger Ian Harry Broadberry come segretario in data 01 nov 2016 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Huit Holdings (Uk) Limited come segretario in data 31 ott 2016 | 1 pagine | TM02 | ||
Chi sono gli amministratori di CLAREMONT GARMENTS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUIT HOLDINGS (UK) LIMITED | Amministratore | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building Nottinghamshire United Kingdom |
| 136235800001 | ||||||||||
BLAKE, John Martin | Segretario | 1 Somerton Avenue TW9 4QP Richmond Surrey | British | 18972710001 | ||||||||||
BROADBERRY, Roger Ian Harry | Segretario | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building England | 312012930001 | |||||||||||
BROADBERRY, Roger Ian Harry | Segretario | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building England | 217565890001 | |||||||||||
CATTERMOLE, Carolyn Tracy | Segretario | 81 Cranbrook Road Chiswick W4 2LJ London | British | 53026290001 | ||||||||||
CLARKE, Melanie Anne | Segretario | 21 Bankside Close CV3 4GD Coventry West Midlands | British | Chartered Secretary | 68681710001 | |||||||||
DRING, Susan Mary | Segretario | 1 Ferens Close The Sands DH1 1JX Durham Co Durham | British | 27228120002 | ||||||||||
JAGUN, Ayotola | Segretario | 4e Bassett Road W10 6JJ London | British | Chartered Secretary | 77729230001 | |||||||||
KELLY, Susan Kathleen | Segretario | 43 Southview Clifton Road SW19 4QU London | British | Chartered Secretary | 71087960003 | |||||||||
RUBENSTEIN, Howard Justin | Segretario | 10 Cyprus Avenue Finchley N3 1ST London | British | Company Secretary And Legal Co | 66642870003 | |||||||||
RUSS, Neil Andrew | Segretario | Archdale House 87 Wanlip Road LE7 1PB Syston Leicestershire | British | Financial Controller | 118426120001 | |||||||||
WILSON, Julia Ruth | Segretario | 5 Northwood Rise DE6 1BF Ashbourne Derbyshire | British | Financial Controller | 73543180001 | |||||||||
HUIT HOLDINGS (UK) LIMITED | Segretario | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building Nottinghamshire United Kingdom |
| 136235800001 | ||||||||||
BOBROFF, Anthony Pierre | Amministratore | 14 Batchworth Lane HA6 3AT Northwood Middlesex | British | Director | 36168250001 | |||||||||
BROADBERRY, Roger Ian Harry | Amministratore | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building England | England | British | Group Financial Accountant | 126443750002 | ||||||||
BROADBERRY, Roger Ian Harry | Amministratore | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building England | England | British | Financial Accountant | 126443750002 | ||||||||
CATTERMOLE, Carolyn Tracy | Amministratore | 81 Cranbrook Road Chiswick W4 2LJ London | British | Solicitor | 53026290001 | |||||||||
CLARKE, Melanie Anne | Amministratore | 21 Bankside Close CV3 4GD Coventry West Midlands | British | Chartered Secretary | 68681710001 | |||||||||
DONNELLY, David John, Mr. | Amministratore | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building England | Scotland | British | None | 110847310002 | ||||||||
DRING, Susan Mary | Amministratore | 1 Ferens Close The Sands DH1 1JX Durham Co Durham | British | Chartered Accountant | 27228120002 | |||||||||
DUFFY, Hugh Brian | Amministratore | Highwood Woodland Drive KT24 5AN East Horsley Surrey | British | Chief Executive | 91979290001 | |||||||||
ELLIS, Michael | Amministratore | 3 The Paddocks Peasehill DE5 3QR Ripley Derbyshire | United Kingdom | British | Finance Director | 82849150002 | ||||||||
GILLIATT, John Mowbray | Amministratore | 9 Banbury Road CV37 7HN Stratford Upon Avon Warwickshire | Scotland | British | Chief Executive | 169894800001 | ||||||||
HAMILTON, Nicholas Ian | Amministratore | South Hill House Smiths Lane, Ditcheat BA4 6PP Shepton Mallet Somerset | British | Chartered Accountant | 65558940001 | |||||||||
HANDLEY, Helen Kay | Amministratore | 6 Daniels Lane CR6 9ET Warlingham Surrey | British | Solicitor | 109816110001 | |||||||||
JAGUN, Ayotola | Amministratore | 4e Bassett Road W10 6JJ London | British | Chartered Secretary | 77729230001 | |||||||||
JENKINS, Stephen Adrian | Amministratore | Mill Farm House Barkston Road Marston NG32 2HN Grantham Lincolnshire | British | Chartered Accountant | 49738660002 | |||||||||
KELLY, Susan Kathleen | Amministratore | 43 Southview Clifton Road SW19 4QU London | England | British | Chartered Secretary | 71087960003 | ||||||||
LLEWELLYN, Stephen Michael | Amministratore | Portman Close W1H 6BS London 22-25 England | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 146726750001 | ||||||||
MASON, David | Amministratore | 4 Durham Road Sedgefield TS21 3DW Stockton On Tees Cleveland | British | Manufacturing Director | 32996850002 | |||||||||
MCGARVEY, David | Amministratore | 3 Loudwater Ridge Loudwater WD3 4AR Rickmansworth Hertfordshire | British | Company Director | 9220530004 | |||||||||
MCWILLIAMS, Michael Joseph | Amministratore | Scotland Head House Winlaton NE21 6PL Blaydon Tyne And Wear | British | Accountant | 38800080001 | |||||||||
MILLER, Graham Anthony | Amministratore | Muddle Cottage Hare Lane Blindley Heath RH7 6JB Lingfield Surrey | British | Commercial Director | 32996900001 | |||||||||
PITSILLOS, Marios | Amministratore | 17 Meadowsweet Hill Bingham NG13 8TS Nottingham Nottinghamshire | British | Chartered Accountant | 64722090002 | |||||||||
POLEG, Eliaz | Amministratore | 20 Tedworth Square SW3 4DY London | French And Israeli | Ceo | 82549490001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CLAREMONT GARMENTS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claremont Garments (Holdings) Limited | 06 apr 2016 | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building Nottinghamshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
CLAREMONT GARMENTS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creato il 13 giu 1997 Consegnato il 19 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that l/h property k/a or being land and buildings on the west side of highgate lane dearne t/no.SYK252843. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 13 giu 1997 Consegnato il 19 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that l/h property k/a or being unit BT102/2B middlefields industrial estate south shields t/no.TY119450. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 13 giu 1997 Consegnato il 19 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that l/h property k/a or being land and buildings on the north side of ennerdale road blyth t/no. ND44307. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 13 giu 1997 Consegnato il 19 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that l/h property k/a or being land and buildings on the south west side of pilling street and land and buildings on the north west side of back st george's street t/nos.LA328872 and GM72049. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 13 giu 1997 Consegnato il 19 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that f/h property k/a or being land on the east side of north street t/no.SYK13091. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 13 giu 1997 Consegnato il 19 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that f/h property k/a or being land and buildings on the west side of eldon street south shields t/no. TY146999. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 13 giu 1997 Consegnato il 19 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that the f/h property k/a or being 8 burdon drive peterlee t/no.DU202573. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 13 giu 1997 Consegnato il 19 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that f/h property k/a or being 3 cook way north west industrial estate peterlee county durham t/no. DU106547. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 13 giu 1997 Consegnato il 19 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that f/h property k/a or being land and buildings lying to the north east of durham road craghead stanley t/no.DU209454. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 13 giu 1997 Consegnato il 19 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that l/h property k/a or being unit BT61/3 rekendyke industrial estate west walpole street south shields t/nos.TY153703 and TY164629. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 13 giu 1997 Consegnato il 19 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that f/h property k/a or being unit BT79/3 greenfields industrial estate west auckland t/no.DU205777. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 13 giu 1997 Consegnato il 19 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that the f/h property k/a or being land and buildings on the south side of northfield way newton aycliffe t/no.DU110228. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 13 giu 1997 Consegnato il 19 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee for itself or as agent and trustee for n m rothschild & sons LTD and the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that the f/h property k/a or being land and buildings on the east side of easington way peterlee t/no.DU98612. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 13 giu 1997 Consegnato il 19 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 07 gen 1993 Consegnato il 18 gen 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Please see doc M476C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee and debenture | Creato il 07 gen 1993 Consegnato il 19 gen 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from claremont garments (holdings ) PLC to the chargee under the terms of a sterling guarantee facility letter dated 18TH june 1992 | |
Brevi particolari Please see doc M109L for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 07 gen 1993 Consegnato il 15 gen 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Please see doc M265C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 06 lug 1992 Acquisito il 07 gen 1993 Consegnato il 26 gen 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee and debenture and all other obligations of claremont garments (holdings) PLC under the terms of a sterling guarantee facility letter dated 18TH june 1992 secured on property acquired by claremont garments limited on the 7TH january 1993. | |
Brevi particolari Please see doc M194C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 22 lug 1991 Acquisito il 07 gen 1993 Consegnato il 26 gen 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Please see doc M195C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 22 lug 1991 Acquisito il 07 gen 1993 Consegnato il 26 gen 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Please see doc M196C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0