REG WINDPOWER LIMITED

REG WINDPOWER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREG WINDPOWER LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02431173
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di REG WINDPOWER LIMITED?

    • Produzione di energia elettrica (35110) / Fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata

    Dove si trova REG WINDPOWER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 3b, Damery Works Damery Lane
    Woodford
    GL13 9JR Berkeley
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di REG WINDPOWER LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE CORNWALL LIGHT & POWER CO LIMITED22 giu 201122 giu 2011
    REG WINDPOWER LIMITED13 giu 201113 giu 2011
    THE CORNWALL LIGHT & POWER CO. LIMITED10 ott 198910 ott 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di REG WINDPOWER LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 giu 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mar 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per REG WINDPOWER LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al31 mar 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma14 apr 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al31 mar 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per REG WINDPOWER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2023

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2022

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2021

    11 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2020

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2019

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 2nd Floor Edgeborough House Upper Edgeborough Road Guildford Surrey GU1 2BJ a Unit 3B, Damery Works Damery Lane Woodford Berkeley GL13 9JR in data 05 apr 2019

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2018

    19 pagineAA

    Stato del capitale al 05 feb 2019

    • Capitale: GBP 1,000.00
    3 pagineSH19

    legacy

    12 pagineSH20

    legacy

    12 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of the share premium account and cancellation of the redemption reserve account 31/01/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Rachel Jayne Partridge come amministratore in data 31 gen 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mina Booth come amministratore in data 31 gen 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Katey Louise Korzenietz come amministratore in data 31 gen 2019

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Katey Louise Korzenietz il 01 apr 2018

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2017

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2016

    25 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di REG WINDPOWER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CROCKFORD, Zoe Catherine
    Damery Lane
    Woodford
    GL13 9JR Berkeley
    Unit 3b, Damery Works
    England
    Segretario
    Damery Lane
    Woodford
    GL13 9JR Berkeley
    Unit 3b, Damery Works
    England
    207498860001
    BOOTH, Stephen
    Damery Lane
    Woodford
    GL13 9JR Berkeley
    Unit 3b, Damery Works
    England
    Amministratore
    Damery Lane
    Woodford
    GL13 9JR Berkeley
    Unit 3b, Damery Works
    England
    United KingdomBritishDirector184176760002
    COLLINS, Ian Kenneth
    Edgeborough House
    Upper Edgeborough Road
    GU1 2BJ Guildford
    2nd Floor
    Surrey
    England
    Amministratore
    Edgeborough House
    Upper Edgeborough Road
    GU1 2BJ Guildford
    2nd Floor
    Surrey
    England
    EnglandBritishDirector102013910001
    CROCKFORD, David Edward
    6 Paddock Road
    GU4 7LL Guildford
    Surrey
    Amministratore
    6 Paddock Road
    GU4 7LL Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant125163140001
    PARTRIDGE, Matthew Richard
    Damery Lane
    Woodford
    GL13 9JR Berkeley
    Unit 3b, Damery Works
    England
    Amministratore
    Damery Lane
    Woodford
    GL13 9JR Berkeley
    Unit 3b, Damery Works
    England
    United KingdomBritishDevelopment Director123666400001
    WANNOP, Simon Thomas
    Grange Close
    Lympstone
    EX8 5LD Exmouth
    8
    Devon
    England
    Amministratore
    Grange Close
    Lympstone
    EX8 5LD Exmouth
    8
    Devon
    England
    Unitied KingdomBritishCorporate Finance182521950001
    WHALLEY, Andrew Nicholas
    Damery Lane
    Woodford
    GL13 9JR Berkeley
    Unit 3b, Damery Works
    England
    Amministratore
    Damery Lane
    Woodford
    GL13 9JR Berkeley
    Unit 3b, Damery Works
    England
    United KingdomBritishCompany Director43664020007
    BAILEY, Peter John
    Chymder
    Cury
    TR12 7BP Helston
    Cornwall
    Segretario
    Chymder
    Cury
    TR12 7BP Helston
    Cornwall
    British9636570001
    BURTON, Craig Thomas
    1 Folly Lane South
    GU9 0BZ Farnham
    Surrey
    Segretario
    1 Folly Lane South
    GU9 0BZ Farnham
    Surrey
    BritishAccountant119693220001
    CROCKFORD, David Edward
    6 Paddock Road
    GU4 7LL Guildford
    Surrey
    Segretario
    6 Paddock Road
    GU4 7LL Guildford
    Surrey
    BritishAccountant125163140001
    LYLE, Teresa Ruth, The Hon Mrs
    The Old Manse
    OX11 9DD Aston Tirrold
    Oxfordshire
    Segretario
    The Old Manse
    OX11 9DD Aston Tirrold
    Oxfordshire
    British31336560003
    MACPHERSON, Neil
    15 Heather Close
    Finchampstead
    RG40 4PX Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    15 Heather Close
    Finchampstead
    RG40 4PX Wokingham
    Berkshire
    BritishCompany Director13681820002
    TREZONA PHILLIPS, Sally Elizabeth
    Chaslume
    Killivose Road
    TR14 7RN Camborne
    Cornwall
    Segretario
    Chaslume
    Killivose Road
    TR14 7RN Camborne
    Cornwall
    British2425480002
    BOOTH, Mina
    Edgeborough House
    Upper Edgeborough Road
    GU1 2BJ Guildford
    2nd Floor
    Surrey
    Amministratore
    Edgeborough House
    Upper Edgeborough Road
    GU1 2BJ Guildford
    2nd Floor
    Surrey
    EnglandBritishDirector207499230001
    BURTON, Craig Thomas
    1 Folly Lane South
    GU9 0BZ Farnham
    Surrey
    Amministratore
    1 Folly Lane South
    GU9 0BZ Farnham
    Surrey
    BritishAccountant119693220001
    EDWARDS, Peter Dixon
    Deli
    PL33 9BZ Delabole
    N Cornwall
    Amministratore
    Deli
    PL33 9BZ Delabole
    N Cornwall
    United KingdomBritishFarmer6723810001
    HARRIS, Neil Tracey
    Levalsa
    Meor Farm London Apprentice
    PL26 6DW St Austell
    Cornwall
    Amministratore
    Levalsa
    Meor Farm London Apprentice
    PL26 6DW St Austell
    Cornwall
    United KingdomBritishCompany Director42584490002
    KORZENIETZ, Katey Louise
    Edgeborough House
    Upper Edgeborough Road
    GU1 2BJ Guildford
    2nd Floor
    Surrey
    Amministratore
    Edgeborough House
    Upper Edgeborough Road
    GU1 2BJ Guildford
    2nd Floor
    Surrey
    United KingdomBritishDirector207500210002
    LYLE, Robert Arthur Wyatt
    The Old Manse
    OX11 9DD Aston Tirrold
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Old Manse
    OX11 9DD Aston Tirrold
    Oxfordshire
    British2180210004
    LYLE, Teresa Ruth, The Hon Mrs
    The Old Manse
    OX11 9DD Aston Tirrold
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Old Manse
    OX11 9DD Aston Tirrold
    Oxfordshire
    BritishSolicitor31336560003
    MACPHERSON, Neil
    15 Heather Close
    Finchampstead
    RG40 4PX Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    15 Heather Close
    Finchampstead
    RG40 4PX Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director13681820002
    MCMANUS, Nigel
    4 South View
    OX10 0HJ Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    4 South View
    OX10 0HJ Wallingford
    Oxfordshire
    BritishChief Operating Officer117267240001
    PARTRIDGE, Rachel Jayne
    Edgeborough House
    Upper Edgeborough Road
    GU1 2BJ Guildford
    2nd Floor
    Surrey
    Amministratore
    Edgeborough House
    Upper Edgeborough Road
    GU1 2BJ Guildford
    2nd Floor
    Surrey
    United KingdomBritishDirector147420160001
    WOODMAN, Bruce Vaughan
    Geal Cottage Tresowes Hill
    Ashton
    TR13 9TB Helston
    Cornwall
    Amministratore
    Geal Cottage Tresowes Hill
    Ashton
    TR13 9TB Helston
    Cornwall
    EnglandBritishCompany Director23015000002
    LORD WYATT OF WEEFORD
    19 Cavendish Avenue
    St John's Wood
    NW8 9JD London
    Amministratore
    19 Cavendish Avenue
    St John's Wood
    NW8 9JD London
    4413590001

    Chi sono le persone con controllo significativo di REG WINDPOWER LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Reg Holdings Limited
    Upper Edgeborough Road
    GU1 2BJ Guildford
    Reg Holdings Limited, 2nd Floor, Edgeborough House
    England
    06 apr 2016
    Upper Edgeborough Road
    GU1 2BJ Guildford
    Reg Holdings Limited, 2nd Floor, Edgeborough House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione2766574
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    REG WINDPOWER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 24 giu 2014
    Consegnato il 04 lug 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The company:. 1) assigns absolutely and charges by way of first fixed charge to the security agent all its rights, title and interest in the following assets: (I) the charged contracts; and (ii) the contract proceeds;. 2) charges by way of first fixed charge the following assets: (I) the charged contracts; and (ii) the contract proceeds; and also (iii) any monies payable to the company for or in connection with the disposal of the charged contracts or any interest in the charged contracts.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V. as Security Agent
    Transazioni
    • 04 lug 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 13 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 giu 2014
    Consegnato il 04 lug 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The company:. 1) assigns absolutely and charges by way of first fixed charge to the security agent all its rights, title and interest in the following assets: (I) the charged contracts; and (ii) the contract proceeds;. 2) charges by way of first fixed charge the following assets: (I) the charged contracts; and (ii) the contract proceeds; and also (iii) any monies payable to the company for or in connection with the disposal of the charged contracts or any interest in the charged contracts.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V. as Security Agent
    Transazioni
    • 04 lug 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 13 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 11 ott 2010
    Consegnato il 20 ott 2010
    In corso
    Importo garantito
    £9,546.88 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the tenant's interest in the deposit see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Andrew Douglas Brownsword
    Transazioni
    • 20 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Rent deposit deed
    Creato il 09 feb 2010
    Consegnato il 12 feb 2010
    In corso
    Importo garantito
    £4,259.38 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Interest in the deposit as security for the payment of rents see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Andrew Brownsword
    Transazioni
    • 12 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Account security
    Creato il 15 set 2008
    Consegnato il 18 set 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The accounts and all sums see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties (Security Trustee)
    Transazioni
    • 18 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 06 giu 2008
    Consegnato il 17 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of £17,500 plus interest.
    Persone aventi diritto
    • William Ian Murdoch
    Transazioni
    • 17 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 16 ott 2007
    Consegnato il 24 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any chargor to the secured parties on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 24 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 28 lug 1998
    Consegnato il 05 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All sums payable by waterpower and renewable energy limited under a power purchase agreement dated 28 july 1998.
    Persone aventi diritto
    • Wasserkraft Und Regenerative Energieentwicklung Ag
    Transazioni
    • 05 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 14 dic 1992
    Consegnato il 30 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land and property at goonhilly downs, cury helston, cornwall. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • County Natwest Limited
    Transazioni
    • 30 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of coutts account
    Creato il 14 dic 1992
    Consegnato il 23 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility letters the assignment and the mortgage debenture
    Brevi particolari
    The interst bearing deposit account no.01087169 (Reserve account) in the current account number 10871501.
    Persone aventi diritto
    • County Natwest Limited
    Transazioni
    • 23 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over power purchase agreement
    Creato il 14 dic 1992
    Consegnato il 23 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility letters the charge and the mortgage debenture
    Brevi particolari
    All sums payable by the non fossil purchasing agency limited to the company under the power purchase agreement.
    Persone aventi diritto
    • County Natwest Limited
    Transazioni
    • 23 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over deposit account
    Creato il 14 dic 1992
    Consegnato il 23 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility letters and/or the charge and/or the mortgage debenture
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in the interest bearing deposit account numbered 66620501 with the bank.
    Persone aventi diritto
    • County Natwest Limited
    Transazioni
    • 23 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over consultants contract
    Creato il 14 dic 1992
    Consegnato il 23 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility letters the charge and the mortgage debenture
    Brevi particolari
    All the benefit of the agreement dated 14.12.92 (the consultants contract).
    Persone aventi diritto
    • County Natwest Limited
    Transazioni
    • 23 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over vestas contract and warranty and maintenance agreement
    Creato il 14 dic 1992
    Consegnato il 23 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under facility letters the charge and the mortgage debenture
    Brevi particolari
    All the benefit of the wind farm purchase contract agreement dated 09.11.92 and the wind turbine generator warranty and maintenance agreement dated 14.12.92.
    Persone aventi diritto
    • County Natwest Limited
    Transazioni
    • 23 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of performance bond and warranty guarantee
    Creato il 14 dic 1992
    Consegnato il 23 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility letters and/or the assignment and/or the mortgage debenture
    Brevi particolari
    All of the companys right title and interest in a performance bond dated 14.12.92.
    Persone aventi diritto
    • County Natwest Limited
    Transazioni
    • 23 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over engineers contract
    Creato il 14 dic 1992
    Consegnato il 23 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility letters and/or the charge and/or the mortgage debenture
    Brevi particolari
    All the benefit of the agreement dated 14.12.92 (the engineers contract).
    Persone aventi diritto
    • County Natwest Limited
    Transazioni
    • 23 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0