MORTIMER SPINKS LIMITED

MORTIMER SPINKS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMORTIMER SPINKS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02432139
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MORTIMER SPINKS LIMITED?

    • Attività di consulenza in tecnologie dell'informazione (62020) / Informazione e comunicazione
    • Attività delle agenzie di lavoro interinale (78200) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova MORTIMER SPINKS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    110 Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MORTIMER SPINKS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TAGPASS LIMITED13 ott 198913 ott 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di MORTIMER SPINKS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per MORTIMER SPINKS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mark Jonathan Garratt come amministratore in data 27 apr 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mark Jonathan Garratt come segretario in data 27 apr 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jonathan Richard Ashcroft come amministratore in data 27 apr 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jonathan Richard Ashcroft come segretario in data 27 apr 2017

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2016

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 giu 2016

    Stato del capitale al 27 giu 2016

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 gen 2015

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 ott 2015

    Stato del capitale al 13 ott 2015

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 gen 2014

    17 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Harvey Nash Heron Tower 110 Bishopsgate London England and Wales EC2N 4AY a 110 Bishopsgate London EC2N 4AY in data 22 set 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 06 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 set 2014

    Stato del capitale al 22 set 2014

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 06 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 ott 2013

    Stato del capitale al 10 ott 2013

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 gen 2013

    16 pagineAA

    legacy

    10 pagineMG01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Resolution effect notwithstanding provisions company articles 05/02/2013
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Resolution effect notwithstanding any provisions of company articles 05/02/2013
    RES13

    Chi sono gli amministratori di MORTIMER SPINKS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GARRATT, Mark Jonathan
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    Segretario
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    231362280001
    ELLIS, Albert George Hector
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish49452080003
    GARRATT, Mark Jonathan
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    EnglandBritish229682100001
    WASSALL, Simon Mark
    Highview
    18 Pebworth Drive
    CV35 7UD Hatton Park
    Warwickshire
    Amministratore
    Highview
    18 Pebworth Drive
    CV35 7UD Hatton Park
    Warwickshire
    EnglandBritish108449780001
    ASHCROFT, Jonathan Richard, Mr.
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Segretario
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    British258414370001
    ELLIS, Albert George Hector
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Segretario
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British49452080003
    ELLIS, Albert George Hector
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Segretario
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British49452080003
    FURNISS, Ian William
    Greensands
    Promrose Way Bramley
    GU5 0BZ Guildford
    Surrey
    Segretario
    Greensands
    Promrose Way Bramley
    GU5 0BZ Guildford
    Surrey
    British81663830001
    HANTON, Karen Anne
    11 Warwick Square Mews
    SW1V 2EL London
    Segretario
    11 Warwick Square Mews
    SW1V 2EL London
    British318330001
    NORTHEY, David
    187 Croxted Road
    West Dulwich
    SE21 8NL London
    Segretario
    187 Croxted Road
    West Dulwich
    SE21 8NL London
    British46276820002
    HARFORD NOMINEES LIMITED
    Harford House
    101-103 Great Portland Street
    W1N 6BH London
    Segretario
    Harford House
    101-103 Great Portland Street
    W1N 6BH London
    2134810001
    ASHCROFT, Jonathan Richard, Mr.
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish258414370001
    CRAWFORD, Thomas Francis Alexander
    1 Durrell Road
    Fulham
    SW6 5LQ London
    Amministratore
    1 Durrell Road
    Fulham
    SW6 5LQ London
    United KingdomBritish3856480002
    ELLIS, Albert George Hector
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish49452080003
    FURNISS, Ian William
    Greensands
    Promrose Way Bramley
    GU5 0BZ Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Greensands
    Promrose Way Bramley
    GU5 0BZ Guildford
    Surrey
    British81663830001
    HANTON, Karen Anne
    12 Crown Reach
    145 Grosvenor Road
    SW1V 3JU London
    Amministratore
    12 Crown Reach
    145 Grosvenor Road
    SW1V 3JU London
    British318330003
    HIGGINS, David Charles
    40 Bradbourne Street
    Fulham
    SW6 3TE London
    Amministratore
    40 Bradbourne Street
    Fulham
    SW6 3TE London
    United KingdomBritish33333910003
    NORTHEY, David
    128 Farnaby Road
    BR1 4BH Bromley
    Surrey
    Amministratore
    128 Farnaby Road
    BR1 4BH Bromley
    Surrey
    British46276820003
    SINGER, David Ivan
    11 Kings Drive
    HA8 8EB Edgware
    Middlesex
    Amministratore
    11 Kings Drive
    HA8 8EB Edgware
    Middlesex
    United KingdomBritish38583380003
    TREACHER, David Hedley
    Suite Goft House
    Byworth
    GU28 0HW Petworth
    West Sussex
    Amministratore
    Suite Goft House
    Byworth
    GU28 0HW Petworth
    West Sussex
    EnglandBritish80479660001

    MORTIMER SPINKS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 12 feb 2013
    Consegnato il 21 feb 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 21 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 03 mag 2005
    Consegnato il 17 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 17 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed charge by client on purchased debts which fail to vest and other debts and floating charge on banked proceeds of other debts
    Creato il 14 nov 2001
    Consegnato il 27 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the agreement (as defined in the charge) for the purchase of debts (as defined in the agreement) or otherwise
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge over any debt with its related rights purchased by the security holder pursuant to the agreement which fails to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason and any proceeds thereof; all indebtedness now or at any time owing or becoming due to the company on any account whatsoever with related rights thereto other than the purchased debts and floating charge over all monies which the company may receive in respect of other debts.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 27 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 08 set 1997
    Consegnato il 24 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 29 giu 1995
    Consegnato il 07 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 16 feb 1994
    Consegnato il 18 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Brevi particolari
    The sum of £5,000 deposited.
    Persone aventi diritto
    • Stoll Moss Theatres Limited
    Transazioni
    • 18 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 17 giu 1993
    Consegnato il 25 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0