COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED

COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02435766
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) PLC24 ott 198924 ott 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    24 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da One Kingdom Street Paddington London W2 6BL in data 08 giu 2011

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 26 mag 2011

    LRESSP

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2010

    5 pagineAA

    Stato del capitale al 14 feb 2011

    • Capitale: GBP 840.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    £33400000 cancelled from share prem a/c 04/02/2011
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Thomas Edward Timothy Homer come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di James Cheesewright come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Nicholas Brian Farrimond come amministratore

    6 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Ham come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Misys Corporate Secretary Limited come segretario

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Gurbinder Bains come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2009

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    Segretario
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione07036299
    149985420001
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish75357260001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Maidenhead Road
    Cookham
    SL6 9DF Berkshire
    Rosedale
    United Kingdom
    Amministratore
    Maidenhead Road
    Cookham
    SL6 9DF Berkshire
    Rosedale
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    1
    Amministratore
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    1
    82836510002
    BAINS, Gurbinder
    Kingston Road
    UB2 4AP Southall
    36
    Middlesex
    United Kingdom
    Segretario
    Kingston Road
    UB2 4AP Southall
    36
    Middlesex
    United Kingdom
    Other138753780001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Segretario
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Segretario
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Segretario
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    JACOBS, Trevor Arthur
    23 Crowson Way
    Deeping St James
    PE6 8EY Peterborough
    Cambridgeshire
    Segretario
    23 Crowson Way
    Deeping St James
    PE6 8EY Peterborough
    Cambridgeshire
    British5724050001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Segretario
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Segretario
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    BEAUMONT, Frederick Peter
    The Homestead
    The Playing Close Browns Lane
    OX7 3QP Chalbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Homestead
    The Playing Close Browns Lane
    OX7 3QP Chalbury
    Oxfordshire
    British17370420001
    CHEESEWRIGHT, James
    Horton Meadow
    Heyshott
    GU29 0DL Midhurst
    West Sussex
    Amministratore
    Horton Meadow
    Heyshott
    GU29 0DL Midhurst
    West Sussex
    United KingdomBritish80646020001
    COOK, John
    Barnside
    GL20 7BP Tredington
    Gloucestershire
    Amministratore
    Barnside
    GL20 7BP Tredington
    Gloucestershire
    EnglandBritish86208160001
    COPELAND, Philip Robert
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish44954570001
    DAVIS, James Michael
    22 Meadow Road
    Market Deeping
    PE6 8PF Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    22 Meadow Road
    Market Deeping
    PE6 8PF Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritish17589470001
    EVANS, Howard
    Charlton Park House
    Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Charlton Park House
    Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish56986700002
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Amministratore
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Amministratore
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Amministratore
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    JACOBS, Trevor Arthur
    12 Woodcroft Close
    PE6 8BT Market Deeping
    Lincs
    Amministratore
    12 Woodcroft Close
    PE6 8BT Market Deeping
    Lincs
    British5724050002
    KING, Gary James
    The Coppice Brockhill Road
    WR14 4DL West Malvern
    Worcestershire
    Amministratore
    The Coppice Brockhill Road
    WR14 4DL West Malvern
    Worcestershire
    British5724060004
    LOMAX, John Kevin
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    British22190280002
    MCMAHON, Jasper Philip
    Ground Floor Flat
    33 Warrington Crescent
    W9 1EJ London
    Amministratore
    Ground Floor Flat
    33 Warrington Crescent
    W9 1EJ London
    EnglandBritish45080250003
    MORGAN, Glyn Howell
    2a College Road
    WR14 3DD Malvern
    Worcestershire
    Amministratore
    2a College Road
    WR14 3DD Malvern
    Worcestershire
    British10282920001
    MORGAN, Roger Hugh
    The Gables Grit Lane
    Leigh Sinton
    WR14 1UR Malvern
    Worcestershire
    Amministratore
    The Gables Grit Lane
    Leigh Sinton
    WR14 1UR Malvern
    Worcestershire
    British17001000001
    O'LEARY, Michael Kevin
    Greenwood
    Wichenford
    WR6 6YB Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Greenwood
    Wichenford
    WR6 6YB Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish129193560001
    SHAW, John Malcolm
    Willow Gate
    Southorpe
    PE9 3BX Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    Willow Gate
    Southorpe
    PE9 3BX Stamford
    Lincolnshire
    EnglandBritish12536610001
    SUSSENS, John Gilbert
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish1442450002
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001

    COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    Creato il 19 dic 2006
    Consegnato il 29 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Creato il 17 set 2003
    Consegnato il 01 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Creato il 11 set 2003
    Consegnato il 24 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Creato il 29 lug 2003
    Consegnato il 12 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    Creato il 23 ott 2002
    Consegnato il 13 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995
    Creato il 09 mag 2002
    Consegnato il 25 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 mag 2012Data di scioglimento
    26 mag 2011Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    William Antony Batty
    Antony Batty & Co
    Third Floor
    WC1R 5EF 3 Field Court
    Gray'S Inn London
    Praticante
    Antony Batty & Co
    Third Floor
    WC1R 5EF 3 Field Court
    Gray'S Inn London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0