MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED

MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02436108
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8th Floor One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    METAPATH SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED15 dic 199815 dic 1998
    MOBILE SYSTEMS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY04 ago 199204 ago 1992
    MOBILE SYSTEMS UK LIMITED25 ott 198925 ott 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    19 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 01 mar 2023

    17 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Point 3 Haywood Road Warwick CV34 5AH a 8th Floor One Temple Row Birmingham B2 5LG in data 11 mar 2022

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 02 mar 2022

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Stato del capitale al 04 nov 2021

    • Capitale: GBP 0.025
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account; cancellation of capital redemption reserve 02/11/2021
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 mar 2021

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mrs Heather Marie Green come amministratore in data 18 feb 2021

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 mar 2020

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2019

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2018

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2017

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 apr 2016

    Stato del capitale al 29 apr 2016

    • Capitale: GBP 40,000,000
    SH01

    Cessazione della carica di Craig George Donaldson come segretario in data 31 mar 2016

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GREEN, Heather Marie
    One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    8th Floor
    Amministratore
    One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    8th Floor
    EnglandBritish106936580002
    WEBBERLEY, Mark Andrew
    One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    8th Floor
    Amministratore
    One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    8th Floor
    EnglandBritish162019130001
    BRITTON, Jeanette Eden
    32 Chestnut Avenue
    KT10 8JF Esher
    Surrey
    Segretario
    32 Chestnut Avenue
    KT10 8JF Esher
    Surrey
    British33976690001
    CARPENTER, Peter Jon
    3a King Edward Mansions
    No 8 Grape Street
    WC2H 8DY London
    Segretario
    3a King Edward Mansions
    No 8 Grape Street
    WC2H 8DY London
    British37632220001
    DONALDSON, Craig George
    Haywood Road
    CV34 5AH Warwick
    Point 3
    Segretario
    Haywood Road
    CV34 5AH Warwick
    Point 3
    British79026210001
    FADL, Hania, Dr
    15 Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PG London
    Segretario
    15 Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PG London
    British7644540001
    LONG, Jacqueline
    361 Hanworth Road
    TW12 3EJ Hampton
    Middlesex
    Segretario
    361 Hanworth Road
    TW12 3EJ Hampton
    Middlesex
    British77617710001
    MEADES, Derek Leslie
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    Segretario
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    British8142960002
    SKELLY, Mary Angela
    44 Hartswood Road
    Stamford Brook
    W12 9NF London
    Segretario
    44 Hartswood Road
    Stamford Brook
    W12 9NF London
    British83455820001
    SMITH, Julian Matthew
    36 Ferndene Road
    Herne Hill
    SE24 0AB London
    Segretario
    36 Ferndene Road
    Herne Hill
    SE24 0AB London
    British110194190001
    ANDREEN, Marcus
    Flat 3 39 Matheson Road
    W14 8SN London
    Amministratore
    Flat 3 39 Matheson Road
    W14 8SN London
    Swedish44488170001
    BAJWA, Anwar Sharif, Dr
    7 Lavenda Close
    Hempstead
    ME7 3TB Gillingham
    Kent
    Amministratore
    7 Lavenda Close
    Hempstead
    ME7 3TB Gillingham
    Kent
    United KingdomBritish32990830001
    BUTLER, Thomas Michael
    13 West Heath Road
    Hampstead
    NW3 7UU London
    Amministratore
    13 West Heath Road
    Hampstead
    NW3 7UU London
    British24904420001
    CARPENTER, Peter Jon
    3a King Edward Mansions
    No 8 Grape Street
    WC2H 8DY London
    Amministratore
    3a King Edward Mansions
    No 8 Grape Street
    WC2H 8DY London
    British37632220001
    CARRINGTON, John Christopher
    1 Anchor Brewhouse
    50 Shad Thames
    SE1 2LY London
    Amministratore
    1 Anchor Brewhouse
    50 Shad Thames
    SE1 2LY London
    United KingdomBritish79087670001
    COPELAND, James
    4808 Prestwick Drive
    Colleyville Texas
    76034
    United States
    Amministratore
    4808 Prestwick Drive
    Colleyville Texas
    76034
    United States
    United States Citizen94697790001
    DAIN, Mark St.John
    316 Shobnall Road
    DE14 2BG Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    316 Shobnall Road
    DE14 2BG Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish159246160001
    DAYA, Moez Rajabali Rahemtulla
    6 Christchurch Road
    CR8 2BY Purley
    Surrey
    Amministratore
    6 Christchurch Road
    CR8 2BY Purley
    Surrey
    Kenya7644560001
    DONALDSON, Craig George
    Haywood Road
    CV34 5AH Warwick
    Point 3
    Amministratore
    Haywood Road
    CV34 5AH Warwick
    Point 3
    United KingdomBritish79026210001
    HANKINS, Kevin
    485 The Hermitage Drive
    FOREIGN Alpharetta
    30004 Georgia
    Us
    Amministratore
    485 The Hermitage Drive
    FOREIGN Alpharetta
    30004 Georgia
    Us
    United States Citizen105639200001
    HARDYMON, Gene Felda
    22 Newton Street
    02193 Weston
    Massachusetts
    Usa
    Amministratore
    22 Newton Street
    02193 Weston
    Massachusetts
    Usa
    American62278260001
    HARRIS, Paul
    29 Eastfields Road
    CR4 2LS Mitcham
    Surrey
    Amministratore
    29 Eastfields Road
    CR4 2LS Mitcham
    Surrey
    British68547980001
    HOLT, Martin Alan
    13 Heath Rise
    NN8 5QN Wellingborough
    Amministratore
    13 Heath Rise
    NN8 5QN Wellingborough
    British81023100001
    IBRAHIM, Mohamed Fathi Ahmed, Doctor
    20 Park Street
    W1K 2JA London
    Amministratore
    20 Park Street
    W1K 2JA London
    British72245030003
    JULIN, Sven Tomas
    Magnebergsvagen 51
    12134 Enskededalen
    Stockholm
    Sweden
    Amministratore
    Magnebergsvagen 51
    12134 Enskededalen
    Stockholm
    Sweden
    Swedish47715430001
    KERN, Rene M
    151 East 92nd Street
    10128 New York
    New York
    Usa
    Amministratore
    151 East 92nd Street
    10128 New York
    New York
    Usa
    German71085180001
    LONG, Jacqueline
    361 Hanworth Road
    TW12 3EJ Hampton
    Middlesex
    Amministratore
    361 Hanworth Road
    TW12 3EJ Hampton
    Middlesex
    British77617710001
    MACGOWAN, Iain Angus William
    Flat2
    22 Saltoun Road
    SW2 1EP London
    Amministratore
    Flat2
    22 Saltoun Road
    SW2 1EP London
    British68985510001
    MEADES, Derek Leslie
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    British8142960002
    MEYER, John Joseph
    3745 Sterling Road
    Downes Grove
    60515 Illinois
    U.S.A
    Amministratore
    3745 Sterling Road
    Downes Grove
    60515 Illinois
    U.S.A
    American34273260001
    PORTER, Norman Charles
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish445360034
    REDDY, Sreenivasula Dhanireddy
    Ino 40 Coventry Drive
    60188 Wheaton
    Illinois
    Usa
    Amministratore
    Ino 40 Coventry Drive
    60188 Wheaton
    Illinois
    Usa
    Indian50894490001
    RHODES, Terence
    12 Dartmouth Row
    Greenwich
    SE10 8AN London
    Amministratore
    12 Dartmouth Row
    Greenwich
    SE10 8AN London
    British72245020001
    ROBINSON, Colin Lloyd
    3717 Atrium Dr
    FOREIGN Plano Tx 75075 Usa
    U S A
    Amministratore
    3717 Atrium Dr
    FOREIGN Plano Tx 75075 Usa
    U S A
    Usa41651480001
    SCHICKLING, John Joseph
    Crawford Lodge Orchehill Avenue
    SL9 8QF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Crawford Lodge Orchehill Avenue
    SL9 8QF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    75042900002

    Chi sono le persone con controllo significativo di MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Telent Limited
    Haywood Road
    CV34 5AH Warwick
    Point 3
    England
    06 apr 2016
    Haywood Road
    CV34 5AH Warwick
    Point 3
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngand & Wales
    Numero di registrazione67307
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security trust and intercreditor deed
    Creato il 19 mag 2003
    Consegnato il 05 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    If any intra-group creditor receives any sum in relation to any intra-group liability other than pursuant to clause 9.5 of the deed, that sum shall be promptly paid to the security trustee for application in accordance with the terms of the deed, and pending such payment it shall be held on trust for the security trustee.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An australian asset fixed and floating charge
    Creato il 19 mag 2003
    Consegnato il 04 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future indebtedness liabilities and obligations at any time of the company to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured creditors) or any of the other secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. as Security Trustee
    Transazioni
    • 04 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A debenture between the companies (including the chargor) and the law debenture trust corporation P.L.C. as security trustee for the secured creditors
    Creato il 19 mag 2003
    Consegnato il 02 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future indebtedness liabilities and obligations at any time of the company to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured creditors) or any of the other secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all of its right title and interest from time to time and to each of the following assets: the schedule 4 real property; the tangible moveable property; any goodwill; all rights in relation to the uncalled capital; the shares, all dividends, interest and other monies; all monetary claims. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. as Security Trustee
    Transazioni
    • 02 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 25 apr 2000
    Consegnato il 11 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a bond in favour of centre d'etrudes et de recherches des telecommunications (cert) for us$37,270
    Brevi particolari
    The sum of us$37,270 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 140-01-08153957.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 31 mar 2000
    Consegnato il 10 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond in favour of centre d'etrudes et de recherches des telecommunications (cert) for us $ 37,270
    Brevi particolari
    The sum of $37,270 us dollars together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 140/01/08153957 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 25 ott 1999
    Consegnato il 28 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from metapath software international, inc., Metapath software international (bellevue), inc., Metapath software international (dallas), inc. And metapath software international limited to the chargee under a facility document as defined in the guarantee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Greyrock Capital
    Transazioni
    • 28 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 22 ott 1999
    Consegnato il 26 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a performance bond in favour of bharti cellular limited $25,300 us dollars
    Brevi particolari
    The sum of $25,300 us dollars together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 140/01/08123748 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 22 ott 1999
    Consegnato il 26 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a performance bond in favour of singapore telecom mobile pte limited for s$345,576.65 Singapore dollars
    Brevi particolari
    The sum of $249,700 us dollars together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 140/01/08123764 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 19 ott 1999
    Consegnato il 27 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a performance bond in favour of et communications sdn bhd for us$109,475.40
    Brevi particolari
    The sum of us$109,475.40 Together with interest accrued now or to be he national westminster bank PLC on an account numbered 140-01-08119538 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 04 mar 1999
    Consegnato il 11 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sum of £18,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 90182111.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 30 mar 1998
    Consegnato il 03 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    $1,563,000 us dollars with interest accrued on account no. 140-01-06422160 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 30 mar 1998
    Consegnato il 03 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    $1,953,000 us dollars with interest thereon on account no. 140-01-06422160 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 19 giu 1997
    Consegnato il 24 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 25 nov 1996
    Consegnato il 04 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a performance guarantee in favour of china resources (holdings) co LTD for hk$11,000,000
    Brevi particolari
    The sum of £1,100,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 90122904 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 25 nov 1996
    Consegnato il 03 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sum of £1,375,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 90123298 and earmarked or designated ny reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    02 mar 2022Inizio della liquidazione
    10 apr 2024Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Malone
    8th Floor One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    Praticante
    8th Floor One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    Gareth Prince
    8th Floor One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    Praticante
    8th Floor One Temple Row
    B2 5LG Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0