LEAFIELD LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLEAFIELD LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02436740
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LEAFIELD LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova LEAFIELD LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Lea Park, Monks Lane
    Corsham
    SN13 9PH Wiltshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LEAFIELD LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LEAFIELD GROUP LIMITED27 lug 199827 lug 1998
    LEAFIELD HOLDINGS LIMITED24 set 199124 set 1991
    LEAFIELD ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED28 feb 199028 feb 1990
    OVAL (568) LIMITED26 ott 198926 ott 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di LEAFIELD LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per LEAFIELD LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 02 ago 2011

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Edward Thistlethwayte il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ronald Priestley il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    7 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di LEAFIELD LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHAPPLE, Timothy Jonathan
    10 St Mellion Close
    Monkton Park
    SN15 3XN Chippenham
    Wiltshire
    Segretario
    10 St Mellion Close
    Monkton Park
    SN15 3XN Chippenham
    Wiltshire
    British28933940004
    HORNER, David Alistair
    15 Macaulay Buildings
    Widcombe Hill
    BA2 6AT Bath
    Somerset
    Amministratore
    15 Macaulay Buildings
    Widcombe Hill
    BA2 6AT Bath
    Somerset
    EnglandBritish79690220002
    PRIESTLEY, Ronald
    Monks Lane
    SN13 9PH Corsham
    Lea Park
    Wiltshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Monks Lane
    SN13 9PH Corsham
    Lea Park
    Wiltshire
    United Kingdom
    FranceBritish64016050005
    THISTLETHWAYTE, Mark Edward
    Fairfield House
    East Street, Hambledon
    PO7 4RY Waterlooville
    Hampshire
    Amministratore
    Fairfield House
    East Street, Hambledon
    PO7 4RY Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritish107579860001
    COOK, Peter George
    Kings Walden
    SG4 8LT Hitchin
    The Crown House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Kings Walden
    SG4 8LT Hitchin
    The Crown House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Other129506020001
    FORSYTH, Nigel John
    Park Farm Barn
    PO7 4SB Hambledon
    Hampshire
    Segretario
    Park Farm Barn
    PO7 4SB Hambledon
    Hampshire
    British59380470002
    WHADCOCK, Stephen Arthur
    75 Nursteed Road
    SN10 3AJ Devizes
    Wiltshire
    Segretario
    75 Nursteed Road
    SN10 3AJ Devizes
    Wiltshire
    British6425330001
    BLOTT, James
    The Rest
    West Street
    PO7 4RW Hambledon
    Hampshire
    Amministratore
    The Rest
    West Street
    PO7 4RW Hambledon
    Hampshire
    British59380580002
    CHAPPLE, Timothy Jonathan
    10 St Mellion Close
    Monkton Park
    SN15 3XN Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    10 St Mellion Close
    Monkton Park
    SN15 3XN Chippenham
    Wiltshire
    United KingdomBritish28933940004
    DYKE, Robert Alexander
    Grove Farm 156 Winsley Road
    BA15 1PA Bradford On Avon
    Wiltshire
    Amministratore
    Grove Farm 156 Winsley Road
    BA15 1PA Bradford On Avon
    Wiltshire
    EnglandBritish51678350002
    FORSYTH, Nigel John
    Amber House
    The Gardens Sion Road
    BA1 2TJ Bath
    Amministratore
    Amber House
    The Gardens Sion Road
    BA1 2TJ Bath
    British59380470003
    JACOMB, Kenneth Edward
    Holly Tree Farm
    Sandy Lane
    SN12 2QB Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    Holly Tree Farm
    Sandy Lane
    SN12 2QB Chippenham
    Wiltshire
    British6425340001
    MUNRO, Peter Austin Dods
    Top Acres
    Chapmanslade
    BA13 4AP Westbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Top Acres
    Chapmanslade
    BA13 4AP Westbury
    Wiltshire
    British67696410001
    PRIESTLEY, Ronald
    1 Park Road
    Slinfold
    RH13 7SD Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    1 Park Road
    Slinfold
    RH13 7SD Horsham
    West Sussex
    British64016050001
    TONGE, Richard Leslie
    4 Trimnells
    Colerne
    SN14 8EP Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    4 Trimnells
    Colerne
    SN14 8EP Chippenham
    Wiltshire
    British6425360001
    WHADCOCK, Stephen Arthur
    75 Nursteed Road
    SN10 3AJ Devizes
    Wiltshire
    Amministratore
    75 Nursteed Road
    SN10 3AJ Devizes
    Wiltshire
    British6425330001
    WHITTLES, Michael John
    Middle Bear
    57 High Street Standon
    SG11 1LA Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    Middle Bear
    57 High Street Standon
    SG11 1LA Ware
    Hertfordshire
    British4271840002

    LEAFIELD LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 giu 2003
    Consegnato il 05 lug 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 22 gen 1997
    Consegnato il 23 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a monks park storage depot monks lane corsham wiltshire together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon fixed charge all present and future book and other debts assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 mar 1990
    Consegnato il 31 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,050,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All the assets and undertaking of the company.
    Persone aventi diritto
    • Honeywell Limited
    Transazioni
    • 31 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 09 gen 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 21 dic 1989
    Consegnato il 09 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 09 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 24 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0