VIEWTON PROPERTIES LIMITED

VIEWTON PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVIEWTON PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02436950
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VIEWTON PROPERTIES LIMITED?

    • Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni

    Dove si trova VIEWTON PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    Derbyshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di VIEWTON PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per VIEWTON PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022

    5 pagineAA

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    5 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2020 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 giu 2016

    Stato del capitale al 27 giu 2016

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    5 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Murdoch il 03 ago 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 08 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 giu 2015

    Stato del capitale al 08 giu 2015

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Cessazione della carica di Keith Manson Miller come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 giu 2014

    Stato del capitale al 30 giu 2014

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di VIEWTON PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JACKSON, Julie Mansfield
    Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    2
    Derbyshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    2
    Derbyshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish94193070001
    MURDOCH, Ian
    Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    2
    Derbyshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    2
    Derbyshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish179717450001
    FELLOWES, Colin
    9 Thistlewood Drive
    Summerfields
    SK9 2RF Wilmslow
    Cheshire
    Segretario
    9 Thistlewood Drive
    Summerfields
    SK9 2RF Wilmslow
    Cheshire
    British800670001
    SMYTH, Pamela June
    6060 Knights Court, Solihull
    Parkway, Birmingham Business
    B37 7WY Park, Solihull
    Segretario
    6060 Knights Court, Solihull
    Parkway, Birmingham Business
    B37 7WY Park, Solihull
    British65057960002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    38508390004
    ANDERSON, Ewan Thomas
    6060 Knights Court, Solihull
    Parkway, Birmingham Business
    B37 7WY Park, Solihull
    Amministratore
    6060 Knights Court, Solihull
    Parkway, Birmingham Business
    B37 7WY Park, Solihull
    ScotlandBritish71536430001
    BAK, Paul Mario
    Greenacres August Lane
    Farley Green
    GU5 9DP Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Greenacres August Lane
    Farley Green
    GU5 9DP Guildford
    Surrey
    British67836240002
    BASELEY, Stewart Antony
    Low Wood
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    Low Wood
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    EnglandBritish4809150002
    COX, Michael John
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    British28998990001
    DEVINE, Stephen Colm
    4 Fernbank
    Finchampstead
    RG11 4XB Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    4 Fernbank
    Finchampstead
    RG11 4XB Wokingham
    Berkshire
    Irish6552570001
    FOGDEN, Geoffrey Harold
    Rydencroft
    Preston New Road
    PR4 3RE Newton With Scales
    Lancashire
    Amministratore
    Rydencroft
    Preston New Road
    PR4 3RE Newton With Scales
    Lancashire
    United KingdomBritish92179710001
    HAMPSON, John
    65 Kingsway
    WC2B 6QT London
    Amministratore
    65 Kingsway
    WC2B 6QT London
    British25345860001
    HAWE, Malcolm Albert
    Greenbriar
    Dubside Wrea Green
    PR4 2WQ Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Greenbriar
    Dubside Wrea Green
    PR4 2WQ Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish81788230001
    HOUGH, Timothy
    6060 Knights Court, Solihull
    Parkway, Birmingham Business
    B37 7WY Park, Solihull
    Amministratore
    6060 Knights Court, Solihull
    Parkway, Birmingham Business
    B37 7WY Park, Solihull
    EnglandBritish80381140002
    ISAAC, Roger
    65 Kingsway
    WC2B 6QT London
    Amministratore
    65 Kingsway
    WC2B 6QT London
    British7582000001
    JACKSON, Stanley Robertson
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    British4689630002
    JACKSON, Stanley Robertson
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    British4689630002
    MILLER, Keith Manson
    Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    2
    Derbyshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    2
    Derbyshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish546650002
    MILLS, Stanley
    Whitegates
    Wixford
    B49 6DA North Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    Whitegates
    Wixford
    B49 6DA North Alcester
    Warwickshire
    British573140004
    RICHARDS, John Steel
    Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    2
    Derbyshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    2
    Derbyshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish1318380002
    WOOD, Robert John
    Bramber House
    59 Lakewood Road, Chandlers Ford
    SO53 1EU Eastleigh
    Hants
    Amministratore
    Bramber House
    59 Lakewood Road, Chandlers Ford
    SO53 1EU Eastleigh
    Hants
    British93812590001
    AMEC NOMINEES LIMITED
    Sandiway House
    Hartford
    CW8 2YA Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    Sandiway House
    Hartford
    CW8 2YA Northwich
    Cheshire
    32732300001

    Chi sono le persone con controllo significativo di VIEWTON PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    2
    Derbyshire
    United Kingdom
    20 giu 2017
    Centro Place
    Pride Park
    DE24 8RF Derby
    2
    Derbyshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione01987689
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    VIEWTON PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 30 mar 2001
    Consegnato il 12 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in respect of each senior document to which a chargor is a party
    Brevi particolari
    Fixed charge over all investments owned by it or held by any nominee on it's behalf together with floating charge all the companies assets other than the investments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent and Trustee for the Senior Lenders, the Facility Agent)
    Transazioni
    • 12 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 23 mar 1990
    Consegnato il 03 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 mar 1990
    Consegnato il 03 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Two parcels of f/h land at ovangle road morecombe.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge on building agreement
    Creato il 23 mar 1990
    Consegnato il 03 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A building and management contract made 22-2-89. between fairclough homes limited & the company.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 mar 1990
    Consegnato il 24 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the debenture dated 22/12/89
    Brevi particolari
    Fixed charge mortgage over two parcels of land at ovangle road, morecambe lancashire. Approx 39.75 acres. All buildings and fixtures. All plant and machinery. Vehicles computers and office equipment both present and future. (Please see form 395 for further details).
    Persone aventi diritto
    • Electra Property Finance Limited
    Transazioni
    • 24 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 22 dic 1989
    Consegnato il 29 dic 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility agreement dated 22.12.89
    Brevi particolari
    All rights title benefits & interest of the company in a building and management contract dated 18.12.89.
    Persone aventi diritto
    • Electra Property Finance Limited
    Transazioni
    • 29 dic 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 dic 1989
    Consegnato il 29 dic 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (For full details refer to doc 395 ref M362C). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Electra Property Finance Limited
    Transazioni
    • 29 dic 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0