MAPLE SECURITIES (UK) LTD

MAPLE SECURITIES (UK) LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMAPLE SECURITIES (UK) LTD
    Stato della societàIn amministrazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02437924
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di MAPLE SECURITIES (UK) LTD?

    • Negoziazione per conto proprio di valori mobiliari (64991) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova MAPLE SECURITIES (UK) LTD?

    Indirizzo della sede legale
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MAPLE SECURITIES (UK) LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MAPLE PARTNERS (U.K.) LIMITED17 nov 199717 nov 1997
    FIRST MARATHON (U.K.) LIMITED11 gen 199011 gen 1990
    STRONGTOP LIMITED31 ott 198931 ott 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di MAPLE SECURITIES (UK) LTD?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 set 2015
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 giu 2016
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2014

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per MAPLE SECURITIES (UK) LTD?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al01 set 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma15 set 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MAPLE SECURITIES (UK) LTD?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per MAPLE SECURITIES (UK) LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    18 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    18 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    18 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    19 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    18 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    18 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    19 pagineAM10

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo o aggiuntivo

    3 pagineAM11

    Avviso dell'ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    14 pagineAM16

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    18 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    38 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    19 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    19 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    19 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    19 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    20 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    20 pagineAM10

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo o aggiuntivo

    13 pagineAM11

    Dimissioni di un amministratore

    13 pagineAM15

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 16 feb 2017

    23 pagine2.24B

    Cessazione della carica di Florian Wolfgang Wirsching come amministratore in data 23 giu 2016

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di James Anthony David Leach come amministratore in data 23 giu 2016

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gordon George Mclean come amministratore in data 16 ago 2016

    2 pagineTM01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 16 ago 2016

    15 pagine2.24B

    Indirizzo della sede legale modificato da Ryder Court 14 Ryder Street London SW1Y 6QB a 7 More London Riverside London SE1 2RT in data 07 lug 2016

    2 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di MAPLE SECURITIES (UK) LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCLEAN, Gordon George
    2b Agar Grove
    Ground Floor Flat
    NW1 9TD London
    Segretario
    2b Agar Grove
    Ground Floor Flat
    NW1 9TD London
    BritishDirector104516970001
    PRADE, Benjamin Edouard Richard
    Wildernesse Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Bassetts
    Kent
    Amministratore
    Wildernesse Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Bassetts
    Kent
    United KingdomBritishFinancial Services133415070002
    RICHARDSON, Thomas James
    Chestnut Avenue
    KT10 8JF Esher
    56
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Chestnut Avenue
    KT10 8JF Esher
    56
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector118466060002
    BROWN, Judith Valerie
    2 Rock Cottages
    Mountfield
    TN32 5JX Robertsbridge
    East Sussex
    Segretario
    2 Rock Cottages
    Mountfield
    TN32 5JX Robertsbridge
    East Sussex
    British19738290001
    DEMETRIOU, Andrew
    5 Bovingdon Road
    SW6 2AP London
    Segretario
    5 Bovingdon Road
    SW6 2AP London
    BritishChief Operating Officer91898120001
    DOYLE, James
    33a Sisters Avenue
    Battersea
    SW11 5SR London
    Segretario
    33a Sisters Avenue
    Battersea
    SW11 5SR London
    BritishDirector76256870004
    MARMION, Myles Columba
    30 Manorgate Road
    KT2 7AL Kingston
    Surrey
    Segretario
    30 Manorgate Road
    KT2 7AL Kingston
    Surrey
    British142764640001
    MASH, Rosalind Elizabeth
    15 Lansdowne Court
    Lansdowne Crescent
    W11 2NW London
    Segretario
    15 Lansdowne Court
    Lansdowne Crescent
    W11 2NW London
    British34781520001
    WOOD, William David
    734 Nautalex Court
    Mississauga
    Ontario
    Canada
    Segretario
    734 Nautalex Court
    Mississauga
    Ontario
    Canada
    British36968480001
    WOOD, William David
    734 Nautalex Court
    Mississauga
    FOREIGN Ontario L5h 1a7
    Canada
    Segretario
    734 Nautalex Court
    Mississauga
    FOREIGN Ontario L5h 1a7
    Canada
    Canadian31818990001
    BERNHARD, Hans Michael Rudigen
    Memeler Street 8
    Butzbach
    35510
    Germany
    Amministratore
    Memeler Street 8
    Butzbach
    35510
    Germany
    GermanyGermanFinancial Services62573190001
    BLOOMBERG, Lawrence Sheldon
    70 Ardwold Gate
    Toronto
    FOREIGN Ontario M5r 2w2
    Canada
    Amministratore
    70 Ardwold Gate
    Toronto
    FOREIGN Ontario M5r 2w2
    Canada
    CanadianChairman Director31819000001
    BRENNAN, Mark Peter
    Flat 10 Boston House
    31 Collingham Road
    SW5 0NS London
    Amministratore
    Flat 10 Boston House
    31 Collingham Road
    SW5 0NS London
    British/CanadianStock Broker34781500001
    BROWN, Judith Valerie
    2 Rock Cottages
    Mountfield
    TN32 5JX Robertsbridge
    East Sussex
    Amministratore
    2 Rock Cottages
    Mountfield
    TN32 5JX Robertsbridge
    East Sussex
    BritishCompliance Officer19738290001
    CHARBONNEAU, Robert Charles Leonard
    3 Ascott Avenue
    W5 3XL London
    Amministratore
    3 Ascott Avenue
    W5 3XL London
    CanadianSecurities Broker44465700002
    COHEN, Robin Daniel
    47 Wykeham Road
    NW4 2SS London
    Amministratore
    47 Wykeham Road
    NW4 2SS London
    EnglandBritishInvestment Manager44278840001
    CRAIG, Campbell John
    Flat 5
    37 Lennox Gardens
    SW1 0DF London
    Amministratore
    Flat 5
    37 Lennox Gardens
    SW1 0DF London
    British/CanadianAccount Executive45582360001
    DEMETRIOU, Andrew
    5 Bovingdon Road
    SW6 2AP London
    Amministratore
    5 Bovingdon Road
    SW6 2AP London
    United KingdomBritishFinancial Services91898120001
    DOYLE, James
    33a Sisters Avenue
    Battersea
    SW11 5SR London
    Amministratore
    33a Sisters Avenue
    Battersea
    SW11 5SR London
    BritishDirector76256870004
    DUNN, Jason
    Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Amministratore
    Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    EnglandBritishDirector179775950001
    HENRY, Stuart Ward
    Rr2 Baltimore Kok 1co
    Ontario
    FOREIGN Canada
    Amministratore
    Rr2 Baltimore Kok 1co
    Ontario
    FOREIGN Canada
    CanadianDir Chief Financial Officer58029260001
    HIGGINS, Thomas
    7 Gibson Avenue
    M5R 1TA Toronto
    Ontario
    Canada
    Amministratore
    7 Gibson Avenue
    M5R 1TA Toronto
    Ontario
    Canada
    CanadianFinancial Services104610870001
    KNEIS, Elizabeth
    229 Walmer Road
    Toronto
    FOREIGN Ontario M5r 3pz
    Canada
    Amministratore
    229 Walmer Road
    Toronto
    FOREIGN Ontario M5r 3pz
    Canada
    CanadianDirector31819010001
    LAM, Maria
    35 Beaufort Gardens
    SW3 1PW London
    Amministratore
    35 Beaufort Gardens
    SW3 1PW London
    EnglandCanadianFinancial Services104517220001
    LEACH, James Anthony David
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Amministratore
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    United KingdomBritishFinance142415740003
    MARMION, Myles Columba
    30 Manorgate Road
    KT2 7AL Kingston
    Surrey
    Amministratore
    30 Manorgate Road
    KT2 7AL Kingston
    Surrey
    United KingdomBritishFinance142764640001
    MASH, Rosalind Elizabeth
    15 Lansdowne Court
    Lansdowne Crescent
    W11 2NW London
    Amministratore
    15 Lansdowne Court
    Lansdowne Crescent
    W11 2NW London
    United KingdomBritishStockbroker34781520001
    MCLEAN, Gordon George
    2b Agar Grove
    Ground Floor Flat
    NW1 9TD London
    Amministratore
    2b Agar Grove
    Ground Floor Flat
    NW1 9TD London
    United KingdomBritishFinancial Services104516970001
    PETERS, Hilda Maikina
    Flat 11
    31 Collingham Road
    SW5 0NU London
    Amministratore
    Flat 11
    31 Collingham Road
    SW5 0NU London
    DutchStockbroker34781510001
    PRICHARD, Roger Montague
    Wakeman Lane
    CT 06890 Southport
    267
    Connecticut
    Usa
    Amministratore
    Wakeman Lane
    CT 06890 Southport
    267
    Connecticut
    Usa
    UsaCanadianGroup Chief Financial Officer118555780002
    RICHARDS, Alan David
    129 Pepys Road
    SE14 5SE London
    Amministratore
    129 Pepys Road
    SE14 5SE London
    EnglandBritishInvestment Manager49930100001
    ROFFEY, David Ernest
    41 Binscarth Road
    Toronto
    Ontario M4w 1y3
    Canada
    Amministratore
    41 Binscarth Road
    Toronto
    Ontario M4w 1y3
    Canada
    CanadianStockbroker50138330002
    ROSENTHAL, Robert Carl
    224 Crest Road
    Ridgewood
    FOREIGN New Jersey
    Njo7451
    Usa
    Amministratore
    224 Crest Road
    Ridgewood
    FOREIGN New Jersey
    Njo7451
    Usa
    AmericanDirector51173180004
    ROWLANDS, Harry Alexander
    20a Whittingstall Road
    SW6 4ED London
    Amministratore
    20a Whittingstall Road
    SW6 4ED London
    British/CanadianStockbroker34781530003
    SCHUCK, Wolfgang
    Am Hoehlchen
    65812
    Bad Soden
    2
    Germany
    Amministratore
    Am Hoehlchen
    65812
    Bad Soden
    2
    Germany
    GermanyGermanDirector134340750001

    MAPLE SECURITIES (UK) LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 30 apr 2013
    Consegnato il 11 mag 2013
    In corso
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Citibank, N.A. for Itself and Behalf of Each Branch or Affiliate of the Bank from Time to Time Selected and Appointed by the Charging Company and Identified in Exhibit a to the Agreement as Custodian or Clearing Agent (Each a "Custodian")
    Transazioni
    • 11 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 31 dic 2010
    Consegnato il 11 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge all securities, deposits and any other assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of New York Mellon
    Transazioni
    • 11 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Security agreement over cash (fixed charge)
    Creato il 23 feb 2005
    Consegnato il 04 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any cash standing to the credit of the "msuk fixed account" (the "msuk collateral"). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Markus Fiala
    Transazioni
    • 04 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement over cash (fixed charge)
    Creato il 23 feb 2005
    Consegnato il 04 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any cash standing to the credit of the "msuk fixed account" (the "msuk collateral"). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dennis O'connell
    Transazioni
    • 04 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Isda credit support deed relating to the isda master agreement dated 13TH june 2001
    Creato il 14 nov 2002
    Consegnato il 22 nov 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All posted collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Saloman Brothers International Limited
    Transazioni
    • 22 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security deed
    Creato il 26 set 2001
    Consegnato il 17 ott 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any group company which arise in connection with the facility agreement and/or the security deed
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all sums and payments at the date and from time to time thereafter receivable by or for the account of the company and by way of floating charge all stock held by or on behalf of or for the account of the company in crest. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank Na
    Transazioni
    • 17 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage deed of amendment
    Creato il 16 ott 2000
    Consegnato il 24 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the security documents
    Brevi particolari
    The shares being all classes of shares issuer hygrove offshore fund limited together with all dividends stocks shares securities rights and monies accruing or offered at any time and other assets relating to the shares please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ubs Ag
    Transazioni
    • 24 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security deed
    Creato il 03 ott 2000
    Consegnato il 06 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all sums and payments, rights, title and interest into all monies standing to the credit of the controlled accounts and floating charge over all eligible stock, property and rights, etc. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed of amendment
    Creato il 09 ago 2000
    Consegnato il 16 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the security documents (as defined therein)
    Brevi particolari
    The shares together with all dividens and any other income derived from them. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ubs Ag
    Transazioni
    • 16 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security deed dated 30 june 2000 (the "security deed") between the company and national westminster bank PLC (the "bank")
    Creato il 30 giu 2000
    Consegnato il 10 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All debts obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the facility agreement and/or the security deed or any of the other documentation as defined therein
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all sums and payments at the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or for the company and by way of first floating charge all eligible stock held by or on behalf of or for the account of the company in crest. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed of amendment
    Creato il 26 giu 2000
    Consegnato il 30 giu 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the security documents (as defined)
    Brevi particolari
    All shares specified in schedule to form 395 together with all related rights thereof inclusive of stocks shares securities bonus and dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ubs Ag
    Transazioni
    • 30 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 lug 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 lug 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 lug 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Mortgage of shares
    Creato il 02 mar 2000
    Consegnato il 11 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the security documents
    Brevi particolari
    The shares by way of first legal mortgage and all dividends paid or payable after the date of this mortgage on all or any of the shares,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ubs Ag
    Transazioni
    • 11 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 lug 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 lug 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 lug 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creato il 29 set 1999
    Consegnato il 13 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the security documents (as defined)
    Brevi particolari
    The shares being all class a non-voting redeemable participating shares of auda global limited (the "company") issued by the company and held by the chargor from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ubs Ag
    Transazioni
    • 13 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creato il 28 set 1999
    Consegnato il 13 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the security documents (as defined)
    Brevi particolari
    The shares; all class c shares (series 111 1999) of quadra strategic partners, inc, (the "company") issued by the company and held by the chargor from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ubs Ag
    Transazioni
    • 13 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental security deed
    Creato il 29 lug 1999
    Consegnato il 05 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all sums and payments from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security deed
    Creato il 29 lug 1999
    Consegnato il 05 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all sums and payments,rights,title and interest into all monies thereon and floating charge over all stocks,property and rights,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creato il 02 lug 1999
    Consegnato il 15 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the security documents (as defined)
    Brevi particolari
    All class b participating non-voting shares of qm ais portfolio limited and qm opportunity portfolio limited held by the company and all dividends payable by way of redemption bonus preference or option derived from the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ubs Ag
    Transazioni
    • 15 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creato il 01 giu 1999
    Consegnato il 14 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The aggregate of all sums of money and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the security documents (as defined)
    Brevi particolari
    Mortgages and charges the shares to the bank, by way of a first legal mortgage. 1) all dividends paid or payable after the date of this mortgage on all or any of the shares, 2) all stocks, shares, securities, rights, moneys or property accruing or offered at any time (whether by way of redemption, bonus, preference, options rights or otherwise) to or in respect of any of the shares.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ubs Ag
    Transazioni
    • 14 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security over cash deposits and securities agreement
    Creato il 13 gen 1999
    Consegnato il 28 gen 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to the "charged portfolio" being all of the accounts the deposits and the securities where the accounts shall mean each account or other deposit for the time being maintained with the secured party by the chargor, the deposit being each credit balance from time to time on an account and all rights benefits and proceeds in respect thereof and securities being all securities at any time (and all rights benefits and proceeds attaching thereto or arising therefrom or in respect thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of New York
    Transazioni
    • 28 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Custody agreement
    Creato il 30 apr 1998
    Consegnato il 15 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under section 11 of the custody agreement
    Brevi particolari
    All cash and securities held in any account pursuant to the custody agreement.
    Persone aventi diritto
    • Caroline Desbrie're-REF962-Banque Paribas
    Transazioni
    • 15 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Custody agreement
    Creato il 30 apr 1998
    Consegnato il 13 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the custody agreement
    Brevi particolari
    All cash, shares, stocks, bonds, notes, debentures or other securities held from time to time on the account of the company by the bank.
    Persone aventi diritto
    • Banque Paribas
    Transazioni
    • 13 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Terms of business agreement
    Creato il 18 nov 1997
    Consegnato il 21 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations of the company (formerly known as first marathon (UK) limited) to the chargee under the agreement and under any transaction or other obligation of the company to the chargee or any associate of the chargee
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge and pledge over all deposits and margin and all securities documents of or entering title to property cash or other assets of any nature with the benefit of all contractual rights and any proceeds of sale and any securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Meespierson Ics Limited
    Transazioni
    • 21 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 10 ott 1996
    Consegnato il 11 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge
    Brevi particolari
    All shares, stock and other securities of any description. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • London Stock Exchange Limited
    Transazioni
    • 11 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MAPLE SECURITIES (UK) LTD ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    17 feb 2016Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ross David Connock
    2 Glass Wharf
    BS2 0EL Bristol
    Avon
    Praticante
    2 Glass Wharf
    BS2 0EL Bristol
    Avon
    David James Kelly
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Mark Charles Batten
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Russell Downs
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0