THE GLENDOWER GROUP LIMITED

THE GLENDOWER GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE GLENDOWER GROUP LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02441490
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di THE GLENDOWER GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova THE GLENDOWER GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Green Park Wharfedale Road
    Euroway Industrial Estate
    BD4 6SG Bradford
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE GLENDOWER GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE FUTURAMA SIGN GROUP LIMITED 08 ott 199008 ott 1990
    FUTURAMA HOLDINGS LIMITED29 dic 198929 dic 1989
    LAKEGLADE LIMITED09 nov 198909 nov 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE GLENDOWER GROUP LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al29 dic 2022
    Scadenza dei prossimi bilanci il29 dic 2023
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 dic 2021

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per THE GLENDOWER GROUP LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al28 lug 2023
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma11 ago 2023
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al28 lug 2022
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per THE GLENDOWER GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Cessazione della carica di Marc James Edwards come amministratore in data 23 feb 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di William Jonathan Evans come amministratore in data 23 feb 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di William Jonathan Evans come segretario in data 23 feb 2023

    1 pagineTM02

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Conto per una società dormiente redatto al 29 dic 2021

    7 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 dic 2021 al 29 dic 2021

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    17 pagineAA

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2020

    8 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Notifica di Phoenix Fire Inhibitor Limited come persona con controllo significativo il 11 dic 2020

    2 paginePSC02

    Indirizzo della sede legale modificato da , Olympia House Metro Park 45, Lockwood Court, Leeds, LS11 5TY, England a Green Park Wharfedale Road Euroway Industrial Estate Bradford BD4 6SG in data 21 apr 2021

    1 pagineAD01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Memorandum e Statuto

    13 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Nomina di Mr Darren Peter Mcmurray come amministratore in data 03 apr 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Benjamin David William Roberts come amministratore in data 03 apr 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Samuel Anthony Roberts come amministratore in data 03 apr 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Emily Charlotte Roberts come amministratore in data 03 apr 2020

    1 pagineTM01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2018

    36 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di THE GLENDOWER GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCMURRAY, Darren Peter
    Wharfedale Road
    Euroway Industrial Estate
    BD4 6SG Bradford
    Green Park
    England
    Amministratore
    Wharfedale Road
    Euroway Industrial Estate
    BD4 6SG Bradford
    Green Park
    England
    EnglandBritish210673030001
    DOBRIN, Michael Morris
    49 Grimsdyke Crescent
    EN5 4AQ Barnet
    Hertfordshire
    Segretario
    49 Grimsdyke Crescent
    EN5 4AQ Barnet
    Hertfordshire
    British30171050002
    EVANS, William Jonathan
    Wharfedale Road
    Euroway Industrial Estate
    BD4 6SG Bradford
    Green Park
    England
    Segretario
    Wharfedale Road
    Euroway Industrial Estate
    BD4 6SG Bradford
    Green Park
    England
    223085620001
    RICHARDS, June Margaret
    South Padre 8 Hurtmore Chase
    GU7 2RT Godalming
    Surrey
    Segretario
    South Padre 8 Hurtmore Chase
    GU7 2RT Godalming
    Surrey
    British24304310002
    ROBERTS, Ricky Ashley
    Woolfords Lane
    Elstead
    GU8 6LL Godalming
    Tadmoor Cottage
    Surrey
    England
    Segretario
    Woolfords Lane
    Elstead
    GU8 6LL Godalming
    Tadmoor Cottage
    Surrey
    England
    British21242130002
    BOULTON, Gareth
    Metro Park 45
    Lockwood Court
    LS11 5TY Leeds
    Olympia House
    England
    Amministratore
    Metro Park 45
    Lockwood Court
    LS11 5TY Leeds
    Olympia House
    England
    EnglandBritish191575560001
    DOBRIN, Michael Morris
    49 Grimsdyke Crescent
    EN5 4AQ Barnet
    Hertfordshire
    Amministratore
    49 Grimsdyke Crescent
    EN5 4AQ Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish30171050002
    EDWARDS, Marc James
    Wharfedale Road
    Euroway Industrial Estate
    BD4 6SG Bradford
    Green Park
    England
    Amministratore
    Wharfedale Road
    Euroway Industrial Estate
    BD4 6SG Bradford
    Green Park
    England
    EnglandBritish157627660003
    EVANS, William Jonathan
    Wharfedale Road
    Euroway Industrial Estate
    BD4 6SG Bradford
    Green Park
    England
    Amministratore
    Wharfedale Road
    Euroway Industrial Estate
    BD4 6SG Bradford
    Green Park
    England
    EnglandBritish174725470001
    MILLER, Steven David
    House
    Island Farm Road
    KT8 2TR West Molesey
    Island Farm
    Surrey
    England
    Amministratore
    House
    Island Farm Road
    KT8 2TR West Molesey
    Island Farm
    Surrey
    England
    EnglandBritish182575510001
    ROBERTS, Benjamin David William
    Metro Park 45
    Lockwood Court
    LS11 5TY Leeds
    Olympia House
    England
    Amministratore
    Metro Park 45
    Lockwood Court
    LS11 5TY Leeds
    Olympia House
    England
    EnglandBritish255764650001
    ROBERTS, Emily Charlotte
    Metro Park 45
    Lockwood Court
    LS11 5TY Leeds
    Olympia House
    England
    Amministratore
    Metro Park 45
    Lockwood Court
    LS11 5TY Leeds
    Olympia House
    England
    EnglandBritish255764040001
    ROBERTS, Ricky Ashley
    Woolfords Lane
    Elstead
    GU8 6LL Godalming
    Tadmoor Cottage
    Surrey
    England
    Amministratore
    Woolfords Lane
    Elstead
    GU8 6LL Godalming
    Tadmoor Cottage
    Surrey
    England
    United KingdomBritish21242130002
    ROBERTS, Samuel Anthony
    Metro Park 45
    Lockwood Court
    LS11 5TY Leeds
    Olympia House
    England
    Amministratore
    Metro Park 45
    Lockwood Court
    LS11 5TY Leeds
    Olympia House
    England
    EnglandBritish255764320001
    SMALL, Andrew Charles
    Metro Park 45
    Lockwood Court
    LS11 5TY Leeds
    Olympia House
    England
    Amministratore
    Metro Park 45
    Lockwood Court
    LS11 5TY Leeds
    Olympia House
    England
    EnglandBritish235705330002
    WHALE, Leroy
    Island Farm House
    Island Farm Road
    KT8 2TR West Molesey
    Surrey
    Amministratore
    Island Farm House
    Island Farm Road
    KT8 2TR West Molesey
    Surrey
    EnglandBritish189329490001
    WHALE, Leroy
    Mistral Court 32 Channel Way
    Ocean Village
    SO14 3JA Southampton
    21
    Hampshire
    England
    Amministratore
    Mistral Court 32 Channel Way
    Ocean Village
    SO14 3JA Southampton
    21
    Hampshire
    England
    United KingdomBritish88042160004
    WINWRIGHT, Malcolm James
    Moat Cottage Thursley Road
    GU8 6LW Elstead
    Surrey
    Amministratore
    Moat Cottage Thursley Road
    GU8 6LW Elstead
    Surrey
    United KingdomBritish51124870001

    Chi sono le persone con controllo significativo di THE GLENDOWER GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Phoenix Fire Inhibitor Limited
    Tenax Road
    Trafford Park
    M17 1JT Manchester
    Unit 5
    England
    11 dic 2020
    Tenax Road
    Trafford Park
    M17 1JT Manchester
    Unit 5
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEnterprise Act
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione02617774
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Island Farm Road
    KT8 2TR West Molesey
    Island Farm House
    Surrey
    England
    06 apr 2016
    Island Farm Road
    KT8 2TR West Molesey
    Island Farm House
    Surrey
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione09071576
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    THE GLENDOWER GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 12 giu 2014
    Consegnato il 13 giu 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Oldco 12345 LTD
    Transazioni
    • 13 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 15 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 12 giu 2014
    Consegnato il 13 giu 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Futurama Signs Holdings Limited
    Transazioni
    • 13 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 15 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 08 mag 2013
    Consegnato il 10 mag 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Island farm house island farm road west moesely surrey t/no SY700319. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • West Register Number 2 Limited
    Transazioni
    • 10 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 gen 2010
    Consegnato il 20 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 13 gen 2010
    Consegnato il 20 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a island farm house island road molesey surrey by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 01 giu 2007
    Consegnato il 14 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge of securities (UK)
    Creato il 01 giu 2007
    Consegnato il 14 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any stocks shares bonds warrants or securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 01 giu 2007
    Consegnato il 14 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a island farm house island road molesey surrey t/no SY700319. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 24 mag 2006
    Consegnato il 02 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £200,000.00 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    Factory 5 island farm road west molesey surrey t/n SY700319.
    Persone aventi diritto
    • The Trustees of the Futurama Pension Scheme
    Transazioni
    • 02 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 nov 2002
    Consegnato il 29 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £200,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Factory 5,island farm road,west molesey,surrey KT8 2TR; t/no sy 700319.
    Persone aventi diritto
    • The Trustees of the Futurama Signs Directors Benefits Scheme (1992)
    Transazioni
    • 29 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 gen 2002
    Consegnato il 24 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £200,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Factory 5 island farm house island farm road west molesey surrey SY700319.
    Persone aventi diritto
    • The Trustees of the Futurama Pension Scheme
    Transazioni
    • 24 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 dic 2000
    Consegnato il 16 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Factory 5 island farm house west molesey surrey KT8 2TR.
    Persone aventi diritto
    • The Trustees of the Futurama Pension Scheme
    Transazioni
    • 16 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 mar 1991
    Consegnato il 15 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 15 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 02 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 01 mar 1991
    Consegnato il 13 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The cash deposit of £1,000,000 held in the account numbered 45521230 with hill samuel & co limited in the name of the company and all right title benefit and interest of the company whatsoever present and future therein together with any certificates of deposit,deposit receipts or other instruments or securities relting thereto.
    Persone aventi diritto
    • Wendy Sonia Pateman
    • Henry Gold
    Transazioni
    • 13 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    THE GLENDOWER GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 nov 2023Data della petizione
    23 gen 2024Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or Leeds
    3rd Floor
    1 City Walk
    LS11 9DA Leeds
    Praticante
    3rd Floor
    1 City Walk
    LS11 9DA Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0