WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED

WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02442706
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHOQS 186 LIMITED14 nov 198914 nov 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 mar 2020

    8 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 mar 2019

    7 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Countryside House the Drive Brentwood Essex CM13 3AT a 15 Canada Square London E14 5GL in data 04 apr 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 07 mar 2018

    LRESSP

    Nomina di Gary Neville Whitaker come amministratore in data 01 ott 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Stephen Cherry come amministratore in data 30 set 2017

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 mar 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2015

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 apr 2016

    Stato del capitale al 11 apr 2016

    • Capitale: GBP 5,000
    SH01

    Nomina di Mr Martin Clift come amministratore in data 03 ago 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jayne Williams come amministratore in data 15 giu 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 apr 2015

    Stato del capitale al 01 apr 2015

    • Capitale: GBP 5,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Stephen Cherry il 23 set 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Nomina di Jayne Williams come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 13 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 apr 2014

    Stato del capitale al 04 apr 2014

    • Capitale: GBP 5,000
    SH01

    Cessazione della carica di Karen Connell come amministratore

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WARREN, Tracy Marina
    Hollow Road
    Felsted
    CM6 3JF Dunmow
    The Molehill
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    Hollow Road
    Felsted
    CM6 3JF Dunmow
    The Molehill
    Essex
    United Kingdom
    British132463120001
    CLIFT, Martin
    Global Avenue
    LS11 8AN Leeds
    Millshaw Court
    England
    Amministratore
    Global Avenue
    LS11 8AN Leeds
    Millshaw Court
    England
    EnglandBritishBanker199928630001
    WHITAKER, Gary Neville
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritishGeneral Counsel238965410001
    HOYLES, Robin Patrick
    12 Springpark Drive
    BR3 6QD Beckenham
    Kent
    Segretario
    12 Springpark Drive
    BR3 6QD Beckenham
    Kent
    British34860250001
    PEARCE, Michael Frank
    Ashdale 18 Longaford Way
    Hutton Mount
    CM13 2LT Brentwood
    Essex
    Segretario
    Ashdale 18 Longaford Way
    Hutton Mount
    CM13 2LT Brentwood
    Essex
    British33032910001
    SHILLINGLAW, Gary Preston
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    Segretario
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    British66825690001
    BAKER, Trevor
    14 Bickmore Way
    TN9 1ND Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    14 Bickmore Way
    TN9 1ND Tonbridge
    Kent
    BritishManaging Director26767780002
    CHERRY, Alan Herbert
    Harvesters Green Street
    Fryerning
    CM4 ONS Ingatestone
    Essex
    Amministratore
    Harvesters Green Street
    Fryerning
    CM4 ONS Ingatestone
    Essex
    EnglandBritishChartered Surveyor2026150001
    CHERRY, Richard Stephen
    Countryside House
    The Drive Brentwood
    CM13 3AT Essex
    Amministratore
    Countryside House
    The Drive Brentwood
    CM13 3AT Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor68733260003
    CLEMINSON, Harold John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    BritishManaging Director43598530003
    CLEMINSON, Harold John
    7 All Saints Road
    TN4 9JF Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    7 All Saints Road
    TN4 9JF Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishHouse Building43598530001
    CONNELL, Karen Michelle
    Global Avenue
    LS11 8DD Leeds
    Millshaw Court
    England
    Amministratore
    Global Avenue
    LS11 8DD Leeds
    Millshaw Court
    England
    EnglandBritishBanker179412850001
    CROOK, Christopher Peter
    7 Lynton Road
    Thorpe Bay
    SS1 3BE Essex
    Amministratore
    7 Lynton Road
    Thorpe Bay
    SS1 3BE Essex
    BritishChartered Surveyor46724000001
    CUMMING, John Alan
    8 Prince Consort Drive
    BR7 5SB Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    8 Prince Consort Drive
    BR7 5SB Chislehurst
    Kent
    BritishCompany Director22511900001
    DEEPROSE, Richard William Griffith
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    BritishManaging Director Ekins62807120004
    DUNLOP, Roger Napier
    Setherum House
    Benham Park Marsh Benham
    RG20 8LX Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Setherum House
    Benham Park Marsh Benham
    RG20 8LX Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor68979710001
    GALLAGHER, Mark
    21 Cromwell Lane
    CM9 4LB Maldon
    Essex
    Amministratore
    21 Cromwell Lane
    CM9 4LB Maldon
    Essex
    EnglandBritishChartered Surveyor3110930001
    GROOM, Richard John
    Broomers Cottage
    Broomers Corner, Shipley
    RH13 8PX Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Broomers Cottage
    Broomers Corner, Shipley
    RH13 8PX Horsham
    West Sussex
    EnglandBritishManaging Director63563610001
    JENNINGS, Michael Anthony
    Longmead Littleworth
    Partridge Green
    RH13 8JU West Sussex
    Amministratore
    Longmead Littleworth
    Partridge Green
    RH13 8JU West Sussex
    BritishBuilding Society Executive53387850001
    KINNOULL, Arthur William George Patrick Hay, Earl Of Kinnoull
    15 Carlyle Square
    SW3 6EX London
    Amministratore
    15 Carlyle Square
    SW3 6EX London
    United KingdomBritishChartered Surveyor39211800001
    RODDY, Julie
    G2.02
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Floor 24
    England
    Amministratore
    G2.02
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Floor 24
    England
    United KingdomAmericanDirector Of Retail Operations161012820001
    ROSE, Andrea
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritishOperations Director124649530001
    STONE, Stephen
    10 Petresfield Way
    West Horndon
    CM13 3TG Brentwood
    Essex
    Amministratore
    10 Petresfield Way
    West Horndon
    CM13 3TG Brentwood
    Essex
    BritishChartered Architect44699490001
    WILLIAMS, Jayne, Director Of Product Operations
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Amministratore
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritishBanker229421510001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Drive
    Great Warley
    CM13 3AT Brentwood
    Countryside House
    England
    06 apr 2016
    The Drive
    Great Warley
    CM13 3AT Brentwood
    Countryside House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom (England And Wales)
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00614864
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    06 apr 2016
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom (England And Wales)
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02093573
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.

    WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of substituted security
    Creato il 25 giu 1996
    Consegnato il 15 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the legal charge dated 30TH november 1994
    Brevi particolari
    Land edged red on the plan (as defined in the deed of substituted security) on the west side of quarry hill road tonbridge and malling kent (substituted in place of the land edged green on the same plan).
    Persone aventi diritto
    • Woolwich Homes Limited
    Transazioni
    • 15 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 01 mag 1995
    Consegnato il 05 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 4 of this charge and clause 2 of the original charge dated 6 may 1994 including the proceeds of any insurance of the charged property
    Brevi particolari
    All that f/h land known as white lodge cottage, biggin hill, upper norwood, london t/n SGL29985.
    Persone aventi diritto
    • Woolwich Homes Limited
    Transazioni
    • 05 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 05 apr 1995
    Consegnato il 26 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 2 of the charge
    Brevi particolari
    All that f/h land known as heatherlands house, 184 forest road, tunbridge wells, kent.
    Persone aventi diritto
    • Woolwich Homes Limited
    Transazioni
    • 26 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 feb 1995
    Consegnato il 01 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the charge including the proceeds of any insurance of the charged property under the terms of the original legal charge dated 6 may 1994
    Brevi particolari
    All that f/h land known as white lodge cottage, biggin hill, upper norwood, london SE19 t/n SGL29985.
    Persone aventi diritto
    • Woolwich Homes Limited
    Transazioni
    • 01 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 1994
    Consegnato il 07 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on the terms set out in a facility letter and loan agreement of even date
    Brevi particolari
    All that f/h land at fosse bank school quarry hill tonbridge kent.
    Persone aventi diritto
    • Woolwich Homes Limited
    Transazioni
    • 07 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 set 1994
    Consegnato il 11 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 2 of the charge
    Brevi particolari
    F/H land at stoughton barracks guildford part of t/n SY643473 including the proceeds of any insurance of the charged property.
    Persone aventi diritto
    • Woolwich Homes Limited
    Transazioni
    • 11 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 22 set 1994
    Consegnato il 10 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 2 of the legal charge
    Brevi particolari
    Land k/a addlestead works tonbridge road east peckham kent and any proceeds of any insurance of the property.
    Persone aventi diritto
    • Woolwich Homes Limited
    Transazioni
    • 10 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 06 mag 1994
    Consegnato il 24 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement or in connection with any facility granted
    Brevi particolari
    The f/h land at dickens wood biggin hill upper norwood london SE19.
    Persone aventi diritto
    • Woolwich Homes Limited
    Transazioni
    • 24 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 07 apr 1994
    Consegnato il 09 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H land at chepstow close,worth,crawley,west sussex.
    Persone aventi diritto
    • Woolwich Homes Limited
    Transazioni
    • 09 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 31 mar 1994
    Consegnato il 19 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement of even date
    Brevi particolari
    Area HA2 south ockendon hospital south ockendon essex.
    Persone aventi diritto
    • Woolwich Homes Limited
    Transazioni
    • 19 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 1993
    Consegnato il 08 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at kings hill west malling kent.
    Persone aventi diritto
    • Woolwich Homes Limited
    Transazioni
    • 08 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge
    Creato il 01 feb 1993
    Consegnato il 02 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date.
    Brevi particolari
    Land at townley road bexleyheath kent.
    Persone aventi diritto
    • Woolwich Homes Limited
    Transazioni
    • 02 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 18 nov 1992
    Consegnato il 27 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the legal charge.
    Brevi particolari
    F/H land at high road loughton essex.
    Persone aventi diritto
    • Woolwich Homes Limited
    Transazioni
    • 27 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 18 set 1992
    Consegnato il 25 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date
    Brevi particolari
    Land at mayflower hospital on the north side of mountnessing road billericay,essex.t/no.ex 465301.
    Persone aventi diritto
    • Woolwich Homes Limited
    Transazioni
    • 25 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 apr 2021Data di scioglimento
    07 mar 2018Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0