WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED
Panoramica
Nome della società | WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02442706 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 15 Canada Square E14 5GL London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CHOQS 186 LIMITED | 14 nov 1989 | 14 nov 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 8 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 mar 2020 | 8 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 mar 2019 | 7 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Countryside House the Drive Brentwood Essex CM13 3AT a 15 Canada Square London E14 5GL in data 04 apr 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Gary Neville Whitaker come amministratore in data 01 ott 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Stephen Cherry come amministratore in data 30 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 mar 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2015 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Martin Clift come amministratore in data 03 ago 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jayne Williams come amministratore in data 15 giu 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Richard Stephen Cherry il 23 set 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2013 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Jayne Williams come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Karen Connell come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 14 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARREN, Tracy Marina | Segretario | Hollow Road Felsted CM6 3JF Dunmow The Molehill Essex United Kingdom | British | 132463120001 | ||||||
CLIFT, Martin | Amministratore | Global Avenue LS11 8AN Leeds Millshaw Court England | England | British | Banker | 199928630001 | ||||
WHITAKER, Gary Neville | Amministratore | Canada Square E14 5GL London 15 | England | British | General Counsel | 238965410001 | ||||
HOYLES, Robin Patrick | Segretario | 12 Springpark Drive BR3 6QD Beckenham Kent | British | 34860250001 | ||||||
PEARCE, Michael Frank | Segretario | Ashdale 18 Longaford Way Hutton Mount CM13 2LT Brentwood Essex | British | 33032910001 | ||||||
SHILLINGLAW, Gary Preston | Segretario | Wynsdale 9 Monkshanger GU9 8BU Farnham Surrey | British | 66825690001 | ||||||
BAKER, Trevor | Amministratore | 14 Bickmore Way TN9 1ND Tonbridge Kent | British | Managing Director | 26767780002 | |||||
CHERRY, Alan Herbert | Amministratore | Harvesters Green Street Fryerning CM4 ONS Ingatestone Essex | England | British | Chartered Surveyor | 2026150001 | ||||
CHERRY, Richard Stephen | Amministratore | Countryside House The Drive Brentwood CM13 3AT Essex | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 68733260003 | ||||
CLEMINSON, Harold John | Amministratore | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | Managing Director | 43598530003 | |||||
CLEMINSON, Harold John | Amministratore | 7 All Saints Road TN4 9JF Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | House Building | 43598530001 | ||||
CONNELL, Karen Michelle | Amministratore | Global Avenue LS11 8DD Leeds Millshaw Court England | England | British | Banker | 179412850001 | ||||
CROOK, Christopher Peter | Amministratore | 7 Lynton Road Thorpe Bay SS1 3BE Essex | British | Chartered Surveyor | 46724000001 | |||||
CUMMING, John Alan | Amministratore | 8 Prince Consort Drive BR7 5SB Chislehurst Kent | British | Company Director | 22511900001 | |||||
DEEPROSE, Richard William Griffith | Amministratore | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | Managing Director Ekins | 62807120004 | |||||
DUNLOP, Roger Napier | Amministratore | Setherum House Benham Park Marsh Benham RG20 8LX Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 68979710001 | ||||
GALLAGHER, Mark | Amministratore | 21 Cromwell Lane CM9 4LB Maldon Essex | England | British | Chartered Surveyor | 3110930001 | ||||
GROOM, Richard John | Amministratore | Broomers Cottage Broomers Corner, Shipley RH13 8PX Horsham West Sussex | England | British | Managing Director | 63563610001 | ||||
JENNINGS, Michael Anthony | Amministratore | Longmead Littleworth Partridge Green RH13 8JU West Sussex | British | Building Society Executive | 53387850001 | |||||
KINNOULL, Arthur William George Patrick Hay, Earl Of Kinnoull | Amministratore | 15 Carlyle Square SW3 6EX London | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 39211800001 | ||||
RODDY, Julie | Amministratore | G2.02 1 Churchill Place E14 5HP London Floor 24 England | United Kingdom | American | Director Of Retail Operations | 161012820001 | ||||
ROSE, Andrea | Amministratore | 1 Churchill Place E14 5HP London | England | British | Operations Director | 124649530001 | ||||
STONE, Stephen | Amministratore | 10 Petresfield Way West Horndon CM13 3TG Brentwood Essex | British | Chartered Architect | 44699490001 | |||||
WILLIAMS, Jayne, Director Of Product Operations | Amministratore | Churchill Place E14 5HP London 1 England | England | British | Banker | 229421510001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Countryside Properties (Uk) Limited | 06 apr 2016 | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Woolwich Homes Limited | 06 apr 2016 | Churchill Place E14 5HP London 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Deed of substituted security | Creato il 25 giu 1996 Consegnato il 15 lug 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the legal charge dated 30TH november 1994 | |
Brevi particolari Land edged red on the plan (as defined in the deed of substituted security) on the west side of quarry hill road tonbridge and malling kent (substituted in place of the land edged green on the same plan). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 01 mag 1995 Consegnato il 05 mag 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 4 of this charge and clause 2 of the original charge dated 6 may 1994 including the proceeds of any insurance of the charged property | |
Brevi particolari All that f/h land known as white lodge cottage, biggin hill, upper norwood, london t/n SGL29985. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 05 apr 1995 Consegnato il 26 apr 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 2 of the charge | |
Brevi particolari All that f/h land known as heatherlands house, 184 forest road, tunbridge wells, kent. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 14 feb 1995 Consegnato il 01 mar 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the charge including the proceeds of any insurance of the charged property under the terms of the original legal charge dated 6 may 1994 | |
Brevi particolari All that f/h land known as white lodge cottage, biggin hill, upper norwood, london SE19 t/n SGL29985. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 30 nov 1994 Consegnato il 07 dic 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on the terms set out in a facility letter and loan agreement of even date | |
Brevi particolari All that f/h land at fosse bank school quarry hill tonbridge kent. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 29 set 1994 Consegnato il 11 ott 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 2 of the charge | |
Brevi particolari F/H land at stoughton barracks guildford part of t/n SY643473 including the proceeds of any insurance of the charged property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 22 set 1994 Consegnato il 10 ott 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 2 of the legal charge | |
Brevi particolari Land k/a addlestead works tonbridge road east peckham kent and any proceeds of any insurance of the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 06 mag 1994 Consegnato il 24 mag 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement or in connection with any facility granted | |
Brevi particolari The f/h land at dickens wood biggin hill upper norwood london SE19. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 07 apr 1994 Consegnato il 09 apr 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari F/H land at chepstow close,worth,crawley,west sussex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 31 mar 1994 Consegnato il 19 apr 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement of even date | |
Brevi particolari Area HA2 south ockendon hospital south ockendon essex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 30 nov 1993 Consegnato il 08 dic 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land at kings hill west malling kent. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 01 feb 1993 Consegnato il 02 feb 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date. | |
Brevi particolari Land at townley road bexleyheath kent. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 18 nov 1992 Consegnato il 27 nov 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the legal charge. | |
Brevi particolari F/H land at high road loughton essex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 18 set 1992 Consegnato il 25 set 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date | |
Brevi particolari Land at mayflower hospital on the north side of mountnessing road billericay,essex.t/no.ex 465301. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
WOOLWICH COUNTRYSIDE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0