AMEY BUILDING LIMITED
Panoramica
| Nome della società | AMEY BUILDING LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02444100 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di AMEY BUILDING LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
- Attività di amministrazione pubblica generale (84110) / Amministrazione pubblica e difesa; previdenza sociale obbligatoria
Dove si trova AMEY BUILDING LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di AMEY BUILDING LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| AMEY-FARR LIMITED | 04 gen 1991 | 04 gen 1991 |
| AMEY BUILDING LIMITED | 02 feb 1990 | 02 feb 1990 |
| INTERCEDE 757 LIMITED | 17 nov 1989 | 17 nov 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di AMEY BUILDING LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per AMEY BUILDING LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Amey Plc come persona con controllo significativo il 21 nov 2022 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Latham Nelson il 25 nov 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Birch il 16 gen 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr Paul Birch come amministratore in data 15 gen 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Lee Milner come amministratore in data 12 dic 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Sherard Secretariat Services Limited il 02 set 2019 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da The Sherard Building Edmund Halley Road Oxford OX4 4DQ a Chancery Exchange 10 Furnival Street London EC4A 1AB in data 02 set 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Amey Plc come persona con controllo significativo il 02 set 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una societ à dormiente redatto al 31 dic 2017 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di AMEY BUILDING LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Segretario | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom |
| 109588620001 | ||||||||||
| BIRCH, Paul | Amministratore | 142 Speke Road L19 2PH Liverpool The Matchworks England England | United Kingdom | British | 76116640004 | |||||||||
| NELSON, Andrew Latham | Amministratore | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London Amey United Kingdom | England | British | 36191090004 | |||||||||
| HUI, Carol | Segretario | GU8 | British | 72371980001 | ||||||||||
| MANTZ, Ann Elizabeth | Segretario | 21 Four Wents KT11 2NE Cobham Surrey | British | 37441550001 | ||||||||||
| TETLOW, John Richard | Segretario | Whittaker Court, Gawsworth New Hall Church Lane, Gawsworth SK11 9RQ Macclesfield Cheshire | British | 68445840001 | ||||||||||
| ADCOCK, Roger Brian | Amministratore | 20 Peter Avenue RH8 9LG Oxted Surrey | England | British | 8738440001 | |||||||||
| ARBUCKLE, John Robert | Amministratore | 2 The Stables Chalke Pyt Broad Chalke SP5 5ET Salisbury Wiltshire | British | 116444950001 | ||||||||||
| ASHLEY, Neil | Amministratore | Burcot Grange Burcot OX14 3DJ Abingdon Oxfordshire | United Kingdom | British | 14069580001 | |||||||||
| BAXTER, Paul | Amministratore | Badgers Sett 16 Bilstone Road CV9 3PP Little Twycross Warwickshire | British | 82266440001 | ||||||||||
| BUTTERS, Nigel Carl | Amministratore | 65 Mount Felix Rivermount KT12 2PJ Walton On Thames Surrey | British | 46089540002 | ||||||||||
| CAWTHORNE, David Alwyn | Amministratore | 21 Park Road RH8 0AN Oxted Surrey | British | 12217320001 | ||||||||||
| COX, Colin Douglas | Amministratore | Dolphin House 13 Wensley Gardens PO10 7RA Emsworth Hampshire | British | 29164670001 | ||||||||||
| DOUGLAS, Richard Colin | Amministratore | Field House 26 Abingdon Road Dorchester On Thames OX10 7JY Wallingford Oxfordshire | British | 14069590002 | ||||||||||
| ENTWISTLE, Richard William | Amministratore | Crossways Crays Pond RG8 7QE Goring Heath Oxfordshire | British | 50174710001 | ||||||||||
| EVELYN-WOOD, Mark William | Amministratore | Holly Lodge 4 Sparrowhawk Close Ewshot GU10 5TJ Farnham Surrey | England | English | 13880480002 | |||||||||
| EWELL, Melvyn | Amministratore | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | England | British | 61515760002 | |||||||||
| HINDLE, David Wilson | Amministratore | Two Ways MK43 8SQ Stagsden Beds | British | 2312780001 | ||||||||||
| HYND, Peter | Amministratore | The Old Hall Sandfield Park L12 Liverpool Merseyside | British | 15266180001 | ||||||||||
| JOHNSON, Peter James | Amministratore | 7 Hall Lane Lydiate L31 4HN Liverpool | England | British | 46649010001 | |||||||||
| KAYSER, Michael Arthur | Amministratore | 17 Hartsbourne Avenue WD23 1JP Bushey Heath Hertfordshire | United Kingdom | British | 141893610001 | |||||||||
| KING, Edmund Alec | Amministratore | Spindlewood Pangbourne Hill RG8 8JS Pangbourne Berkshire | British | 13705700001 | ||||||||||
| LEO, Jose | Amministratore | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | Spanish | 93348510004 | ||||||||||
| LUCAS, William Anthony | Amministratore | Tanglewood Park Close Wilmcote CV37 9XE Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 27693460001 | ||||||||||
| LYNCH, Peter Anthony | Amministratore | Ar-Y-Mynydd Piccadilly Llanblethian CF7 7JL Cowbridge South Glamorgan | British | 29164680001 | ||||||||||
| MILLER, David John | Amministratore | 1 Asmara Road NW2 3SS London | United Kingdom | British | 152304230002 | |||||||||
| MILNER, Andrew Lee | Amministratore | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building England | England | British | 133714170002 | |||||||||
| MOGG, Charles Michael | Amministratore | Ladywood Stray Church Road, Wilmcote CV37 9XD Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 87961010001 | ||||||||||
| OSBORNE, Robert Charles | Amministratore | Heath View Bromstead Common TF10 9DG Newport Shropshire | British | 68448420001 | ||||||||||
| PEAT, Martin John | Amministratore | 35 Augusta Avenue Collingtree Park NN4 0XP Northampton Northamptonshire | British | 81709330001 | ||||||||||
| PENYCATE, Christopher John | Amministratore | Sashcu 156 Bullbrook Drive RG12 2QT Bracknell Berkshire | British | 2312770002 | ||||||||||
| PILBEAM, Michael | Amministratore | Sloping Acre Lockeridge SN8 4ED Marlborough Wiltshire | British | 38883200001 | ||||||||||
| STAPLES, Brian Lynn | Amministratore | Pendle House Castle Hill Prestbury SK10 4AR Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 55479560003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di AMEY BUILDING LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amey Limited | 06 apr 2016 | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
AMEY BUILDING LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating security document | Creato il 14 mar 2003 Consegnato il 26 mar 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rental deposit deed | Creato il 11 mag 1998 Consegnato il 13 mag 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £15,000 and all other monies due from the company to the chargee under the terms of the lease and this deed | |
Brevi particolari Rental deposit of £15,000 pursuant to the terms of a lease of even date. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge and assignment | Creato il 27 set 1995 Consegnato il 04 ott 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of charge the benefit of the agreement dated 24TH february 1995 and by way of assignment all monies due or owing due to the company under or by virtue of the agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge and assignment | Creato il 27 set 1995 Consegnato il 04 ott 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of fixed charge the benefit of an agreement dated 24TH february 1995 relating to land at milton cambridge cambridgeshire and by way of assignment all moneys owing to the company under or by virtue of the agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Creato il 08 mar 1994 Consegnato il 23 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Details of charged account(s) barclays bank PLC re amey building limited business premium account number 80167568. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0