DAIRY CREST FOOD INGREDIENTS LIMITED
Panoramica
Nome della società | DAIRY CREST FOOD INGREDIENTS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02448298 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DAIRY CREST FOOD INGREDIENTS LIMITED?
- Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. (10890) / Industrie manifatturiere
Dove si trova DAIRY CREST FOOD INGREDIENTS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 5 The Heights Brooklands KT13 0NY Weybridge Surrey England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DAIRY CREST FOOD INGREDIENTS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
FOODTEC UK LIMITED | 23 lug 2014 | 23 lug 2014 |
DAIRY CREST FOOD INGREDIENTS LIMITED | 23 lug 2014 | 23 lug 2014 |
FOODTEC UK LIMITED | 31 lug 2013 | 31 lug 2013 |
FAYREFIELD-FOODTEC LIMITED | 31 dic 1994 | 31 dic 1994 |
FAYREFIELD INGREDIENTS LIMITED | 23 ago 1994 | 23 ago 1994 |
DAIRY & FOOD (U.K.) LIMITED | 18 gen 1990 | 18 gen 1990 |
RIVALRIDER LIMITED | 30 nov 1989 | 30 nov 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DAIRY CREST FOOD INGREDIENTS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per DAIRY CREST FOOD INGREDIENTS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Thomas Alexander Atherton il 13 ago 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Thomas Alexander Atherton il 03 mar 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 24 feb 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2019 | 15 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 nov 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Thomas Alexander Atherton il 19 apr 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Claygate House Littleworth Road Esher Surrey KT10 9PN a 5 the Heights Brooklands Weybridge Surrey KT13 0NY in data 07 mag 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Maxime Therrien come amministratore in data 15 apr 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 nov 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2018 | 15 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 nov 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2017 | 13 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 17 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2015 | 18 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mrs Isobel Jean Hinton come segretario in data 23 dic 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Richard James Adamson come amministratore in data 23 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di DAIRY CREST FOOD INGREDIENTS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HINTON, Isobel Jean | Segretario | Brooklands KT13 0NY Weybridge 5 The Heights Surrey England | 203739960001 | |||||||
ATHERTON, Thomas Alexander | Amministratore | Brooklands KT13 0NY Weybridge 5 The Heights Surrey England | England | British | Chartered Accountant | 80898120007 | ||||
HINDS, Antony Trevor | Amministratore | Brooklands KT13 0NY Weybridge 5 The Heights Surrey England | United Kingdom | British | Finance Director | 161273050001 | ||||
THERRIEN, Maxime | Amministratore | Brooklands KT13 0NY Weybridge 5 The Heights Surrey England | Canada | Canadian | Chief Financial Officer And Secretary | 257550170001 | ||||
BEECH, Sydney John | Segretario | 8 Woodland Avenue CW5 6JE Nantwich Cheshire | British | Chartered Accountant | 74718120001 | |||||
FRY, Sasha Deanne | Segretario | Littleworth Road KT10 9PN Esher Claygate House Surrey United Kingdom | 170229700001 | |||||||
MANSON, Kevin Edward | Segretario | 1 Knebworth Court Mossley Congleton Cheshire Cw12 3sw | British | 68208630001 | ||||||
MONEY, Andrew | Segretario | Littleworth Road KT10 9PN Esher Claygate House Surrey United Kingdom | British | Solicitor | 139443850001 | |||||
SADLER, James | Segretario | Bromfield 11 Chester Avenue SY13 1NE Whitchurch Salop | British | 8741770001 | ||||||
SADLER, James | Segretario | Bromfield 11 Chester Avenue SY13 1NE Whitchurch Salop | British | 8741770001 | ||||||
ADAMSON, Richard James | Amministratore | Littleworth Road KT10 9PN Esher Claygate House Surrey United Kingdom | England | British | Manufacturing Director | 165448270001 | ||||
ALLMAN, David Malcolm | Amministratore | 17 Collinbrook Avenue CW2 6PN Crewe Cheshire | England | British | Financial Director | 44773580001 | ||||
BEECH, Sydney John | Amministratore | 8 Woodland Avenue CW5 6JE Nantwich Cheshire | United Kingdom | British | Group Financial Director | 74718120001 | ||||
BRINSMEAD, Toby John | Amministratore | Littleworth Road KT10 9PN Esher Claygate House Surrey United Kingdom | England | British | Company Director | 141000110001 | ||||
CLARK, Paul | Amministratore | 50 Oakley Road Bromham MK43 8HZ Bedford | British | Director | 53057720001 | |||||
DIXON, Irene Mary | Amministratore | Littleworth Road KT10 9PN Esher Claygate House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 89453630001 | ||||
DIXON, Irene Mary | Amministratore | 48 Fuller Drive Wistaston CW2 6TH Crewe Cheshire | United Kingdom | British | Accountant | 89453630001 | ||||
FORRESTER, Michael George | Amministratore | East Meadows Nash SY8 3DQ Ludlow Salop | United Kingdom | British | Director | 19608690004 | ||||
HAWTHORN, Richard David | Amministratore | Littleworth Road KT10 9PN Esher Claygate House Surrey United Kingdom | England | British | Director | 206827970001 | ||||
HILTON, Nicholas Anthony | Amministratore | Paddock Cottage Hollin Green Lane Burland CW5 8NL Nantwich Cheshire | United Kingdom | British | Sales Executive | 20488590001 | ||||
JACOBS, Hendrikus Hubertus | Amministratore | Neustift Am Walde FOREIGN Vienna 59a A - 1190 Austria | Dutch | General Manager | 22415480001 | |||||
KERR, John Douglas | Amministratore | Hilderstone Main Road Worleston CW5 6DN Nantwich Cheshire | England | British | Dairy Products Executive | 6677310001 | ||||
KUHL, Rolf | Amministratore | Kamper Weg Kaltenkirchen 7b D-2358 Germany | German | General Manager | 22415490001 | |||||
LOW, Alison May | Amministratore | Littleworth Road KT10 9PN Esher Claygate House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Supply Chain Director | 141008070001 | ||||
MANSON, Kevin Edward | Amministratore | 1 Knebworth Court Mossley Congleton Cheshire Cw12 3sw | British | Director | 68208630001 | |||||
PATIENT, James Frederick | Amministratore | Violet Cottage 69-71 Buxton Old Road, Disley SK12 2DQ Stockport Cheshire | British | Purchasing Manager | 78965280001 | |||||
PHILLIPS, Roger Geoffrey | Amministratore | The Henblas Poole Mouth Road Highfield LL11 4UR Wrexham | British | Director | 98714240001 | |||||
PRIEST, Leslie | Amministratore | Woodstock Newcastle Road CW3 9SN Woore Shropshire | British | Dairy Trader | 22415500002 | |||||
REEVES, Arthur John | Amministratore | Littleworth Road KT10 9PN Esher Claygate House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Milk Buyer | 21809350001 | ||||
RIDYARD, Timothy James | Amministratore | Bottle Lodge Old Park Road Crew Green CW1 5UE Crewe Cheshire | British | Director | 62381080003 | |||||
RIMMER, David Bernard | Amministratore | Littleworth Road KT10 9PN Esher Claygate House Surrey United Kingdom | Wales | British | Managing Director | 196848030001 | ||||
ROBINSON, Timothy Marcus | Amministratore | Salesbrook Manor Salesbrook Aston CW5 8DR Nantwich Cheshire | England | British | Dairy Products Executive | 40696220003 | ||||
ROBOTHAM, Roger James | Amministratore | Littleworth Road KT10 9PN Esher Claygate House Surrey United Kingdom | England | British | Accountant | 55210710001 | ||||
SADLER, James | Amministratore | Bromfield 11 Chester Avenue SY13 1NE Whitchurch Salop | British | Chartered Accountant | 8741770001 | |||||
TIMMS, Stephen Bryan | Amministratore | Littleworth Road KT10 9PN Esher Claygate House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Sales Director | 141007970001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di DAIRY CREST FOOD INGREDIENTS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dairy Crest Limited | 06 apr 2016 | Littleworth Road KT10 9PN Esher Claygate House Surrey England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
DAIRY CREST FOOD INGREDIENTS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 18 lug 1990 Consegnato il 07 ago 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0