TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED

TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02449641
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HORNGLADE PROJECTS LIMITED14 ago 199014 ago 1990
    PROPERTY DEVELOPMENT PROJECT LIMITED29 dic 198929 dic 1989
    HARLACRE LIMITED05 dic 198905 dic 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Nomina di Mr Stephen Derrick Breach come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Simon Lawton come amministratore

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter John Martin il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Marcus Lawton il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Richard Hawke Collins il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    11 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine225

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    17 pagineAA

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine353a

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    9 pagine395

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COLLINS, Richard Hawke
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Segretario
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    British53398040001
    BREACH, Stephen Derrick
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Amministratore
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    United KingdomBritish147928530001
    MARTIN, Peter John
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Amministratore
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    EnglandBritish176044430001
    BLANKS, Gareth John Ryder
    Little Sir Hughes
    West Hanningfield Road Great Baddow
    CM2 7SZ Chelmsford
    Essex
    Segretario
    Little Sir Hughes
    West Hanningfield Road Great Baddow
    CM2 7SZ Chelmsford
    Essex
    British89781940001
    CANNINGS, Colin Graham
    20 Red Lion Street
    WC1R 4PS London
    Segretario
    20 Red Lion Street
    WC1R 4PS London
    British4936580001
    LAWTON, Simon Marcus
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    British68807890004
    APPLEBY, Robert
    8 Stevenson Way
    Larkfield
    ME20 6UN Aylesford
    Kent
    Amministratore
    8 Stevenson Way
    Larkfield
    ME20 6UN Aylesford
    Kent
    British100449850001
    BLANKS, Gareth John Ryder
    Little Sir Hughes
    West Hanningfield Road Great Baddow
    CM2 7SZ Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Little Sir Hughes
    West Hanningfield Road Great Baddow
    CM2 7SZ Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish89781940001
    DICKS, Steven Trevor
    60 Penningtons
    CM23 4LF Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    60 Penningtons
    CM23 4LF Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    British72561270001
    GRANGER, Adam
    1 Wormbwell Gardens
    DA11 8BL Northfleet
    Kent
    Amministratore
    1 Wormbwell Gardens
    DA11 8BL Northfleet
    Kent
    EnglandBritish97482630002
    JENKINS, David Charles
    12 Queens Road
    SS7 1JW Benfleet
    Essex
    Amministratore
    12 Queens Road
    SS7 1JW Benfleet
    Essex
    British13763330002
    LAWTON, Simon Marcus
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Amministratore
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    EnglandBritish68807890004
    NEILSON, Lindsay Stewart
    Ash House
    Ash Road New Ash Green
    DA3 8JD Longfield
    Kent
    Amministratore
    Ash House
    Ash Road New Ash Green
    DA3 8JD Longfield
    Kent
    British60819520001
    PITMAN, Henry John
    Pinbury Park
    Duntisbourne Rouse
    GL7 7LG Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Pinbury Park
    Duntisbourne Rouse
    GL7 7LG Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritish55231490005
    TODMAN, Andrew William
    4 St Marys Close
    Laddingford
    ME18 6DG Maidstone
    Kent
    Amministratore
    4 St Marys Close
    Laddingford
    ME18 6DG Maidstone
    Kent
    UkBritish115840330001

    TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 14 giu 2007
    Consegnato il 21 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each group company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 21 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee and debenture
    Creato il 17 ott 2002
    Consegnato il 23 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 24 apr 2002
    Consegnato il 30 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Each of the Financeparties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 30 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee and debenture between the company (1) and the south place gresham partnership 2000 as trustee for itself and the noteholders ("trustee") (2)
    Creato il 14 dic 2000
    Consegnato il 28 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due, owing or incurred in whatever manner by the principal (as defined) to any noteholder (as defined) under or in respect of any designated loan note or any other secured party (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The South Place Gresham Partnership 2000
    Transazioni
    • 28 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 dic 2000
    Consegnato il 22 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 31 mag 1995
    Consegnato il 12 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 12 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0