WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED

WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02454379
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Wigmore Street
    London
    W1U 1PB
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DE FACTO 174 LIMITED20 dic 198920 dic 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 ott 2013

    Stato del capitale al 10 ott 2013

    • Capitale: GBP 15,000,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2011

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2010

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    18 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Maurice Moses Benady il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher George White il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    18 pagineAA

    legacy

    10 pagine395

    legacy

    1 pagine403b

    legacy

    1 pagine403b

    legacy

    9 pagine395

    legacy

    6 pagine395

    Chi sono gli amministratori di WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Segretario
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Amministratore
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57-63
    Amministratore
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57-63
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    135415010001
    AUTY, Kenneth Ian
    10 Wendron Way
    Idle
    BD10 8TW Bradford
    West Yorkshire
    Segretario
    10 Wendron Way
    Idle
    BD10 8TW Bradford
    West Yorkshire
    British50948540001
    DOWNES, Jane Claire
    3 Oakleigh View
    Baildon
    BD17 5TP Shipley
    West Yorkshire
    Segretario
    3 Oakleigh View
    Baildon
    BD17 5TP Shipley
    West Yorkshire
    British48088850001
    DOWNES, Jane Claire
    3 Oakleigh View
    Baildon
    BD17 5TP Shipley
    West Yorkshire
    Segretario
    3 Oakleigh View
    Baildon
    BD17 5TP Shipley
    West Yorkshire
    British48088850001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Segretario
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    Segretario
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Segretario
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    PLIMLEY, Martin Wilfred
    The Bungalow Oakwood Grove
    LS8 2PA Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    The Bungalow Oakwood Grove
    LS8 2PA Leeds
    West Yorkshire
    British58693940001
    BATTY, Malcolm Child
    20 Old Hall Road
    WF17 0AX Batley
    West Yorkshire
    Amministratore
    20 Old Hall Road
    WF17 0AX Batley
    West Yorkshire
    British30753710001
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BEST, George Laidler
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    British2748600001
    BRIMBLECOMBE, David John
    2 Kirklees Close
    Farsley
    LS28 5TF Leeds
    Amministratore
    2 Kirklees Close
    Farsley
    LS28 5TF Leeds
    British51190580001
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    HARROWSMITH, John Anthony
    Plum Tree Cottage
    Low Way Bramham
    LS23 6QT Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Plum Tree Cottage
    Low Way Bramham
    LS23 6QT Wetherby
    West Yorkshire
    British62531490001
    HELLIWELL, David Alistair
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish15578740001
    HOPE, Mark Nicholas John
    Kingsley 48 Green Lane
    HG2 9LP Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Kingsley 48 Green Lane
    HG2 9LP Harrogate
    North Yorkshire
    British48039200002
    JONES, Gordon Pearce, Sir
    Bryngower Sitwell Grove
    S60 3AY Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    Bryngower Sitwell Grove
    S60 3AY Rotherham
    South Yorkshire
    British2677770001
    KNIGHT, Ian Graham
    92 Town Lane
    Thackley
    BD10 8PJ Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    92 Town Lane
    Thackley
    BD10 8PJ Bradford
    West Yorkshire
    British36849090002
    KNIGHT, Ian Graham
    3 Harehill Close
    Thackley
    BD10 8PG Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    3 Harehill Close
    Thackley
    BD10 8PG Bradford
    West Yorkshire
    British36849090001
    LEAVESLEY, James David
    Needwood House
    Needwood
    DE13 9PQ Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Needwood House
    Needwood
    DE13 9PQ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish22565050001
    MCKENDRICK, Charles
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    Amministratore
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish173983190001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Amministratore
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritish58693930003
    NEWMAN, James Henry
    Smithy Cottage Newton Kyme
    LS29 9LS Tadcaster
    North Yorkshire
    Amministratore
    Smithy Cottage Newton Kyme
    LS29 9LS Tadcaster
    North Yorkshire
    British6036000006
    NEWTON, Trevor
    Upper Park House
    5 Park House Road Low Moor
    BD12 0QB Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Upper Park House
    5 Park House Road Low Moor
    BD12 0QB Bradford
    West Yorkshire
    British53363050001
    SMITHIES, James Marchant
    109 Marsh Lane
    Shepley
    HD8 8AS Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    109 Marsh Lane
    Shepley
    HD8 8AS Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish37603190001
    SYERS, Alan Matthew
    135 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO23 3TE York
    North Yorkshire
    Amministratore
    135 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO23 3TE York
    North Yorkshire
    EnglandBritish65588650002
    TURNER, Philip Arthur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    British66424440001
    WILSON, Brian Joseph
    5 Fern Way
    Scarcroft
    LS14 3JJ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 Fern Way
    Scarcroft
    LS14 3JJ Leeds
    West Yorkshire
    British13236280002

    WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental security agreement
    Creato il 19 feb 2009
    Consegnato il 25 feb 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Units 17A and 17B of that property k/a follingsby park gateshead t/no TY367999 (part thereof). See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Ag, London Branch as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 25 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Tenth supplemental trust deed
    Creato il 24 dic 2008
    Consegnato il 07 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 and all moneys due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a units 17A and 17B follingsby park, gateshead t/no TY367999 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transazioni
    • 07 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    A security agreement
    Creato il 24 dic 2008
    Consegnato il 07 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Units 17A and 17B follingsby park, gateshead t/no TY367999 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Ag, London Branch
    Transazioni
    • 07 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security agreement
    Creato il 19 set 2007
    Consegnato il 26 set 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Ag,London Branch
    Transazioni
    • 26 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Ninth supplemental trust deed
    Creato il 15 mar 2007
    Consegnato il 03 apr 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Property known as unit 1, follingsby park, follingsby avenue, follingsby park, gateshead t/no TY344000; property known as unit 2 follingsby park, follingsby avenue, gateshead t/no TY306533. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 03 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenturedated 27 may 1999
    Creato il 17 gen 2002
    Consegnato il 02 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from the obligors or any of them to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (I) f/hol lnd and buildings known as unit 6A follingsby park,follingsby ave,wardley; t/no ty 344006; (ii) f/hold land/blds known as units 1,1A and 14 follingsby par,follingsby ave,wardley; ty 344000; plus other properties listed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC,as Security Agent for Itself and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 02 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession (supplemental to a composite guaranteeand mortgage debenture dated 27 may 1999)
    Creato il 12 gen 2001
    Consegnato il 25 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (or any of them) and/or on any account whatsoever (terms as defined)
    Brevi particolari
    Freehold and leasehold and and buildings at york business park nether poppletontitle number(s) NYK72823 NYK72824 NYK87325 NYK67562 NYK59785 NYK85871 NYK70416 NYK176559 freehold land and buildings atfollingsby park gateshead title number TY306533 freehold land and buildings at follingsby lane gateshead title number(s)all its right title and interest in andto the leases,the insurances, the assigned documents,the receivables account and any monies and rental income. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself Andthe Beneficiaries
    Transazioni
    • 25 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 27 mar 1997
    Consegnato il 08 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal mortgage over f/h land and buildings on the north east side of millfield lane nether poppleton york title number NYK59785, land at ings lane millfield nether poppleton york title number NYK85871, land lying to the south of A1237, nether poppleton york title number NYK70416, land lying to the north east of millfield lane nether poppleton york title number NYK176559, land at poppleton ings york title number NYK72823, land at skelton junction millfield lane nether poppleton york title number NYK72824, l/h land at skelton junction millfield lane york title number NYK87325 land on the south east of ings lane millfield nether poppleton york title number NYK67562 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 27 mar 1997
    Consegnato il 08 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal mortgage over the freehold land lying to the north side of follingsby lane wardley gateshead title number TY306533 and the freehold land lying to the north of follingsby lane pelaw gateshead title number TY243775 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 mar 1997
    Consegnato il 08 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 mar 1996
    Consegnato il 14 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H land comprising 11.4 acres or thereabouts and situate at nether poppleton north yorkshire t/no:- NYK17615 and fixed and floating charge over all assets of the company.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Water Estates Limited
    Transazioni
    • 14 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 feb 1996
    Consegnato il 15 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever (excepting the existing subordinated loan of £615,000 advanced on 1ST february 1993)
    Brevi particolari
    Land/blds lying to the north of follingsby lane,pelaw gateshead in the county of tyne and wear; t/no ty 243775.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Water Estates Limited
    Transazioni
    • 15 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 dic 1995
    Consegnato il 15 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the legal charge
    Brevi particolari
    1. freehold land at poppleton ings york title number nyk 72823 2. freehold land lying to the south of A1237 nether poppleton york title number nyk 70416. 3. freehold land at skelton junction millfield lane nether poppleton york and those other properties detailed on the form M395 and a fixed and floating charge over all the assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Water Estates Limited
    Transazioni
    • 15 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 1995
    Consegnato il 10 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (but excepting the existing subordinated loan advanced on 1ST february 1993)
    Brevi particolari
    78 acres 770 square yards approx situate at follingsby county of tyne and wear with a fixed and floating charge over all the assets.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Water Estates Limited
    Transazioni
    • 10 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 feb 1993
    Consegnato il 03 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and premises at thorp arch leeds west yorkshire a fixed and flaoting charge over all the assets present and future of the borrower for full details see form 395.
    Persone aventi diritto
    • Yw Enterprises LTD
    Transazioni
    • 03 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 feb 1993
    Consegnato il 03 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H and f/h properties on the north side of varley st leeds west yorkshire t/nos WYK486001 WYK486002 and wyk 486004 a fixed and floating charge over all the assets of the borrower present and future for full details see form 395.
    Persone aventi diritto
    • Yw Enterprises LTD
    Transazioni
    • 03 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 feb 1993
    Consegnato il 03 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at owlcotes hill stanningley leeds west yorkshire t/n wyk 464352A fixed and floating charge over all the assets present and future of the borrower.
    Persone aventi diritto
    • Yw Enterprises LTD
    Transazioni
    • 03 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 feb 1993
    Consegnato il 03 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a leigh house varley st stanningley leeds west yorkshire for full details see form 395.
    Persone aventi diritto
    • Yw Enterprises LTD
    Transazioni
    • 03 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 feb 1993
    Consegnato il 03 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and premises k/a apex quarry butcher hill horsforth west yorkshire t/n wyk 345268 a fixed and floating charge over all the assets present and future of the borrower.
    Persone aventi diritto
    • Yw Enterprises LTD
    Transazioni
    • 03 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 feb 1993
    Consegnato il 03 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and premises on the s/w side of commercial rd kirkstall leeds west yorkshire t/n wyk 60216 a fixed and floating charge over all the assets present and future of the borrower.
    Persone aventi diritto
    • Yw Enterprises LTD
    Transazioni
    • 03 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 feb 1993
    Consegnato il 03 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and premises k/a citygate wellington st leeds west yorkshire t/n wyk 219237 a fixed and floating charge over all the assets present and future of the borrower.
    Persone aventi diritto
    • Yw Enterprises LTD
    Transazioni
    • 03 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 feb 1993
    Consegnato il 03 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and premises k/a priestly mills swinnow green pudsey west yorkshire t/n YWE58726 fixed and floating charge over all the assets present and future of the borrower.
    Persone aventi diritto
    • Yw Enterprises Limited
    Transazioni
    • 03 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental mortgage
    Creato il 10 gen 1992
    Consegnato il 13 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The benefit of an agreement dated 2ND december 1991 between (1) white rose development enterprises limited and (2) safeway PLC. Relating to land at chow dene bank team valley gateshead (formerly k/a coal house) all proceeds of sale and all monies received under the agreement described.
    Persone aventi diritto
    • Yw Enterprises Limited.
    Transazioni
    • 13 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 30 set 1991
    Consegnato il 01 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Benefit of an agreement for lease dated 30/3/90 benefit of an agreement dated 27/12/90 and proceeds of sale.
    Persone aventi diritto
    • Yw Enterprises Limited
    Transazioni
    • 01 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0