LSUK 2009 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLSUK 2009 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02456232
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LSUK 2009 LIMITED?

    • (5156) /
    • (5190) /

    Dove si trova LSUK 2009 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LSUK 2009 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LITHO SUPPLIES (UK) LIMITED19 ott 199319 ott 1993
    LITHO SUPPLIES LIMITED05 feb 199105 feb 1991
    DRG LITHO SUPPLIES LIMITED26 gen 199026 gen 1990
    TESTRICH LIMITED29 dic 198929 dic 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di LSUK 2009 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per LSUK 2009 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    14 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 ago 2011

    19 pagine4.68

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    24 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 21 giu 2010

    24 pagine2.24B

    Indirizzo della sede legale modificato da 43-45 Portman Square London W1H 6LY in data 28 giu 2010

    2 pagineAD01

    Risultato della riunione dei creditori

    3 pagine2.23B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    9 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    81 pagine2.17B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    81 pagine2.17B

    Cessazione della carica di Simon Wellings come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Simon Wellings come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Edward Williams come amministratore

    2 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 30 dic 2009

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Indirizzo della sede legale modificato da Litho Supplies Longmoor Lane Breaston Derby Derbyshire DE72 3BQ Uk in data 13 gen 2010

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagine2.12B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Facility agreement 03/12/2009
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    14 pagineMG01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    38 pagineAA

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di LSUK 2009 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HAMMOND, Michael John
    Cover Point 195 Attenborough Lane
    Attenborough
    NG9 6AB Nottingham
    Amministratore
    Cover Point 195 Attenborough Lane
    Attenborough
    NG9 6AB Nottingham
    EnglandBritish49566080001
    MITCHELL, John Gerald
    13 Old Sneed Road
    Stoke Bishop
    BS9 1ES Bristol
    Segretario
    13 Old Sneed Road
    Stoke Bishop
    BS9 1ES Bristol
    British48246470002
    RAMCHANDANI, Gulab Nanikram
    4 Off The Scop
    Lower Almondsbury
    BS12 4DU Bristol
    Segretario
    4 Off The Scop
    Lower Almondsbury
    BS12 4DU Bristol
    British15144500001
    WELLINGS, Simon James
    91 Holbrook Road
    Alvaston
    DE24 0LX Derby
    Derbyshire
    Segretario
    91 Holbrook Road
    Alvaston
    DE24 0LX Derby
    Derbyshire
    British76667130001
    BYFORD, John Peter
    The Orchard Hilfield Lane South
    WD23 4EL Bushey Heath
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Orchard Hilfield Lane South
    WD23 4EL Bushey Heath
    Hertfordshire
    British17458340001
    COOPER, Terence Francis Charles
    34 Castle Road
    BS21 7DE Clevedon
    Avon
    Amministratore
    34 Castle Road
    BS21 7DE Clevedon
    Avon
    EnglandBritish102793570001
    MITCHELL, John Gerald
    13 Old Sneed Road
    Stoke Bishop
    BS9 1ES Bristol
    Amministratore
    13 Old Sneed Road
    Stoke Bishop
    BS9 1ES Bristol
    EnglandBritish48246470002
    MULVANEY, Gerald Owen
    17 Mapperley Hall Drive
    Mapperley Park
    NG3 5EP Nottingham
    Amministratore
    17 Mapperley Hall Drive
    Mapperley Park
    NG3 5EP Nottingham
    United KingdomBritish36169070001
    RAMCHANDANI, Gulab Nanikram
    4 Off The Scop
    Lower Almondsbury
    BS12 4DU Bristol
    Amministratore
    4 Off The Scop
    Lower Almondsbury
    BS12 4DU Bristol
    British15144500001
    STOCKTON, James Wardlaw
    4 Oswald Walk
    Milngavie
    G62 6AY Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    4 Oswald Walk
    Milngavie
    G62 6AY Glasgow
    Lanarkshire
    British1381020001
    WELLINGS, Simon James
    91 Holbrook Road
    Alvaston
    DE24 0LX Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    91 Holbrook Road
    Alvaston
    DE24 0LX Derby
    Derbyshire
    EnglandBritish76667130001
    WILLIAMS, Edward Gordon
    Amberley 129 Nottingham Road
    Ravenshead
    NG15 9HJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Amberley 129 Nottingham Road
    Ravenshead
    NG15 9HJ Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish100565740001

    LSUK 2009 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 07 dic 2009
    Consegnato il 17 dic 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Db Invoice Finance 12 Limited
    Transazioni
    • 17 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    All asset debenture
    Creato il 30 apr 2009
    Consegnato il 12 mag 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Eurofactor (UK) Limited
    Transazioni
    • 12 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee and collateral debenture
    Creato il 14 gen 1991
    Consegnato il 24 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from h s holdings limited to the chargee under the terms of the mezzanine loan agreement dated 14/1/91.
    Brevi particolari
    All property as described in schedule, the goodwill and uncalled capital bookdebts, see form 395 (ref 436) and schedule for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group Plcers as Definedfor Itself and as Agent and Trustee for the Lend
    Transazioni
    • 24 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 05 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 gen 1991
    Consegnato il 17 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 4 avon trading estate albert road st philips bristol avon T.no av 168492.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 gen 1991
    Consegnato il 17 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and premises at dale street bilston wolverhampton west midlands t/no sf 103559, wm 164694 and sf 112396.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 05 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of offset
    Creato il 14 gen 1991
    Consegnato il 17 gen 1991
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or l s holdings limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Any sums now or hereafter standing to the credit of any account or accounts in the name of the company.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 14 gen 1991
    Consegnato il 17 gen 1991
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 05 nov 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 13 giu 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)

    LSUK 2009 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 dic 2009Inizio dell'amministrazione
    26 ago 2010Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Phillip Francis Duffy
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praticante
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Andrew Gordon Stoneman
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praticante
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    2
    DataTipo
    26 ago 2010Inizio della liquidazione
    22 ago 2012Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Phillip Francis Duffy
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praticante
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Andrew Gordon Stoneman
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praticante
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0