CERACRYL LABORATORIES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CERACRYL LABORATORIES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02456262 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CERACRYL LABORATORIES LIMITED?
- Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi
Dove si trova CERACRYL LABORATORIES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Bupa Dental Care Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di CERACRYL LABORATORIES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per CERACRYL LABORATORIES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Nomina di Gabriela Pueyo Roberts come amministratore in data 01 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Catherine Elizabeth Barton come amministratore in data 05 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Edward Joseph Coyle come amministratore in data 14 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Dr Steven John Preddy come amministratore in data 14 set 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 8 pagine | AA | ||
legacy | 48 pagine | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pagine | GUARANTEE2 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Ms Catherine Elizabeth Barton come amministratore in data 28 feb 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di David Jon Leatherbarrow come amministratore in data 28 feb 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2018 al 31 dic 2017 | 1 pagine | AA01 | ||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Bupa House 15-19 Bloomsbury Way London WC1A 2BA England a 1 Angel Court London EC2R 7HJ | 1 pagine | AD02 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Bupa Secretaries Limited il 08 dic 2017 | 1 pagine | CH04 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Compliance Manager Oasis Support Centre, Vantage Office Park Old Gloucester Road Hambrook Bristol BS16 1GW a Bupa Dental Care Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook Bristol BS16 1GW in data 27 nov 2017 | 1 pagine | AD01 | ||
Modifica dei dettagli di Jdh Holdings Ltd come persona con controllo significativo il 24 nov 2017 | 2 pagine | PSC05 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 10 pagine | AA | ||
legacy | 44 pagine | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||
Nomina di Mr Jake Stephen Hockley Wright come amministratore in data 30 giu 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Julian Francis Perry come amministratore in data 30 giu 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di CERACRYL LABORATORIES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPA SECRETARIES LIMITED | Segretario | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom |
| 162768400001 | ||||||||||
| PREDDY, Steven John, Dr | Amministratore | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | United Kingdom | British | 250614010001 | |||||||||
| PUEYO ROBERTS, Gabriela | Amministratore | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | Spain | Spanish | 254904830001 | |||||||||
| WRIGHT, Jake Hockley | Amministratore | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | United Kingdom | British | 184341770001 | |||||||||
| BERRY, Stephen Richard | Segretario | 27 Victoria Road Penarth CF64 3HY Cardiff South Glamorgan | British | 117104600001 | ||||||||||
| POWIS, Sarah | Segretario | 104 Princess Victoria Street Clifton Village BS8 4DB Bristol | British | 91325010002 | ||||||||||
| WHITELEY, Alan | Segretario | 2 The Court Corntown CF35 5BJ Bridgend Mid Glamorgan | British | 59879390001 | ||||||||||
| OASIS HEALTHCARE LIMITED | Segretario | c/o Compliance Manager Old Gloucester Road Hambrook BS16 1GW Bristol Oasis Support Centre, Vantage Office Park England |
| 163513320001 | ||||||||||
| QUAYSECO LIMITED | Segretario | Glass Wharf BS2 0ZX Bristol One |
| 146837890001 | ||||||||||
| ASH, Justinian Joseph | Amministratore | c/o Compliance Manager Old Gloucester Road Hambrook BS16 1GW Bristol Oasis Support Centre, Vantage Office Park England | England | British | 188659180001 | |||||||||
| BARTON, Catherine Elizabeth | Amministratore | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | England | British | 243693740001 | |||||||||
| BRAMALL, Colin Stephen | Amministratore | Eastern Building Park CF3 5EA St. Mellons Building 1 Cardiff | United Kingdom | British | 155983960002 | |||||||||
| COYLE, Edward Joseph, Dr | Amministratore | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | United Kingdom | British | 200405130002 | |||||||||
| HULL, James Desmond, Doctor | Amministratore | 13 Brunswick Gardens W8 4AS London | England | British | 95331820002 | |||||||||
| LEATHERBARROW, David Jon | Amministratore | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | England | British | 135618280010 | |||||||||
| MAGRATH, Bryan Robert | Amministratore | Curzon Street W1J 7UW London 50 United Kingdom | England | British | 159813330001 | |||||||||
| O'NEILL, Emmet Eugene | Amministratore | c/o Compliance Manager Old Gloucester Road Hambrook BS16 1GW Bristol Oasis Support Centre, Vantage Office Park England | Ireland | Irish | 171421220001 | |||||||||
| PERRY, Julian Francis | Amministratore | c/o Compliance Manager Old Gloucester Road Hambrook BS16 1GW Bristol Oasis Support Centre, Vantage Office Park England | England | British | 84437900002 | |||||||||
| PUGH, Robin James Mostyn | Amministratore | BS2 0ZX Bristol One Glass Wharf United Kingdom | United Kingdom | British | 64458370003 | |||||||||
| RAETHORNE, David William | Amministratore | c/o Compliance Manager Old Gloucester Road Hambrook BS16 1GW Bristol Oasis Support Centre, Vantage Office Park England | Ireland | Irish | 171537250001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CERACRYL LABORATORIES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jdh Holdings Ltd | 06 apr 2016 | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CERACRYL LABORATORIES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 07 mag 2013 Consegnato il 11 mag 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 13 dic 2010 Consegnato il 22 dic 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security accession deed | Creato il 13 dic 2010 Consegnato il 22 dic 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over all material properties and assets including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security accession deed | Creato il 13 dic 2010 Consegnato il 22 dic 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over all material properties and assets including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 24 mar 2006 Consegnato il 04 apr 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 30 apr 2001 Consegnato il 04 mag 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee (other than dividend on any shares) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 28 gen 1999 Consegnato il 09 feb 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 18 mar 1997 Consegnato il 27 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0