REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED

REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02456356
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
    • Gestione di immobili per conto terzi (68320) / Attività immobiliari

    Dove si trova REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Hall Barn Church Lane
    Lewknor
    OX49 5TP Watlington
    Oxfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NORTH WEST ESTATES (WHITCHURCH) LIMITED19 nov 199219 nov 1992
    NORTH WEST ESTATES (HATHERN) LIMITED26 feb 199026 feb 1990
    GRANDMILE LIMITED29 dic 198929 dic 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 nov 2013

    Stato del capitale al 13 nov 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    11 pagineAA

    Nomina di Miss Carly Colman come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Richard Ashken come segretario

    1 pagineTM02

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2011 al 31 dic 2011

    1 pagineAA01

    legacy

    4 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2009

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Number One Hillingdon Road Uxbridge Middlesex UB10 0AA* in data 13 nov 2009

    2 pagineAD01

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    13 pagineAA

    Varie

    Section 394
    1 pagineMISC

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    12 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    2 pagine88(2)R

    legacy

    1 pagine123

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di aumento del capitale sociale autorizzato

    RES04

    Risoluzioni

    Resolutions
    7 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    legacy

    3 pagine395

    Chi sono gli amministratori di REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COLMAN, Carly
    Church Lane
    Lewknor
    OX49 5TP Watlington
    The Hall Barn
    Oxfordshire
    Segretario
    Church Lane
    Lewknor
    OX49 5TP Watlington
    The Hall Barn
    Oxfordshire
    169548470001
    ASHKEN, Richard Laurence
    3 Heriots Close
    HA7 3EE Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    3 Heriots Close
    HA7 3EE Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish10187380006
    FINCKEN, Paul Edward
    Elm Lodge
    Chinnor Road
    OX49 5SH Aston Rowant
    Amministratore
    Elm Lodge
    Chinnor Road
    OX49 5SH Aston Rowant
    United KingdomBritish109887450001
    ASHKEN, Richard Laurence
    3 Heriots Close
    HA7 3EE Stanmore
    Middlesex
    Segretario
    3 Heriots Close
    HA7 3EE Stanmore
    Middlesex
    British10187380006
    FLICK SMITH, Sarah Louise
    16 Furzeham Road
    UB7 9DD West Drayton
    Middlesex
    Segretario
    16 Furzeham Road
    UB7 9DD West Drayton
    Middlesex
    British85593040001
    MANGAR, Sahadeo
    15 St Agnes Close
    Gore Road
    E9 7HS London
    Segretario
    15 St Agnes Close
    Gore Road
    E9 7HS London
    British48304010001
    PEARL, Brian Irving
    Minster House
    9 Peterborough Road
    HA1 2YW Harrow
    Middlesex
    Segretario
    Minster House
    9 Peterborough Road
    HA1 2YW Harrow
    Middlesex
    British36426610001
    PEARL, Brian Irving
    Minister House
    8 Peterborough Road
    HA1 2BQ Harrow
    Middlesex
    Segretario
    Minister House
    8 Peterborough Road
    HA1 2BQ Harrow
    Middlesex
    British36426610002
    POWER, Anthony John
    Flat 11 Isobel House
    106-112 Station Road
    HA1 2RX Harrow
    Middlesex
    Segretario
    Flat 11 Isobel House
    106-112 Station Road
    HA1 2RX Harrow
    Middlesex
    British64225190001
    TURNER, Martin Neely
    54 Grenfell Park
    Neston
    L64 6TT South Wirral
    Merseyside
    Segretario
    54 Grenfell Park
    Neston
    L64 6TT South Wirral
    Merseyside
    British2308620001
    WILKINS, Christopher Nicholas
    5 Melrose Road
    Barnes
    SW13 9LG London
    Segretario
    5 Melrose Road
    Barnes
    SW13 9LG London
    British37360310001
    HALLAM FINANCIAL PLANNING SERVICES LTD
    145 157 St John Street
    EC1V 4PY London
    Segretario
    145 157 St John Street
    EC1V 4PY London
    42486160001
    CARTER, Anthony David
    44 Leighton Drive
    Marple Bridge
    SK6 5BY Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    44 Leighton Drive
    Marple Bridge
    SK6 5BY Stockport
    Cheshire
    British35406890001
    FINCKEN, Kenneth John
    Cookshall Farmhouse
    Cookshall Lane
    HP12 4AP West Wycombe
    Amministratore
    Cookshall Farmhouse
    Cookshall Lane
    HP12 4AP West Wycombe
    United KingdomBritish41926340010
    MCMILLAN, Robin Chichester
    The Old Malthouse
    Church Lane Ombersley
    WR9 0ER Droitwich
    Worcestershire
    Amministratore
    The Old Malthouse
    Church Lane Ombersley
    WR9 0ER Droitwich
    Worcestershire
    British35995090001

    REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over shares
    Creato il 14 set 2007
    Consegnato il 27 set 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fifty (50) shares of £1 each in highland trilatera limited together with all allotments, accretions, benefits and advantages whatever now or in the future accruing in respect of them. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bradda Finance and Investment Limited
    Transazioni
    • 27 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 14 set 2007
    Consegnato il 27 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bradda Finance and Investment Limited
    Transazioni
    • 27 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assignment
    Creato il 27 mag 2005
    Consegnato il 02 giu 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from cheetham village investments L.P (debtor) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of security its interest pursuant to the joint venture agreement and amendments and variations thereto; will pay and discharge the secured liabilities in accordance with the terms of the facility letter. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transazioni
    • 02 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 27 set 2000
    Consegnato il 29 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or northwest estates PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold land on south west side of newcut west,ipswich,suffolk; t/no sk 39424.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 24 lug 1998
    Consegnato il 31 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 21 ott 1991
    Consegnato il 31 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See doc M268C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 15 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 26 giu 1990
    Consegnato il 10 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 15 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0