WILLIAMSON MOORE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | WILLIAMSON MOORE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02457623 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WILLIAMSON MOORE LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova WILLIAMSON MOORE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | The Walbrook Building 25 Walbrook EC4N 8AW London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di WILLIAMSON MOORE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SCHEMEWATCH LIMITED | 09 gen 1990 | 09 gen 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di WILLIAMSON MOORE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per WILLIAMSON MOORE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 8 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 gen 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Jarlath Delphene Wade come segretario in data 09 ago 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Alistair Charles Peel come segretario in data 09 ago 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 gen 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 gen 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 9 South Parade Wakefield West Yorkshire WF1 1LR a The Walbrook Building 25 Walbrook London EC4N 8AW in data 07 dic 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2014 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Stephen Mugge come amministratore in data 26 gen 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Matthew Pike come amministratore in data 26 gen 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mag 2015 al 31 dic 2014 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 33 George Street Wakefield West Yorkshire WF1 1LX United Kingdom a The Walbrook Building 25 Walbrook London EC4N 8AW | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Nomina di Mr Mark Stephen Mugge come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Jarlath Delphene Wade come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di WILLIAMSON MOORE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEEL, Alistair Charles | Segretario | 25 Walbrook EC4N 8AW London The Walbrook Building England | 249411660001 | |||||||
| PIKE, Matthew William | Amministratore | 25 Walbrook EC4N 8AW London The Walbrook Building England | England | British | 187274510001 | |||||
| BENEV, Stefan Benkov | Segretario | 61 Lyndon Road Bramham LS23 6RH Wetherby West Yorkshire | British | 57276760002 | ||||||
| GLEE, Nicolette May | Segretario | Bramley House Norfolk Place PO21 1XF Bognor Regis West Sussex | British | 10656590001 | ||||||
| WADE, Jarlath Delphene | Segretario | 25 Walbrook EC4N 8AW London The Walbrook Building England | 187144000001 | |||||||
| ALLISON, Simon | Amministratore | 5 The Orchard PO7 6YG Waterlooville Hampshire | England | British | 153456310001 | |||||
| CHAPPELL, Lee | Amministratore | Dolphins Bookers Lane, Earnley PO20 7JG Chichester West Sussex | United Kingdom | British | 79036030001 | |||||
| GLEE, Jack | Amministratore | Bramley House Norfolk Place PO21 1XF Bognor Regis West Sussex | British | 10656600001 | ||||||
| GLEE, Nicolette May | Amministratore | Bramley House Norfolk Place PO21 1XF Bognor Regis West Sussex | British | 10656590001 | ||||||
| HERDMAN, Jeffrey Niven | Amministratore | South Parade WF1 1LR Wakefield 9 West Yorkshire | United Kingdom | British | 59019040004 | |||||
| HODSON, Richard Phillip | Amministratore | Manor Farm House 75 George Lane Notton WF4 2NQ Wakefield West Yorkshire | England | British | 5677400003 | |||||
| KNIGHT, Robert Charles | Amministratore | 10 West Close Middleton On Sea PO22 7RP Bognor Regis West Sussex | British | 88953210001 | ||||||
| MACGREGOR TRUSCOTT, James Edward | Amministratore | Timberley House Tudor Close RH20 2EF Pulborough West Sussex | British | 109619940001 | ||||||
| MORLEY, Richard John | Amministratore | 187 Goldstone Crescent BN3 6BD Hove Sussex | England | British | 80122390001 | |||||
| MUGGE, Mark Stephen | Amministratore | 9 South Parade Wakefield WF1 1LR West Yorkshire | United Kingdom | American | 177812360003 | |||||
| SHAW, Simon Andrew | Amministratore | South Parade WF1 1LR Wakefield 8 West Yorkshire | England | British | 87062650003 | |||||
| STANTON, Paul | Amministratore | Westcroft Victoria Gardens PO20 3YL Westergate West Sussex | England | British | 109619830001 | |||||
| STONE, John Kyle | Amministratore | 28 Groom Place SW1X 7BA London | British | 8860300001 | ||||||
| VAN DER WALT, Geoffrey Ronald | Amministratore | Holme Manor Cottage Mare Hill Road RH20 2DS Pulborough West Sussex | British | 6075900003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di WILLIAMSON MOORE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oval Limited | 06 apr 2016 | South Parade WF1 1LR Wakefield 9 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
WILLIAMSON MOORE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| An accession deed | Creato il 31 mag 2007 Consegnato il 11 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 03 feb 1999 Consegnato il 22 feb 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 11 mar 1996 Consegnato il 13 mar 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £62,521 and all other monies due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 01 ott 1992 Consegnato il 19 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £103,521.00 and all other monies due or to become due from the company to john kyle stone | |
Brevi particolari Second floating charge over all the company`s undertaking and property and uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 07 ago 1992 Consegnato il 12 ago 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £35,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Second floating charge of all the undertaking and property whatsoever and wheresoever both present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 07 gen 1991 Consegnato il 10 gen 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £61,000 | |
Brevi particolari By way of floating charge all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
WILLIAMSON MOORE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0