ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED

ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02463879
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    250 Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE TRAINING CENTRE LIMITED26 gen 199026 gen 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 18 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 ago 2013

    Stato del capitale al 06 ago 2013

    • Capitale: GBP 52,750
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr. Timothy Walter Gregory il 24 lug 2013

    3 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2012

    3 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2012 al 30 set 2012

    3 pagineAA01

    Nomina di Mr. Timothy Walter Gregory come amministratore in data 19 set 2012

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr. Robert David Anderson come amministratore in data 19 set 2012

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr. Faris Mehdi Kadhim Mohammed come amministratore in data 19 set 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Gavin Peter Griggs come amministratore in data 19 set 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Alice Rivers come amministratore in data 19 set 2012

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Logica Cosec Limited come segretario in data 07 dic 2011

    3 pagineAP04

    Cessazione della carica di Logica International Limited come segretario in data 07 dic 2011

    2 pagineTM02

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    11 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Authority in accordance with sec 175(5)(a) 22/09/2011
    RES13

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Thomas Mackay come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Gavin Peter Griggs come amministratore

    3 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Logica International Limited il 01 ott 2009

    2 pagineCH04

    Chi sono gli amministratori di ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LOGICA COSEC LIMITED
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    United Kingdom
    Segretario
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione7745327
    165434150001
    ANDERSON, Robert David, Mr.
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Amministratore
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    CanadaCanadian122988350004
    GREGORY, Timothy Walter
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Amministratore
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    EnglandBritish149429760002
    MOHAMMED, Faris Mehdi Kadhim
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Amministratore
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    EnglandBritish67645590001
    BLACKMAN, Kenneth
    3 Selwood Terrace
    SW7 3QN London
    Segretario
    3 Selwood Terrace
    SW7 3QN London
    British42539880001
    FRANCIS, Richard John
    7 Kinderscout
    HP3 8HW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Segretario
    7 Kinderscout
    HP3 8HW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British67742720001
    PATON, Daryl Marc
    Miles Lane
    KT11 2EF Cobham
    Easter House
    Surrey
    Segretario
    Miles Lane
    KT11 2EF Cobham
    Easter House
    Surrey
    British104564540001
    LOGICA INTERNATIONAL LIMITED
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Segretario
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1237299
    45193120003
    AUER, Adrian Richard
    Rme House
    Coldharbour Lane
    TW20 8TD Thorpe Egham
    Surrey
    Amministratore
    Rme House
    Coldharbour Lane
    TW20 8TD Thorpe Egham
    Surrey
    United KingdomBritish105271660001
    BLACKMAN, Kenneth
    3 Selwood Terrace
    SW7 3QN London
    Amministratore
    3 Selwood Terrace
    SW7 3QN London
    British42539880001
    BRADSHAW, Michael
    46 Scatterdells Lane
    Chipperfield
    WD4 9ET Kings Langley
    Hertfordshire
    Amministratore
    46 Scatterdells Lane
    Chipperfield
    WD4 9ET Kings Langley
    Hertfordshire
    British57941410001
    BRENDISH, Clayton Mark
    Horseshoe House
    Coworth Park, London Road Sunninghill
    SL5 7SE Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Horseshoe House
    Coworth Park, London Road Sunninghill
    SL5 7SE Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish11857380004
    CRAIG, Peter John
    9 Clayfield
    Yate
    BS17 5PE Bristol
    Avon
    Amministratore
    9 Clayfield
    Yate
    BS17 5PE Bristol
    Avon
    British28293230002
    FLOYDD, William
    27 Dagden Road
    GU4 8DD Shalford
    Surrey
    Amministratore
    27 Dagden Road
    GU4 8DD Shalford
    Surrey
    British101702410001
    GRIGGS, Gavin Peter
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Amministratore
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    EnglandBritish154536120001
    HAMMILL, George
    6 Abbotsbury Road
    Bishopstoke
    SO50 8NZ Eastleigh
    Hampshire
    Amministratore
    6 Abbotsbury Road
    Bishopstoke
    SO50 8NZ Eastleigh
    Hampshire
    British76504500001
    HAMMILL, George
    6 Abbotsbury Road
    Bishopstoke
    SO50 8NZ Eastleigh
    Hampshire
    Amministratore
    6 Abbotsbury Road
    Bishopstoke
    SO50 8NZ Eastleigh
    Hampshire
    British76504500001
    HARRISON, Simon Charles
    Laurel House
    Goose Lane
    GU22 0NW Woking
    Surrey
    Amministratore
    Laurel House
    Goose Lane
    GU22 0NW Woking
    Surrey
    EnglandBritish120581670001
    JAMES, Ceri Lloyd
    Fairacre
    35 Compton Way
    GU10 1QT Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Fairacre
    35 Compton Way
    GU10 1QT Farnham
    Surrey
    British65996360001
    JONES, David Rodney
    White Cottage
    Rectory Road, Oakley
    RG23 7ED Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    White Cottage
    Rectory Road, Oakley
    RG23 7ED Basingstoke
    Hampshire
    British69172140001
    MACKAY, Thomas Owen
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Amministratore
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    United KingdomBritish125924240001
    MARSHALL, Jeffrey
    22 Riversdell Close
    KT16 9JW Chertsey
    Surrey
    Amministratore
    22 Riversdell Close
    KT16 9JW Chertsey
    Surrey
    British37185850001
    MARSHALL, Jeffrey
    22 Riversdell Close
    KT16 9JW Chertsey
    Surrey
    Amministratore
    22 Riversdell Close
    KT16 9JW Chertsey
    Surrey
    British37185850001
    MELLORS, David Antony
    Cody Technology Park
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    A1/2009
    Hampshire
    Uk
    Amministratore
    Cody Technology Park
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    A1/2009
    Hampshire
    Uk
    EnglandBritish166957670001
    MUNRO, Alan Malcolm
    Holly Bank Lodge 150a Nine Mile Ride
    RG40 4JA Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Holly Bank Lodge 150a Nine Mile Ride
    RG40 4JA Wokingham
    Berkshire
    British55767650001
    NEVILLE, Geoffrey Leslie
    53 Church Road
    Abbots Leigh
    BS8 3QU Bristol
    Avon
    Amministratore
    53 Church Road
    Abbots Leigh
    BS8 3QU Bristol
    Avon
    United KingdomBritish39989270002
    NEVILLE, Geoffrey Leslie
    53 Church Road
    Abbots Leigh
    BS8 3QU Bristol
    Avon
    Amministratore
    53 Church Road
    Abbots Leigh
    BS8 3QU Bristol
    Avon
    United KingdomBritish39989270002
    PARKER, Anthony Hugh
    4 Baldock Road
    SG6 3LB Letchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Baldock Road
    SG6 3LB Letchworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish90058690001
    RIVERS, Alice
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Amministratore
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    EnglandBritish135315640001
    SMITH, Adrian Trevor
    36 The Willows
    Highworth
    SN6 7PG Swindon
    Wiltshire
    Amministratore
    36 The Willows
    Highworth
    SN6 7PG Swindon
    Wiltshire
    United KingdomBritish44525580002
    WEAVER, Paul
    Brookside
    CM11 1DT Billericay
    36
    Essex
    Amministratore
    Brookside
    CM11 1DT Billericay
    36
    Essex
    United KingdomBritish45193280002

    ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Letter of charge
    Creato il 14 lug 1995
    Consegnato il 04 ago 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies now or at any time standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit agreement
    Creato il 26 nov 1993
    Consegnato il 03 dic 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 26TH november 1993
    Brevi particolari
    £4,876.25 due or to become due from the company to the chargee.
    Persone aventi diritto
    • Broadwell Land PLC
    Transazioni
    • 03 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 11 nov 1991
    Consegnato il 19 nov 1991
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit agreement
    Creato il 15 mag 1991
    Consegnato il 16 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of 2 leases dated 15.5.91
    Brevi particolari
    £4.150.00.
    Persone aventi diritto
    • Broadwell Kind PLC
    Transazioni
    • 16 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 10 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0