BL HC INVIC LEISURE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BL HC INVIC LEISURE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02464159 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BL HC INVIC LEISURE LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova BL HC INVIC LEISURE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BL HC INVIC LEISURE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| INVICTA LEISURE LIMITED | 26 gen 1990 | 26 gen 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BL HC INVIC LEISURE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per BL HC INVIC LEISURE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 feb 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione di Bl Hc Health and Fitness Holdings Limited come persona con controllo significativo il 25 nov 2022 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Notifica di Bl Retail Warehousing Holding Company Limited come persona con controllo significativo il 25 nov 2022 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Katherine Fyfe come amministratore in data 17 ott 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Katherine Fyfe il 20 lug 2022 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Katherine Fyfe come amministratore in data 20 lug 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Stato del capitale al 21 apr 2022
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Charles John Middleton come amministratore in data 31 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Gavin Bergin come amministratore in data 18 mar 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sarah Morrell Barzycki come amministratore in data 18 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan Charles Mcnuff come amministratore in data 18 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Nick Taunt come amministratore in data 18 mar 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nigel Mark Webb come amministratore in data 18 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Stuart Macey come amministratore in data 18 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 feb 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 feb 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BL HC INVIC LEISURE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| BERGIN, Gavin | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 251327820001 | |||||||||
| TAUNT, Nicholas Henry | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 275050860001 | |||||||||
| BALL, Michael David | Segretario | Mulberry House Trumps Green Road GU25 4JA Virginia Water Surrey | British | 58961410002 | ||||||||||
| EKPO, Ndiana | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | 162246380001 | |||||||||||
| FALLOWS, Michael Joseph | Segretario | 11 Greville Drive Edgbaston B15 2UU Birmingham | British | 58345490001 | ||||||||||
| SCALES, Eugene Patrick | Segretario | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | Other | 124193970001 | ||||||||||
| TYSON, Roger Thomas Virley | Segretario | 2 Gadd Close RG40 5PQ Wokingham Berkshire | British | 113777700001 | ||||||||||
| WEATHERLEY, Kenneth Frank | Segretario | 8 Langtons Court Sun Lane SO24 9UE Alresford Hampshire | British | 50477690001 | ||||||||||
| WONG, Wai Chung | Segretario | Flat 3 Rowsley Lodge 72a Lady Margaret Road N19 5EL London | British | 123616460002 | ||||||||||
| BALL, Michael David | Amministratore | Mulberry House Trumps Green Road GU25 4JA Virginia Water Surrey | United Kingdom | British | 58961410002 | |||||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 32809050044 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 32809000002 | |||||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 170891060001 | |||||||||
| CHARLTON, Stephen Paul | Amministratore | 9 Rowan Close L40 4LP Burscough Lancashire | England | British | 96743210001 | |||||||||
| CLELAND, Jonathan Bradley | Amministratore | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 146698270001 | |||||||||
| CONNON, Daniel Francis | Amministratore | Elmhurst Dundle Road Matfield TN12 7HD Tonbridge Kent | British | 35128740001 | ||||||||||
| COUPE, David John | Amministratore | 1 Chelsea House 13 Edith Grove SW10 0JZ London | United Kingdom | British | 125432970002 | |||||||||
| CREED, Stuart John | Amministratore | Jade House The Avenue Claverton Down BA2 7AX Bath | United Kingdom | British | 3716600001 | |||||||||
| CURRY, John Arthur Hugh | Amministratore | Stokewood Park House Sheardley Lane Droxford SO32 3QY Southampton | England | British | 2968140002 | |||||||||
| DAVIES, Rhian Lynn | Amministratore | 32 Caldervale Road SW4 9LZ Clapham London | British | 48466920001 | ||||||||||
| DHODY, Jog | Amministratore | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 104269910002 | |||||||||
| DICKSON, Peter Alan | Amministratore | Pointer House Farm Langley Lane Goosnargh PR3 2JS Preston Lancashire | British | 13332510001 | ||||||||||
| FALLOWS, Michael Joseph | Amministratore | 11 Greville Drive Edgbaston B15 2UU Birmingham | England | British | 58345490001 | |||||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 1898090001 | |||||||||
| FYFE, Katherine | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 293284010001 | |||||||||
| GIBSON, Clive Patrick, The Honourable | Amministratore | Monmouth House 29a Hyde Park Gate SW7 5DJ London | British | 45468220001 | ||||||||||
| GILLIS, Neil Duncan | Amministratore | Lodge Farm High Street, Thelnetham IP22 1JL Diss Norfolk | England | British | 69204500003 | |||||||||
| GRIFFITHS, Paul Richard | Amministratore | 21 Manor Way Blackheath SE3 9EF London | British | 54611260001 | ||||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| GUYER, Paul John | Amministratore | Oakwood House 29 Leydene Park GU32 1HF East Meon Hampshire | British | 100971720002 | ||||||||||
| HALL, Andrew James | Amministratore | Tanglewood 3 Badingham Drive AL5 2DA Harpenden Hertfordshire | England | British | 30306840002 | |||||||||
| LEATHERBARROW, David Jon | Amministratore | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | England | British | 135618280002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BL HC INVIC LEISURE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bl Retail Warehousing Holding Company Limited | 25 nov 2022 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Bl Hc Health And Fitness Holdings Limited | 06 apr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
BL HC INVIC LEISURE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating security document | Creato il 18 giu 2009 Consegnato il 26 giu 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment of receivables | Creato il 18 giu 2009 Consegnato il 26 giu 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Right title and interest in and to the receivables see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Group debenture | Creato il 08 feb 2006 Consegnato il 18 feb 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 27 gen 2004 Consegnato il 07 feb 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any other member of the group to the note finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 27 gen 2004 Consegnato il 03 feb 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any member of the group (meaning the borrower or its subsidiaries from time to time) to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Dukes meadow chiswick hounslow t/no NGL147830; imperial way croydon surrey t/no SGL454522; llandarcy neath swansea t/no CYM43829 and WA953690 for details of further properties charged please refer to form 395 unscheduled property, rental income, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, reights as tenant, book and other debts, bank accounts, charged securities, uncalled capital , goodwill, intellectual property, licences, credit agreements, contracts floating charge undertaking property rights and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental charge | Creato il 09 set 2003 Consegnato il 12 set 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari L/H premises together with buildings erected on them k/a the bridgend health & fitness club, waterton park, waterton lane, bridgend, mid glamorgan together with all buildings and fixtures thereon and the proceeds of sale or any part thereon, all other estates or interests in the property and any rights under any licence or other agreement fixed charge present and future book and other debts, all equipment owned present and future , the benefit of all licences, permissions, consents and authorisations present and future, benefits of all insurance by way of assignment all its right, title and interest in and to all contracts and insurances. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 05 set 2002 Consegnato il 09 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the issuer and by each charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage all properties now owned by or vested in each charging company including t/n HS293663 humberston country club, humberston avenue, grimsby. T/n HS293701 humberston country club, humberston avenue, grimsby and leasehold unit 9C, upper winbury farm, wingrave, aylesbury, buckinghamshire. By way of first fixed mortgage the securities, first fixed charge all properties thereafter acquired, all present and future interests in or over freehold or leasehold property; all present and future rights, licences, guarantees, rents, deposits, contracts, covenants and warranties relating to the properties.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit deed | Creato il 14 giu 2001 Consegnato il 28 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £100,000 including all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The deposit and all rights titles and benefits whatsoever present and future therein. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit deed | Creato il 18 apr 2000 Consegnato il 26 apr 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £100,000 due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Charge over the deposit of £100,000. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 15 ott 1999 Consegnato il 28 ott 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and security trustee for the finance parties (as therein defined)) on any account whatsoever, under or in connection with the financing documents (including, without limitation, the guarantee and debenture) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 10 mar 1999 Consegnato il 24 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land and buildings lying to the north of humberston avenue humberston north east lincolnshire t/no;-HS228117 together with goodwill of any business carried on at the property and all right title and interest in and to the "acquisition documents" (as defined in the charge). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 08 mar 1999 Consegnato il 23 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 191 humberston avenue grimsby t/no ;-HS256419 together with land at the rear with title number HS228117 (part) and goodwill of any business carried on at the property and all the company's interest in and to the acquisition documents. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 30 mag 1996 Consegnato il 10 giu 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 30 mag 1996 Consegnato il 07 giu 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or any group member to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 lug 1994 Consegnato il 20 lug 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £150000 due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari Land to south of batlet road west end hampshire t/n HP471547. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of amendment | Creato il 13 feb 1992 Consegnato il 20 feb 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari As specified in previous debenture see form 395 m/66/l for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment of life policies | Creato il 07 gen 1992 Consegnato il 15 gen 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility agreement dated 16/9/91 and/or this charge | |
Brevi particolari The policies as defined below and all moneys thereby assured which may become payable thereunder and all the full benefit thereof please see form 395 5 16/1 for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 16 set 1991 Consegnato il 23 set 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 16 sept, 1991 and the charge | |
Brevi particolari (See form 395 and continuation sheets relevant to this charge). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0