BL HC INVIC LEISURE LIMITED

BL HC INVIC LEISURE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBL HC INVIC LEISURE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02464159
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INVICTA LEISURE LIMITED26 gen 199026 gen 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 feb 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione di Bl Hc Health and Fitness Holdings Limited come persona con controllo significativo il 25 nov 2022

    1 paginePSC07

    Notifica di Bl Retail Warehousing Holding Company Limited come persona con controllo significativo il 25 nov 2022

    2 paginePSC02

    Cessazione della carica di Katherine Fyfe come amministratore in data 17 ott 2022

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Katherine Fyfe il 20 lug 2022

    2 pagineCH01

    Nomina di Mrs Katherine Fyfe come amministratore in data 20 lug 2022

    2 pagineAP01
    Note
    DataNota
    23 mag 2023Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 23rd May 2023 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022

    5 pagineAA

    Stato del capitale al 21 apr 2022

    • Capitale: GBP 1.00
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Charles John Middleton come amministratore in data 31 mar 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Gavin Bergin come amministratore in data 18 mar 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sarah Morrell Barzycki come amministratore in data 18 mar 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jonathan Charles Mcnuff come amministratore in data 18 mar 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Nick Taunt come amministratore in data 18 mar 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nigel Mark Webb come amministratore in data 18 mar 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Stuart Macey come amministratore in data 18 mar 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 feb 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 feb 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Segretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione8992198
    187856670001
    BERGIN, Gavin
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish251327820001
    TAUNT, Nicholas Henry
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish275050860001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Segretario
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    British58961410002
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Segretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    162246380001
    FALLOWS, Michael Joseph
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    Segretario
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    British58345490001
    SCALES, Eugene Patrick
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Other124193970001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    British113777700001
    WEATHERLEY, Kenneth Frank
    8 Langtons Court
    Sun Lane
    SO24 9UE Alresford
    Hampshire
    Segretario
    8 Langtons Court
    Sun Lane
    SO24 9UE Alresford
    Hampshire
    British50477690001
    WONG, Wai Chung
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    Segretario
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    British123616460002
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritish58961410002
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish32809050044
    BRAINE, Anthony
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish32809000002
    CARTER, Simon Geoffrey
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish170891060001
    CHARLTON, Stephen Paul
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    Amministratore
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    EnglandBritish96743210001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish146698270001
    CONNON, Daniel Francis
    Elmhurst Dundle Road
    Matfield
    TN12 7HD Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    Elmhurst Dundle Road
    Matfield
    TN12 7HD Tonbridge
    Kent
    British35128740001
    COUPE, David John
    1 Chelsea House
    13 Edith Grove
    SW10 0JZ London
    Amministratore
    1 Chelsea House
    13 Edith Grove
    SW10 0JZ London
    United KingdomBritish125432970002
    CREED, Stuart John
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    Amministratore
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    United KingdomBritish3716600001
    CURRY, John Arthur Hugh
    Stokewood Park House Sheardley Lane
    Droxford
    SO32 3QY Southampton
    Amministratore
    Stokewood Park House Sheardley Lane
    Droxford
    SO32 3QY Southampton
    EnglandBritish2968140002
    DAVIES, Rhian Lynn
    32 Caldervale Road
    SW4 9LZ Clapham
    London
    Amministratore
    32 Caldervale Road
    SW4 9LZ Clapham
    London
    British48466920001
    DHODY, Jog
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish104269910002
    DICKSON, Peter Alan
    Pointer House Farm
    Langley Lane Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Pointer House Farm
    Langley Lane Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    British13332510001
    FALLOWS, Michael Joseph
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    Amministratore
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    EnglandBritish58345490001
    FORSHAW, Christopher Michael John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish1898090001
    FYFE, Katherine
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish293284010001
    GIBSON, Clive Patrick, The Honourable
    Monmouth House
    29a Hyde Park Gate
    SW7 5DJ London
    Amministratore
    Monmouth House
    29a Hyde Park Gate
    SW7 5DJ London
    British45468220001
    GILLIS, Neil Duncan
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    Amministratore
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    EnglandBritish69204500003
    GRIFFITHS, Paul Richard
    21 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9EF London
    Amministratore
    21 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9EF London
    British54611260001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    GUYER, Paul John
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    Amministratore
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    British100971720002
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish30306840002
    LEATHERBARROW, David Jon
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish135618280002

    Chi sono le persone con controllo significativo di BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bl Retail Warehousing Holding Company Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    25 nov 2022
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione06002154
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Bl Hc Health And Fitness Holdings Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 apr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    BL HC INVIC LEISURE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating security document
    Creato il 18 giu 2009
    Consegnato il 26 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 26 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment of receivables
    Creato il 18 giu 2009
    Consegnato il 26 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Right title and interest in and to the receivables see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Esporta Financial Services Limited
    Transazioni
    • 26 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2009
    • 08 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Group debenture
    Creato il 08 feb 2006
    Consegnato il 18 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Secured Parties)(in Such Capacity the "Security Agent")
    Transazioni
    • 18 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 gen 2004
    Consegnato il 07 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any other member of the group to the note finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Electra Partners Europe Limited as Noteholders' Agent and Noteholders' Security Trustee Andnoteholders Security Trust (The "Noteholders' Security Trustee")
    Transazioni
    • 07 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 gen 2004
    Consegnato il 03 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any member of the group (meaning the borrower or its subsidiaries from time to time) to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Dukes meadow chiswick hounslow t/no NGL147830; imperial way croydon surrey t/no SGL454522; llandarcy neath swansea t/no CYM43829 and WA953690 for details of further properties charged please refer to form 395 unscheduled property, rental income, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, reights as tenant, book and other debts, bank accounts, charged securities, uncalled capital , goodwill, intellectual property, licences, credit agreements, contracts floating charge undertaking property rights and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge
    Creato il 09 set 2003
    Consegnato il 12 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H premises together with buildings erected on them k/a the bridgend health & fitness club, waterton park, waterton lane, bridgend, mid glamorgan together with all buildings and fixtures thereon and the proceeds of sale or any part thereon, all other estates or interests in the property and any rights under any licence or other agreement fixed charge present and future book and other debts, all equipment owned present and future , the benefit of all licences, permissions, consents and authorisations present and future, benefits of all insurance by way of assignment all its right, title and interest in and to all contracts and insurances.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 12 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 05 set 2002
    Consegnato il 09 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the issuer and by each charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all properties now owned by or vested in each charging company including t/n HS293663 humberston country club, humberston avenue, grimsby. T/n HS293701 humberston country club, humberston avenue, grimsby and leasehold unit 9C, upper winbury farm, wingrave, aylesbury, buckinghamshire. By way of first fixed mortgage the securities, first fixed charge all properties thereafter acquired, all present and future interests in or over freehold or leasehold property; all present and future rights, licences, guarantees, rents, deposits, contracts, covenants and warranties relating to the properties.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Electra Partners Europe Limited (As Noteholders' Agent and Noteholders' Security Agent for Thenote Finance Parties)
    Transazioni
    • 09 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit deed
    Creato il 14 giu 2001
    Consegnato il 28 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £100,000 including all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The deposit and all rights titles and benefits whatsoever present and future therein.
    Persone aventi diritto
    • Arrowcroft Leisure Limited
    Transazioni
    • 28 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit deed
    Creato il 18 apr 2000
    Consegnato il 26 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £100,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Charge over the deposit of £100,000.
    Persone aventi diritto
    • Arrowcroft Leisure Limited
    Transazioni
    • 26 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 ott 1999
    Consegnato il 28 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and security trustee for the finance parties (as therein defined)) on any account whatsoever, under or in connection with the financing documents (including, without limitation, the guarantee and debenture)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 28 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 10 mar 1999
    Consegnato il 24 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings lying to the north of humberston avenue humberston north east lincolnshire t/no;-HS228117 together with goodwill of any business carried on at the property and all right title and interest in and to the "acquisition documents" (as defined in the charge). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Kingsway Nominees Limitedas Trustee on Behalf of Electra Fleming Privateequity Partners (The Lender)
    Transazioni
    • 24 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 08 mar 1999
    Consegnato il 23 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    191 humberston avenue grimsby t/no ;-HS256419 together with land at the rear with title number HS228117 (part) and goodwill of any business carried on at the property and all the company's interest in and to the acquisition documents. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 23 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 mag 1996
    Consegnato il 10 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 10 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 mag 1996
    Consegnato il 07 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or any group member to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kingsway Nominees Limitedas Trustee on Behalf of Electra Fleming Privateequity Partners
    Transazioni
    • 07 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 lug 1994
    Consegnato il 20 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £150000 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Land to south of batlet road west end hampshire t/n HP471547.
    Persone aventi diritto
    • The Lawn Tennis Association
    Transazioni
    • 20 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of amendment
    Creato il 13 feb 1992
    Consegnato il 20 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    As specified in previous debenture see form 395 m/66/l for full details.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Co.
    Transazioni
    • 20 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of life policies
    Creato il 07 gen 1992
    Consegnato il 15 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility agreement dated 16/9/91 and/or this charge
    Brevi particolari
    The policies as defined below and all moneys thereby assured which may become payable thereunder and all the full benefit thereof please see form 395 5 16/1 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Co.
    Transazioni
    • 15 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 set 1991
    Consegnato il 23 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 16 sept, 1991 and the charge
    Brevi particolari
    (See form 395 and continuation sheets relevant to this charge). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Co.
    Transazioni
    • 23 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 26 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0