IXITECH LIMITED
Panoramica
| Nome della società | IXITECH LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02466556 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di IXITECH LIMITED?
- Ricerca e sviluppo sperimentale in biotecnologie (72110) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova IXITECH LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o 4TH FLOOR, GRIFFIN COURT 15 Long Lane EC1A 9PN London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di IXITECH LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| PHYTOTECH LIMITED | 12 mar 1996 | 12 mar 1996 |
| PHYTOPHARM LIMITED | 02 feb 1990 | 02 feb 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di IXITECH LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per IXITECH LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Susan Day Lowther come amministratore in data 11 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 nov 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Derek Lionel Glendon Hill come amministratore in data 22 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2017 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 nov 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2016 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Giulio Cerroni come amministratore in data 07 feb 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jane Elizabeth Whitrow come segretario in data 30 ago 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2015 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Charles Alexander Evan Spicer come amministratore in data 31 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2014 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mrs Susan Day Lowther come amministratore in data 01 ott 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed phytotech LIMITED\certificate issued on 29/09/14 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * the London Bioscience Innovation Centre 2 Royal College Street Greater London NW1 0NH* in data 05 giu 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2013 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Varie Section 519 | 1 pagine | MISC | ||||||||||
Nomina di Dr Jane Elizabeth Whitrow come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Zoe Mcgowan come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di IXITECH LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERRONI, Giulio | Amministratore | c/o 4th Floor, Griffin Court Long Lane EC1A 9PN London 15 | England | British | 224250820001 | |||||
| CHONG, Giap Wang, Dr | Segretario | Corpus Christi House 9 West Street PE29 2HY Godmanchester Cambridgeshire | British | 63602640005 | ||||||
| GORMAN, Jeremy Philip | Segretario | Clifton Gardens W9 1AU London 58d | British | 3290440005 | ||||||
| INGHAM, Bruce | Segretario | 12 Meadowford CB11 3QL Newport Essex | British | 32333130001 | ||||||
| LOACH, Simon Charles, Doctor | Segretario | 37b Cannon Street Little Downham CB6 2SS Ely Cambridgeshire | British | 34750290001 | ||||||
| MCGOWAN, Zoe Karen | Segretario | The London Bioscience Innovation Centre 2 Royal College Street NW1 0NH Greater London | British | 146103060001 | ||||||
| MCGOWAN, Zoe Karen | Segretario | 9 West Street PE29 2HY Godmanchester Cambridgeshire | British | 109349700001 | ||||||
| WHITROW, Jane Elizabeth, Dr | Segretario | c/o 4th Floor, Griffin Court Long Lane EC1A 9PN London 15 England | 183160920001 | |||||||
| BABER, Ralph Peter | Amministratore | Oaklands 5 Queenborough Gardens BR7 6NP Chislehurst Kent | England | British | 150093220001 | |||||
| CHONG, Giap Wang, Dr | Amministratore | Corpus Christi House 9 West Street PE29 2HY Godmanchester Cambridgeshire | British | 63602640005 | ||||||
| DIXEY, Richard, Doctor | Amministratore | 9 West Street PE29 2HY Godmanchester Cambridgeshire | British | 85945390002 | ||||||
| GIBBONS, Paul Michael | Amministratore | 3 Exeter Court St Peters Street PE9 2PF Stamford Lincolnshire | British | 51143880002 | ||||||
| GUY, Geoffrey William, Dr | Amministratore | South House Piddletrenthide DT2 7QP Dorchester Dorset | British | 64246220001 | ||||||
| HEBBEN, Klaus | Amministratore | Bp 539 98015 FOREIGN Monaco (Edex) | German | 33459440003 | ||||||
| HEBBEN, Klaus | Amministratore | 2 Harley Gardens SW10 9SW London | German | 33459440005 | ||||||
| HICKLING, Roger Ian | Amministratore | The London Bioscience Innovation Centre 2 Royal College Street NW1 0NH Greater London | England | British | 149361120001 | |||||
| HILL, Derek Lionel Glendon, Professor | Amministratore | c/o 4th Floor, Griffin Court Long Lane EC1A 9PN London 15 England | England | British | 182736050001 | |||||
| INGHAM, Bruce | Amministratore | 12 Meadowford CB11 3QL Newport Essex | British | 32333130001 | ||||||
| LOACH, Simon Charles, Doctor | Amministratore | 37b Cannon Street Little Downham CB6 2SS Ely Cambridgeshire | British | 34750290001 | ||||||
| LOWTHER, Susan Day | Amministratore | c/o 4th Floor, Griffin Court Long Lane EC1A 9PN London 15 England | England | British | 9291070004 | |||||
| MORGAN, Piers John | Amministratore | Corpus Christi House 9 West Street PE29 2HY Godmanchester Cambridgeshire | British | 118336220001 | ||||||
| MORRISON, Alexander Dunbar | Amministratore | 2 Lakeview Court Ermine Business Park PE29 6UA Huntingdon Lakeview House Cambridgeshire | England | British | 134747100003 | |||||
| REES, Daryl, Dr | Amministratore | Phytopharm Plc Corpus Christi House 9 West Street PE29 2HY Godmanchester Cambridgeshire | United Kingdom | British | 112434690003 | |||||
| RUBIN, Ian Duncan, Dr | Amministratore | Hall Farm House 9 High Street Castle Donington DE74 2PP Leicester | British | 46816200002 | ||||||
| SHARPINGTON, Timothy | Amministratore | The London Bioscience Innovation Centre 2 Royal College Street NW1 0NH Greater London | England | English | 113846800001 | |||||
| SPICER, Charles Alexander Evan, Dr | Amministratore | c/o 4th Floor, Griffin Court Long Lane EC1A 9PN London 15 England | England | British | 99923640001 | |||||
| TAYLOR, Alistair Henderson | Amministratore | 2 Lakeview Court Ermine Business Park PE29 6UA Huntingdon Lakeview House Cambridgeshire | England | British | 123442480002 | |||||
| WHITTLE, Brian Anthony | Amministratore | Mere Close Hull Road HU18 1RJ Hornsea East Yorkshire | British | 5696300001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di IXITECH LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ixico Plc | 06 apr 2016 | Long Lane EC1A 9PN London 15 Long Lane England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
IXITECH LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Single debenture | Creato il 20 ago 1990 Consegnato il 23 ago 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0