TAVERNER (1) LIMITED

TAVERNER (1) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTAVERNER (1) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02466749
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TAVERNER (1) LIMITED?

    • fabbricazione di articoli di plastica per edilizia (22230) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova TAVERNER (1) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Fibresec Holdings Ltd
    Snaygill Ind Estate
    BD23 2QR Keighley Road, Skipton
    North Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TAVERNER (1) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FOAM TECHNOLOGY LIMITED10 mar 199410 mar 1994
    ENGINEERING COMPOSITES LIMITED10 apr 199010 apr 1990
    SIMCO 311 LIMITED05 feb 199005 feb 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di TAVERNER (1) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TAVERNER (1) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TAVERNER (1) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 04 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 apr 2014

    Stato del capitale al 09 apr 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed foam technology LIMITED\certificate issued on 30/10/13
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name30 ott 2013

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 06 ott 2013

    RES15

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 02 ott 2013

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Martin Paul Heath il 18 ott 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Peter Thompson il 15 mar 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Ann Jacqueline Preston il 15 mar 2012

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Peter Thompson il 04 mar 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    2 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    2 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di TAVERNER (1) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRESTON, Ann Jacqueline
    C/O Fibresec Holdings Ltd
    Snaygill Ind Estate
    BD23 2QR Keighley Road, Skipton
    North Yorkshire
    Segretario
    C/O Fibresec Holdings Ltd
    Snaygill Ind Estate
    BD23 2QR Keighley Road, Skipton
    North Yorkshire
    British110426760001
    HEATH, Martin Paul
    C/O Fibresec Holdings Ltd
    Snaygill Ind Estate
    BD23 2QR Keighley Road, Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    C/O Fibresec Holdings Ltd
    Snaygill Ind Estate
    BD23 2QR Keighley Road, Skipton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish20585800006
    THOMPSON, Ian Peter
    C/O Fibresec Holdings Ltd
    Snaygill Ind Estate
    BD23 2QR Keighley Road, Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    C/O Fibresec Holdings Ltd
    Snaygill Ind Estate
    BD23 2QR Keighley Road, Skipton
    North Yorkshire
    EnglandBritish46127620002
    JENNINGS, Michael
    Unit 2
    Snaygill Industrial Estate
    Keighley Road
    Skipton
    North Yorkshire
    Segretario
    Unit 2
    Snaygill Industrial Estate
    Keighley Road
    Skipton
    North Yorkshire
    British30584730001
    LEESING, Brian
    Limestones Back Lane
    Old Edlington
    DN12 1QA Doncaster
    South Yorkshire
    Segretario
    Limestones Back Lane
    Old Edlington
    DN12 1QA Doncaster
    South Yorkshire
    British19080600002
    THOMPSON, Ian Peter
    Merrimead
    Constable Road
    LS29 8RW Ben Rhydding Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    Merrimead
    Constable Road
    LS29 8RW Ben Rhydding Ilkley
    West Yorkshire
    British46127620002
    WATSON, Keith
    18 Harrowby Road
    LS16 5HX Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    18 Harrowby Road
    LS16 5HX Leeds
    West Yorkshire
    British33828510001
    CROSSLAND, John Stuart
    Park House Bankwell
    Giggleswick
    BD24 0AP Settle
    North Yorkshire
    Amministratore
    Park House Bankwell
    Giggleswick
    BD24 0AP Settle
    North Yorkshire
    EnglandBritish83891300001
    JENNINGS, Michael
    Mickleden Ladder Banks Lane
    Baildon Shipley
    Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Mickleden Ladder Banks Lane
    Baildon Shipley
    Bradford
    West Yorkshire
    British1951910001
    KEMP, Steven
    11 Coppy Road
    Addingham
    LS29 Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    11 Coppy Road
    Addingham
    LS29 Ilkley
    West Yorkshire
    British39217900002
    LEESING, Brian
    Limestones Back Lane
    Old Edlington
    DN12 1QA Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Limestones Back Lane
    Old Edlington
    DN12 1QA Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritish19080600002
    PARDOE, Trevor William
    Woodstock House Bleach Mill Lane
    Menston
    LS29 6AN Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Woodstock House Bleach Mill Lane
    Menston
    LS29 6AN Ilkley
    West Yorkshire
    British3465590001
    TURNER, David Deacon
    Swinnow Hill York Road
    LS22 5EL Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Swinnow Hill York Road
    LS22 5EL Wetherby
    West Yorkshire
    British3465600001
    TURNER, John Deacon
    15 Bracken Park
    Scarcroft
    LS14 3HZ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    15 Bracken Park
    Scarcroft
    LS14 3HZ Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish1140750002

    TAVERNER (1) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite debenture & guarantee
    Creato il 11 set 1992
    Consegnato il 29 set 1992
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of theother companies named therein to the chargee under the terms of the loanstock agreement(as defined) and this charge
    Brevi particolari
    See form 395 ref M439C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bayford & Co.Limitedas Agent for the Stockholder
    Transazioni
    • 29 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 11 set 1992
    Consegnato il 24 set 1992
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    For full details see form 395 tc ref: M346C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 24 gen 1991
    Consegnato il 06 feb 1991
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 feb 1991Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0