PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED

PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02467508
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP in data 14 set 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 04 set 2012

    LRESSP

    Nomina di Mr Kenneth Mcintyre Carlaw come amministratore in data 28 ago 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nigel Paul Featham come amministratore in data 28 ago 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard Anthony Bowler come amministratore in data 28 ago 2012

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 26 mag 2012

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 14 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 dic 2011

    Stato del capitale al 16 dic 2011

    • Capitale: GBP 220,002
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Nomina di Nigel Paul Featham come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jonathan May come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 14 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 14 dic 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jonathan Paul May il 14 dic 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Anthony Bowler il 14 dic 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    9 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    9 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Segretario
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    British102907000002
    CARLAW, Kenneth Mcintyre
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    Amministratore
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    EnglandBritish161250030001
    CAMPBELL, David Gerard
    47 Ridgely Drive
    Ponteland
    NE20 9BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    47 Ridgely Drive
    Ponteland
    NE20 9BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British8159840001
    JONES, Michael Adrian
    5 Sandycroft
    Warsash
    SO31 9AA Southampton
    Hampshire
    Segretario
    5 Sandycroft
    Warsash
    SO31 9AA Southampton
    Hampshire
    British36134870001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    Segretario
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    42985760001
    BAYFIELD, Stephen
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    British42058550001
    BOWLER, Richard Anthony
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish35116070001
    FEATHAM, Nigel Paul
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish161124990001
    FICKLING, John Matthew
    62 Gainsborough Close
    NE25 9XB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Amministratore
    62 Gainsborough Close
    NE25 9XB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British40818470001
    JONES, Michael Adrian
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish77984700001
    KENNAN, Anthony Denis
    13 The Poplars
    Gosforth
    NE3 4AE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    13 The Poplars
    Gosforth
    NE3 4AE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British8159860001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Amministratore
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritish4971910001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001
    MAY, Jonathan Paul
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish125675730002
    MONAGHAN, David Bell
    43 Well Ridge Close
    Redhouse Farm
    NE25 9PN Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Amministratore
    43 Well Ridge Close
    Redhouse Farm
    NE25 9PN Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British35862500001
    NOBLE, Stephen Leslie
    Brewery Close
    Stamfordham
    NE18 0PQ Northumberland
    Close House
    United Kingdom
    Amministratore
    Brewery Close
    Stamfordham
    NE18 0PQ Northumberland
    Close House
    United Kingdom
    United KingdomBritish128655430001
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Amministratore
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    British58415290001
    WATT, Gordon George
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish67622780002
    WILLIAMS, Dawson Thomas
    Chately Wood House
    Rockford
    BH24 3LZ Ringwood
    Hampshire
    Amministratore
    Chately Wood House
    Rockford
    BH24 3LZ Ringwood
    Hampshire
    British2719600006

    PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Chattel mortgage
    Creato il 29 dic 1994
    Consegnato il 29 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from kentish bus & coach company limited and northumbria - motor services limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the vehicles as described in the schedule to the form 395 including 17 x leyland olympian double decker buses and 2 x optare delta buses. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 29 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge and set-off over credit balances
    Creato il 15 ago 1994
    Consegnato il 31 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994
    Brevi particolari
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 11 ago 1994
    Consegnato il 26 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the loan agreement dated 4TH may 1994, any interest rate agreement, or any of the security documents (as defined in the charge)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston"the Agent"
    Transazioni
    • 26 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 13 lug 1990
    Consegnato il 23 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever (see form 395 for further details)
    Brevi particolari
    (See form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 23 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 06 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 lug 1990
    Consegnato il 23 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for standard chartered bank and dresdner bank A.G. pursuant to a loan agreement of even date and under the terms of the charge
    Brevi particolari
    (See form 395 for further details of specific property). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank(As Agent and Trustee)
    Transazioni
    • 23 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 06 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 apr 2013Data di scioglimento
    04 set 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praticante
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Andrew Timothy Clay
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praticante
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0