ASPECT VENTURES LIMITED

ASPECT VENTURES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàASPECT VENTURES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02468264
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ASPECT VENTURES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ASPECT VENTURES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Resolve Advisory Limited
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ASPECT VENTURES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE LANGDALE GROUP LIMITED02 apr 199002 apr 1990
    THE LANGDALE GROUP LIMITED02 apr 199002 apr 1990
    LEGIBUS 1520 LIMITED08 feb 199008 feb 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di ASPECT VENTURES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 apr 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per ASPECT VENTURES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 gen 2021

    10 pagineLIQ03

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Indirizzo della sede legale modificato da Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom a Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU in data 27 gen 2020

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 16 gen 2020

    LRESSP

    Stato del capitale al 30 dic 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 29 apr 2018

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mr Richard Smothers come amministratore in data 31 gen 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kirk Dyson Davis come amministratore in data 31 gen 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 apr 2017

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 01 mag 2016

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    19 pagineAR01
    Note
    DataNota
    30 nov 2016Replacement This document replaces the AR01 registered on 04/01/2012 as it was not properly delivered

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    22 pagineAR01
    Note
    DataNota
    30 nov 2016Replacement This document replaces the AR01 registered on 04/01/2011 as it was not properly delivered

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    22 pagineAR01
    Note
    DataNota
    30 nov 2016Replacement This document replaces the AR01 registered on 04/01/2010 as it was not properly delivered

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Chi sono gli amministratori di ASPECT VENTURES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Segretario
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    207524030001
    SMOTHERS, Richard
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Amministratore
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish242658700001
    BRIDGE, John Nigel
    Millhouse
    Parkstile Lane
    L11 0BG Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    Millhouse
    Parkstile Lane
    L11 0BG Liverpool
    Merseyside
    British39560640001
    DOWNIE, Robert Arran
    Glendale
    Horrocks Road Edgworth
    BL7 0QJ Bolton
    Lancashire
    Segretario
    Glendale
    Horrocks Road Edgworth
    BL7 0QJ Bolton
    Lancashire
    British97033480001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Segretario
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180591790001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172444930001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEVENS, Mark
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    Segretario
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    British80951870001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181022150001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Segretario
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164754670001
    CRICHTON, Roger Wells
    Pitsford House West
    Manor Road, Pitsford
    NN6 9AR Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Pitsford House West
    Manor Road, Pitsford
    NN6 9AR Northampton
    Northamptonshire
    British67937290001
    CUMMING, Johanna Louise
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    Amministratore
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    United KingdomBritish111108910001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158484730001
    DOWNIE, Robert Arran
    Glendale
    Horrocks Road Edgworth
    BL7 0QJ Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    Glendale
    Horrocks Road Edgworth
    BL7 0QJ Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish97033480001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    DYSON, Ian
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish154003250001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish170184800001
    HOMER, Colin David
    39 The Avenue
    Ingol
    PR2 7AX Preston
    Lancashire
    Amministratore
    39 The Avenue
    Ingol
    PR2 7AX Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish1850120001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Amministratore
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    IZATT, George Gordon Maclean
    11 Broom Road
    KY13 8BU Kinross
    Kinross Shire
    Amministratore
    11 Broom Road
    KY13 8BU Kinross
    Kinross Shire
    United KingdomBritish895970001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Amministratore
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritish47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86246470001
    KNIGHT, Andrew Ronald
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    Amministratore
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    British81555100002
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135408140001
    LESLIE, John Stewart
    Bec House Church End
    HP27 9PD Bledlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Bec House Church End
    HP27 9PD Bledlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish59934350001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish170590800001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002

    Chi sono le persone con controllo significativo di ASPECT VENTURES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    06 apr 2016
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione4872046
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ASPECT VENTURES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Amendment and restatement deed
    Creato il 07 lug 2006
    Consegnato il 21 lug 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each security provider or any other security provider to the chargee or any of the other borrower group secured creditors on any account whatsoever. All monies due or to become due from each security provider and/or any other security provider and/or the punch borrower to the chargee or any of the other junior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Real property scottish property ancillary property rights shares contractual rights insurance intellectual property book debts accounts licences and consents. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Truste Company Limited in Its Capacity as the "Issuer Security Trustee" and "Borrowergroup Security Trustee"
    Transazioni
    • 21 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental deed of charge
    Creato il 21 mar 2006
    Consegnato il 31 mar 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any other security provider and/or the punch borrower or any of the other junior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H abbey 944 chesterfield road sheffield t/no SYK428293,f/h abington park brewery wellingborough road northampton t/no NN160993,f/h adam & eve high street homerton t/no EGL413814 (for details of further properties charged please refer to form 395) all estates or interests in such property and all buildings,trade and other fixtures,fixed plant and machinery from time to time on such f/h or l/h property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Trustee Company Limited as Agent and Trustee for the Borrower Secured Parties
    Transazioni
    • 31 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Borrower group deed of charge
    Creato il 25 nov 2004
    Consegnato il 13 dic 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other security provider to the borrower group security trustee or any of the other borrower group secured creditors on any account whatsoever and all monies due or to become due from the company and/or any other security provider and/or bankco and/or loanco to the borrower group security trustee or any of the other junior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a abbey 944 chesterfield road sheffield t/no SYK428293, f/h property k/a abington park brewery wellingborough road northampton t/no NN160993, f/h property k/a adam & eve st james 81 & 82 petty france westminster london t/no LN211870. For details of further properties charged please refer to form 395. by way of fixed security all right title interest and benefit in to and under all shares stocks debentures and other securities and all dividends, the relevant documents, the insurance policies, the intellectual property rights, book debts and floating charge all undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Trustee Company Limited (As Trustee for the Borrower Secured Parties)
    Transazioni
    • 13 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security agreement
    Creato il 15 dic 2003
    Consegnato il 31 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Ansty arms, coventry f/h t/n's WK251251 & WK251242. Bay horse, wigan f/h t/n's GM85094 & GM484585. Berkshire arms, nr newbury f/h t/n BK249470 for details of further property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transazioni
    • 31 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 15 dic 2003
    Consegnato il 31 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transazioni
    • 31 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 giu 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 07 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ASPECT VENTURES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 gen 2020Inizio della liquidazione
    25 apr 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon Jagger
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    Praticante
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    Ben David Woodthorpe
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Praticante
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0