MITEK COMPUTER COMPONENTS LIMITED

MITEK COMPUTER COMPONENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMITEK COMPUTER COMPONENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02469968
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MITEK COMPUTER COMPONENTS LIMITED?

    • (7260) /

    Dove si trova MITEK COMPUTER COMPONENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3 Rosevale Business Park
    Rosevale Road
    ST5 7UB Newcastle-Under-Lyme
    Staffordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MITEK COMPUTER COMPONENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MITEK GROUP LIMITED29 mar 199429 mar 1994
    FINANCEDATE LIMITED14 feb 199014 feb 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di MITEK COMPUTER COMPONENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2005

    Quali sono le ultime deposizioni per MITEK COMPUTER COMPONENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    legacy

    1 pagine288b

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 04 lug 2006

    2 pagine1.3

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    5 pagine1.4

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    3 pagine1.1

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 mar 2005

    22 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di MITEK COMPUTER COMPONENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HYRE, Satbinderpal Singh
    42 Lytham Road
    Perton
    WV6 7YY Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    42 Lytham Road
    Perton
    WV6 7YY Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritishSales Manager111959520001
    GREATOREX, Ian
    The Old Coach House
    4, Park Vale Road
    SK11 8AR Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    The Old Coach House
    4, Park Vale Road
    SK11 8AR Macclesfield
    Cheshire
    BritishAccountant111957800001
    HANKEY, Kelly Jane
    6 Westholme Close
    CW12 4FZ Congleton
    Cheshire
    Segretario
    6 Westholme Close
    CW12 4FZ Congleton
    Cheshire
    BritishSales Executive110490520001
    HOWARD, Joseph William
    101 St Georges Road
    BL1 2BY Bolton
    Lancashire
    Segretario
    101 St Georges Road
    BL1 2BY Bolton
    Lancashire
    BritishChartered Accountant8789820001
    ROACH, Jacqueline Frances
    6 Lake View
    Astbury Mere
    CW12 4FP Congleton
    Cheshire
    Segretario
    6 Lake View
    Astbury Mere
    CW12 4FP Congleton
    Cheshire
    BritishDirector12644760001
    ROACH, Jacqueline Frances
    6 Lake View
    Astbury Mere
    CW12 4FP Congleton
    Cheshire
    Segretario
    6 Lake View
    Astbury Mere
    CW12 4FP Congleton
    Cheshire
    BritishDirector12644760001
    ROACH, Malcolm David
    22 Oak Drive
    ST7 3LY Scholar Green
    Cheshire
    Segretario
    22 Oak Drive
    ST7 3LY Scholar Green
    Cheshire
    BritishCredit Manager92070380001
    ROACH, Mark Damion
    6 Lakeview
    Astbury Mere
    CW12 4FP Congleton
    Cheshire
    Segretario
    6 Lakeview
    Astbury Mere
    CW12 4FP Congleton
    Cheshire
    British57429240001
    SPOONER, Paul Rodney
    Post Box Cottage
    Wall Hill
    CW12 4TE Congleton
    Cheshire
    Segretario
    Post Box Cottage
    Wall Hill
    CW12 4TE Congleton
    Cheshire
    BritishOperations Director40878670001
    BISHTON, Paul Neil
    85 Ennerdale Drive
    CW12 4FJ Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    85 Ennerdale Drive
    CW12 4FJ Congleton
    Cheshire
    United KingdomBritishSales Director80342690001
    DEOL, Hardip Singh
    171 Warwick Road
    B92 7AW Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    171 Warwick Road
    B92 7AW Solihull
    West Midlands
    BritishDirector109512210001
    LARKIN, Michael Scott
    12 Goldney Court
    Horsehay
    TF4 3UH Telford
    Shropshire
    Amministratore
    12 Goldney Court
    Horsehay
    TF4 3UH Telford
    Shropshire
    BritishSales Manager94365430001
    MATTHEWS, Robert Morton
    12 Blackbird Way
    Biddulph
    ST8 7UH Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    12 Blackbird Way
    Biddulph
    ST8 7UH Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishFinance Director104245720001
    ROACH, Jacqueline Frances
    6 Lake View
    Astbury Mere
    CW12 4FP Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    6 Lake View
    Astbury Mere
    CW12 4FP Congleton
    Cheshire
    BritishDirector12644760001
    ROACH, Malcolm David
    22 Oak Drive
    ST7 3LY Scholar Green
    Cheshire
    Amministratore
    22 Oak Drive
    ST7 3LY Scholar Green
    Cheshire
    United KingdomBritishCo Director92070380001
    ROACH, Mark Damion
    6 Westholme Close
    CW12 4FZ Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    6 Westholme Close
    CW12 4FZ Congleton
    Cheshire
    EnglandBritishPurchasing Manager57429240002
    SPOONER, Paul Rodney
    Post Box Cottage
    Wall Hill
    CW12 4TE Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    Post Box Cottage
    Wall Hill
    CW12 4TE Congleton
    Cheshire
    BritishGeneral Manager40878670001

    MITEK COMPUTER COMPONENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 21 mag 2003
    Consegnato il 23 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Enterprise Finance Europe (UK) LTD
    Transazioni
    • 23 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 21 giu 2000
    Consegnato il 23 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement for ibm global financing dated 13TH june 2000
    Brevi particolari
    All book and other debts and full benefit of the rights and remedies thereon; floating charge over the company's stock-in-trade and all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ibm United Kingdom Financial Services Limited
    Transazioni
    • 23 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 02 lug 1998
    Consegnato il 04 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under an agreement for the purchase of debts between the company and the chargee or otherwise
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Griffin Credit Services Limited
    Transazioni
    • 04 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 apr 1998
    Consegnato il 16 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as mitek house greenfield farm trading estate congleton cheshire title number CH332640. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 15 mag 1996
    Consegnato il 28 mag 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge by way of debenture
    Creato il 08 set 1994
    Consegnato il 10 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to or in connection with the financing agreement or on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 10 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 18 gen 1994
    Consegnato il 02 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land on the north east side of sands road harriseahead newcastle under lyme staffordshire t/n SF255700 and/or the proceeds of sale thereof the entry in col.6 Above has this day been amended please see doc.M27L.R.M.groves 12/5/94. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MITEK COMPUTER COMPONENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 ott 2005Data della riunione per approvare il CVA
    20 giu 2006Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Njh Smith
    Vantis Business Recovery
    Torrington House
    AL1 1HD 47 Holywell Hill
    St Albans
    Praticante
    Vantis Business Recovery
    Torrington House
    AL1 1HD 47 Holywell Hill
    St Albans
    Michael William Young
    Vantis Business Recovery
    Torrington House
    AL1 1HD 47 Holywell Hill
    St Albans Herts
    Praticante
    Vantis Business Recovery
    Torrington House
    AL1 1HD 47 Holywell Hill
    St Albans Herts

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0