NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02470056 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 140 Aldersgate Street EC1A 4HY London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| GLE PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | 14 feb 1990 | 14 feb 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2020 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Steven Carl Wright come amministratore in data 08 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Arthur Rushton come amministratore in data 11 dic 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2019 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 9 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2018 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Steven Carl Wright come amministratore in data 14 nov 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2017 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Greater London Enterprise Investments Limited come persona con controllo significativo il 07 ott 2016 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 40 Aldersgate Street London EC1A 4HY England a 140 Aldersgate Street London EC1A 4HY in data 25 apr 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 10-12 Queen Elizabeth Street London SE1 2JN England a 40 Aldersgate Street London EC1A 4HY in data 24 apr 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 5th Floor Valiant Building 14 South Parade Leeds LS1 5QS a 10-12 Queen Elizabeth Street London SE1 2JN in data 06 ott 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael Hofman come segretario in data 31 mag 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Bernard Walsh come segretario in data 31 mag 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOFMAN, Michael | Segretario | Aldersgate Street EC1A 4HY London 140 England | 209188220001 | |||||||
| MANSON, Christopher John | Amministratore | Aldersgate Street EC1A 4HY London 140 England | United Kingdom | British | 175493670001 | |||||
| WALSH, Michael Bernard | Amministratore | Aldersgate Street EC1A 4HY London 140 England | England | British | 74086660002 | |||||
| CHAPMAN, Paul Stephen | Segretario | 13 Southbourne Hayes BR2 7NJ Bromley Kent | British | 1403010005 | ||||||
| GERVASIO, James Ernest Peter | Segretario | Chapeltown Road LS7 4HZ Leeds Saint Martins House 210-212 West Yorkshire | British | 2093810001 | ||||||
| NOEL, Dawn | Segretario | 6 Cantley Road Hanwell W7 2BQ London | British | 79021070001 | ||||||
| WALSH, Michael Bernard | Segretario | 14 South Parade LS1 5QS Leeds 5th Floor Valiant Building England | 159189680001 | |||||||
| WOODALL, Michael David | Segretario | Glovers Cottage Reigate Hill RH2 9PN Reigate Surrey | British | 4777030001 | ||||||
| COMPTON, Colin Richard | Amministratore | Kingsland House Kingsland Lane Leavenheath CO6 4PD Colchester Essex | British | 12075710001 | ||||||
| LARGE, Martin Gerald | Amministratore | 14 South Parade LS1 5QS Leeds 5th Floor Valiant Building England | England | British | 44118740003 | |||||
| ROGERS, Mary | Amministratore | Basement Flat 46 Gordon Square WC1H 0PD London | British | 85165800001 | ||||||
| RUSHTON, Christopher Arthur | Amministratore | Aldersgate Street EC1A 4HY London 140 England | England | British | 44369580002 | |||||
| WRIGHT, Steven Carl | Amministratore | Aldersgate Street EC1A 4HY London 140 England | England | British | 232556880001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newable Uk Holdings Limited | 06 apr 2016 | Aldersgate Street EC1A 4HY London 140 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment of share sale agreement | Creato il 25 set 2001 Consegnato il 15 ott 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The company with full title guarantee assigns to the bank by way of charge all that an agreement relating inter alia to the sale by the company of it's shares in gle property developments (kingston) limited dated 02 february 2001... see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment of building contract | Creato il 25 set 2001 Consegnato il 15 ott 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The company with full title guarantee assigns to the bank by way of charge all that the agreement dated 05 june 2001 and the full benefit thereof and the benefit of any claims or compensation whatsoever arising thereunder... See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge on shares | Creato il 25 set 2001 Consegnato il 15 ott 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All of the company's obligations to the chargee (or any company which is a member of the same group of companies of the bank) of any kind and in any currency | |
Brevi particolari The one ordinary share held by the company in gle property developments (kingston) limited (which constitutes the entire issued share capital of that company) together with all other stocks, shares, bonds, or other securities at any time deposited with or transferred to the bank or its nominee by the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment of building contract | Creato il 28 feb 2001 Consegnato il 14 mar 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Building contract means the agreement dated the 6 february 2001 made between the customer and the contractor and includes the drawings specifications and attachments referred to therein contractor means buxton building contractors limited c/number 2261235 of cedar house 91 high street caterham surrey CR3 5UH. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 28 feb 2001 Consegnato il 14 mar 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of legal charge | Creato il 28 feb 2001 Consegnato il 14 mar 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The property k/a land and premises at st georges square (west) gore street deptford london SE8 t/n TGL182465. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 24 mag 1994 Consegnato il 26 mag 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H-part of number 90 and the wholes of numbers 92 to 104 (even) newington butts kennington london. Fixed charge over the plant machinery and fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils of the company and the present or future goodwill of any business. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 06 dic 1993 Consegnato il 13 dic 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 112,114,116,118,120,122,124 newington butts and 76/77 holyoak road kenniongton t/ns ln 13388 sgl 298102. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 19 nov 1993 Consegnato il 24 nov 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H-land lying to the north east of therapia lane L.B. of sutton land and buildings to the north east of therapia lane L.B. of sutton and land on the south east side of the south east of the junction of therapia lane and beddington lane beddington L.B. of sutton greater london t/n-SGL532994, SGL556142, SGL213815. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 19 ago 1993 Consegnato il 26 ago 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge | |
Brevi particolari F/H- parcels of land in boot street hoxton market shoreditch london N1 t/n-EGL287091. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter | Creato il 18 ago 1993 Consegnato il 01 set 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the letter | |
Brevi particolari Cash sum of £4,000. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 31 gen 1992 Consegnato il 20 feb 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £200,000 | |
Brevi particolari F/H land containing 5.81 acres or thereabouts at therapia lane off beddington lane L.B. of sutton. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 31 gen 1992 Consegnato il 20 feb 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land containing 5.81 acres or thereabouts at therapia lane off beddington lane L.B. of sutton together with all buildings and fixtures fixed charge on all attached plant and machinery and other chattels floatings charge over all unattached plant and machinery and other chattels. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0