NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED

NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02470056
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    140 Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GLE PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED14 feb 199014 feb 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2020

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Steven Carl Wright come amministratore in data 08 nov 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christopher Arthur Rushton come amministratore in data 11 dic 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2019

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 mar 2018

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Steven Carl Wright come amministratore in data 14 nov 2017

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 mar 2017

    20 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Greater London Enterprise Investments Limited come persona con controllo significativo il 07 ott 2016

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 40 Aldersgate Street London EC1A 4HY England a 140 Aldersgate Street London EC1A 4HY in data 25 apr 2017

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 10-12 Queen Elizabeth Street London SE1 2JN England a 40 Aldersgate Street London EC1A 4HY in data 24 apr 2017

    1 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name07 ott 2016

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 07 ott 2016

    RES15

    Indirizzo della sede legale modificato da 5th Floor Valiant Building 14 South Parade Leeds LS1 5QS a 10-12 Queen Elizabeth Street London SE1 2JN in data 06 ott 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    24 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mr Michael Hofman come segretario in data 31 mag 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Michael Bernard Walsh come segretario in data 31 mag 2016

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HOFMAN, Michael
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Segretario
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    209188220001
    MANSON, Christopher John
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Amministratore
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    United KingdomBritish175493670001
    WALSH, Michael Bernard
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Amministratore
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    EnglandBritish74086660002
    CHAPMAN, Paul Stephen
    13 Southbourne
    Hayes
    BR2 7NJ Bromley
    Kent
    Segretario
    13 Southbourne
    Hayes
    BR2 7NJ Bromley
    Kent
    British1403010005
    GERVASIO, James Ernest Peter
    Chapeltown Road
    LS7 4HZ Leeds
    Saint Martins House 210-212
    West Yorkshire
    Segretario
    Chapeltown Road
    LS7 4HZ Leeds
    Saint Martins House 210-212
    West Yorkshire
    British2093810001
    NOEL, Dawn
    6 Cantley Road
    Hanwell
    W7 2BQ London
    Segretario
    6 Cantley Road
    Hanwell
    W7 2BQ London
    British79021070001
    WALSH, Michael Bernard
    14 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    5th Floor Valiant Building
    England
    Segretario
    14 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    5th Floor Valiant Building
    England
    159189680001
    WOODALL, Michael David
    Glovers Cottage Reigate Hill
    RH2 9PN Reigate
    Surrey
    Segretario
    Glovers Cottage Reigate Hill
    RH2 9PN Reigate
    Surrey
    British4777030001
    COMPTON, Colin Richard
    Kingsland House Kingsland Lane
    Leavenheath
    CO6 4PD Colchester
    Essex
    Amministratore
    Kingsland House Kingsland Lane
    Leavenheath
    CO6 4PD Colchester
    Essex
    British12075710001
    LARGE, Martin Gerald
    14 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    5th Floor Valiant Building
    England
    Amministratore
    14 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    5th Floor Valiant Building
    England
    EnglandBritish44118740003
    ROGERS, Mary
    Basement Flat
    46 Gordon Square
    WC1H 0PD London
    Amministratore
    Basement Flat
    46 Gordon Square
    WC1H 0PD London
    British85165800001
    RUSHTON, Christopher Arthur
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Amministratore
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    EnglandBritish44369580002
    WRIGHT, Steven Carl
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Amministratore
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    EnglandBritish232556880001

    Chi sono le persone con controllo significativo di NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Newable Uk Holdings Limited
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    06 apr 2016
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales Companies Register
    Numero di registrazione5547054
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignment of share sale agreement
    Creato il 25 set 2001
    Consegnato il 15 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The company with full title guarantee assigns to the bank by way of charge all that an agreement relating inter alia to the sale by the company of it's shares in gle property developments (kingston) limited dated 02 february 2001... see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of building contract
    Creato il 25 set 2001
    Consegnato il 15 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The company with full title guarantee assigns to the bank by way of charge all that the agreement dated 05 june 2001 and the full benefit thereof and the benefit of any claims or compensation whatsoever arising thereunder... See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge on shares
    Creato il 25 set 2001
    Consegnato il 15 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All of the company's obligations to the chargee (or any company which is a member of the same group of companies of the bank) of any kind and in any currency
    Brevi particolari
    The one ordinary share held by the company in gle property developments (kingston) limited (which constitutes the entire issued share capital of that company) together with all other stocks, shares, bonds, or other securities at any time deposited with or transferred to the bank or its nominee by the company.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of building contract
    Creato il 28 feb 2001
    Consegnato il 14 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Building contract means the agreement dated the 6 february 2001 made between the customer and the contractor and includes the drawings specifications and attachments referred to therein contractor means buxton building contractors limited c/number 2261235 of cedar house 91 high street caterham surrey CR3 5UH. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 feb 2001
    Consegnato il 14 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 20 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of legal charge
    Creato il 28 feb 2001
    Consegnato il 14 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a land and premises at st georges square (west) gore street deptford london SE8 t/n TGL182465.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 mag 1994
    Consegnato il 26 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H-part of number 90 and the wholes of numbers 92 to 104 (even) newington butts kennington london. Fixed charge over the plant machinery and fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils of the company and the present or future goodwill of any business.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 dic 1993
    Consegnato il 13 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    112,114,116,118,120,122,124 newington butts and 76/77 holyoak road kenniongton t/ns ln 13388 sgl 298102. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 nov 1993
    Consegnato il 24 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-land lying to the north east of therapia lane L.B. of sutton land and buildings to the north east of therapia lane L.B. of sutton and land on the south east side of the south east of the junction of therapia lane and beddington lane beddington L.B. of sutton greater london t/n-SGL532994, SGL556142, SGL213815.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 24 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 ago 1993
    Consegnato il 26 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H- parcels of land in boot street hoxton market shoreditch london N1 t/n-EGL287091. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter
    Creato il 18 ago 1993
    Consegnato il 01 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the letter
    Brevi particolari
    Cash sum of £4,000.
    Persone aventi diritto
    • Snowcem Pmc Limited
    Transazioni
    • 01 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 1992
    Consegnato il 20 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £200,000
    Brevi particolari
    F/H land containing 5.81 acres or thereabouts at therapia lane off beddington lane L.B. of sutton.
    Persone aventi diritto
    • Blue Circle Industries PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 1992
    Consegnato il 20 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land containing 5.81 acres or thereabouts at therapia lane off beddington lane L.B. of sutton together with all buildings and fixtures fixed charge on all attached plant and machinery and other chattels floatings charge over all unattached plant and machinery and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0