NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.

NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02475402
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.?

    • (7222) /

    Dove si trova NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    2nd Floor
    79 Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CAMBRIDGE ANIMATION SYSTEMS LIMITED22 mar 199022 mar 1990
    FELTONIAN LIMITED28 feb 199028 feb 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2008

    9 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2007

    7 pagineAA

    legacy

    8 pagine363a

    legacy

    6 pagine363a

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed cambridge animation systems LIMITED\certificate issued on 19/01/09
    3 pagineCERTNM

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 08 gen 2009

    2 pagine1.3

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    5 pagine1.4

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 22 set 2008

    9 pagine1.3

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 22 set 2007

    10 pagine1.3

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2006

    9 pagineAA

    Varie

    Supervisor's report
    5 pagineMISC

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 22 set 2006

    2 pagine1.3

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2005

    11 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288b

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 22 set 2005

    3 pagine1.3

    Chi sono gli amministratori di NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PS LAW SECRETARIES LIMITED
    Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    79
    Segretario
    Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    79
    81576980001
    SLEVIN, Cormac Brian
    62 Brampton Road
    CB1 3HL Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    62 Brampton Road
    CB1 3HL Cambridge
    Cambridgeshire
    Irish98972470001
    FLORENCE, Peter Charles
    34 Grafton Street
    CB1 1DS Cambridge
    Segretario
    34 Grafton Street
    CB1 1DS Cambridge
    British50715100001
    HOLLAND, Stephen John William
    35 Woodlands Park
    CB3 0QB Girton
    Cambridgeshire
    Segretario
    35 Woodlands Park
    CB3 0QB Girton
    Cambridgeshire
    British79873930001
    MCCALL, Ruth
    18 Milman Road
    Queens Park
    NW6 6EJ London
    Segretario
    18 Milman Road
    Queens Park
    NW6 6EJ London
    British51783880001
    O'CONNOR, Christopher Patrick, Mr.
    Willow Cottage
    School Lane
    CB23 4ND Boxworth
    Cambridgeshire
    Segretario
    Willow Cottage
    School Lane
    CB23 4ND Boxworth
    Cambridgeshire
    British3751430003
    SHIRREN, Gerry
    Kiltale
    IRISH Dunsany
    Co Meath
    Ireland
    Segretario
    Kiltale
    IRISH Dunsany
    Co Meath
    Ireland
    Irish97685400001
    VIS, Annemarie Mirjam Frederique
    37 Martingale Close
    CB4 3TA Cambridge
    Segretario
    37 Martingale Close
    CB4 3TA Cambridge
    British52939100001
    WOOLLEY, Alastair John Lomond
    Charity Farmhouse
    Brinkley
    CB8 0SE Newmarket
    Suffolk
    Segretario
    Charity Farmhouse
    Brinkley
    CB8 0SE Newmarket
    Suffolk
    British89506550001
    PS LAW SECRETARIES LIMITED
    2nd Floor
    79 Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    Segretario
    2nd Floor
    79 Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    81576980001
    ABBOTT, Raymond James
    44 Coillesdene Avenue
    EH15 2JR Edinburgh
    Amministratore
    44 Coillesdene Avenue
    EH15 2JR Edinburgh
    British65699620002
    BAHNS, Robert Harold
    40a Parkhill Road
    NW3 2YP London
    Amministratore
    40a Parkhill Road
    NW3 2YP London
    British64794090001
    BARRETT, Philip James, Dr
    16 Kings Road
    PE19 1LD St. Neots
    Cambridgeshire
    Amministratore
    16 Kings Road
    PE19 1LD St. Neots
    Cambridgeshire
    EnglandBritish198025600001
    BEREND, Andrew Louis Charles
    145 King Henrys Road
    NW3 3RD London
    Amministratore
    145 King Henrys Road
    NW3 3RD London
    British24724970005
    CARRIGAN, Thomas Jay
    464 Notre Dame Road
    91711 Claremont
    Los Angeles
    Usa
    Amministratore
    464 Notre Dame Road
    91711 Claremont
    Los Angeles
    Usa
    American60077320001
    FERRIS, Gavin Robert, Dr
    29c Shanrod Road
    Katebridge
    BT32 5PG Banbridge
    County Down
    Northern Ireland
    Amministratore
    29c Shanrod Road
    Katebridge
    BT32 5PG Banbridge
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish107911580001
    FLORENCE, Peter Charles
    34 Mornington Crescent
    NW1 7RE London
    Amministratore
    34 Mornington Crescent
    NW1 7RE London
    United KingdomBritish50715100002
    FLORENCE, Peter Charles
    34 Grafton Street
    CB1 1DS Cambridge
    Amministratore
    34 Grafton Street
    CB1 1DS Cambridge
    British50715100001
    HAYMAN, Anne Carolyn
    36 Lawford Road
    NW5 2LN London
    Amministratore
    36 Lawford Road
    NW5 2LN London
    EnglandBritish32391350001
    HOLLAND, Stephen John William
    35 Woodlands Park
    CB3 0QB Girton
    Cambridgeshire
    Amministratore
    35 Woodlands Park
    CB3 0QB Girton
    Cambridgeshire
    British79873930001
    JACKSON, John Bernard Haysom
    Summit House
    Red Lion Square
    WC1R 4QB London
    Amministratore
    Summit House
    Red Lion Square
    WC1R 4QB London
    United KingdomBritish98731480001
    KELLY, William
    10 Peak Lane
    Portola Valley
    94028 California
    Usa
    Amministratore
    10 Peak Lane
    Portola Valley
    94028 California
    Usa
    American46464350001
    KORDA, Alexander Vincent
    Flat 7 8 St Quintin Avenue
    W10 6NU London
    Amministratore
    Flat 7 8 St Quintin Avenue
    W10 6NU London
    United KingdomBritish110996140001
    MCCALL, Ruth
    18 Milman Road
    Queens Park
    NW6 6EJ London
    Amministratore
    18 Milman Road
    Queens Park
    NW6 6EJ London
    British51783880001
    MITCHELL, John Ross, Dr
    123a London Road
    SG18 8EF Biggleswade
    Bedfordshire
    Amministratore
    123a London Road
    SG18 8EF Biggleswade
    Bedfordshire
    British54883260001
    O'CONNOR, Christopher Patrick, Mr.
    Willow Cottage
    School Lane
    CB23 4ND Boxworth
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Willow Cottage
    School Lane
    CB23 4ND Boxworth
    Cambridgeshire
    EnglandBritish3751430003
    OSBORN, Peter Gordon
    Northchurch Farm Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Northchurch Farm Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    British28389710001
    PETTMAN, Michael George
    The Ranch
    High Street
    SL6 5LT Hurley
    Bucks
    Amministratore
    The Ranch
    High Street
    SL6 5LT Hurley
    Bucks
    British23702430001
    RAMSAY, Michael
    13060 Alta Lane North
    Los Altos Hills
    California 94022
    Usa
    Amministratore
    13060 Alta Lane North
    Los Altos Hills
    California 94022
    Usa
    UsaBritish72705850001
    SCOGGINS, Ian Maxwell
    High Thicket
    Dockenfield
    GU10 4HB Farnham
    Surrey
    Amministratore
    High Thicket
    Dockenfield
    GU10 4HB Farnham
    Surrey
    British54583190001
    SOMPER, Nicholas John
    55 Brookland Rise
    NW11 6DT London
    Amministratore
    55 Brookland Rise
    NW11 6DT London
    British59505050001
    STEEL, Andrew Dewar
    Flat 2 3 Dean Path
    EH4 3BG Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    Flat 2 3 Dean Path
    EH4 3BG Edinburgh
    Midlothian
    British14788330002
    SWINSTEAD, Philip Edgar
    Flat 5
    60-61 Cheyne Walk
    SW3 5LX London
    Amministratore
    Flat 5
    60-61 Cheyne Walk
    SW3 5LX London
    British101634050001
    TYLER, Brian David
    64 Cavendish Avenue
    CB1 7UT Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    64 Cavendish Avenue
    CB1 7UT Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritish76611270001
    WATT, Mark
    14 Beaufort Place
    Thompsons Lane
    CB5 8AG Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    14 Beaufort Place
    Thompsons Lane
    CB5 8AG Cambridge
    Cambridgeshire
    British56960450001

    NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 11 apr 2001
    Consegnato il 18 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 dic 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 mar 1997
    Consegnato il 19 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 13TH march 1997 and the debenture
    Brevi particolari
    All of the assets and undertakings of the company except interest in leaseholds as at 13/3/97; shares in animax animation consortium limited and charges in respect of rent deposits not exceeding £50,000.
    Persone aventi diritto
    • Ivory & Sime Enterprise Capital PLC
    Transazioni
    • 19 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 11 mar 1997
    Consegnato il 28 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £3,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    £3,000 plus interest.
    Persone aventi diritto
    • Leonard Robert Martin
    Transazioni
    • 28 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of rent deposit
    Creato il 14 set 1995
    Consegnato il 15 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease made 14TH september 1995
    Brevi particolari
    The sum of £8,800.00 being the initial deposit placed in a deposit account by cambridge homes limited under the terms of the deed.
    Persone aventi diritto
    • Cambridge Homes Limited
    Transazioni
    • 15 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Creato il 16 feb 1994
    Consegnato il 19 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £50,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland (Stanlife) London Nominees Limited
    Transazioni
    • 19 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Creato il 16 feb 1994
    Consegnato il 19 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £20,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Monument Trust Company Limited
    Transazioni
    • 19 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Creato il 16 feb 1994
    Consegnato il 19 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £55,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ivory & Sime Enterprise Capital PLC
    Transazioni
    • 19 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Creato il 16 feb 1994
    Consegnato il 19 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £5,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • John Jackson
    Transazioni
    • 19 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Creato il 16 feb 1994
    Consegnato il 19 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £5,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Colin West
    Transazioni
    • 19 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Creato il 16 feb 1994
    Consegnato il 19 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Walbrook Trustees (Guernsey) Limited
    Transazioni
    • 19 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Creato il 16 feb 1994
    Consegnato il 19 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £50,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Korda Seed Capital Fund Limited Partnership
    Transazioni
    • 19 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 lug 1993
    Consegnato il 20 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 18 set 1992
    Consegnato il 26 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date and this charge
    Brevi particolari
    £14,900 and any other amount standing to the credit of the account.
    Persone aventi diritto
    • The Oceana Consolidated Company PLC
    Transazioni
    • 26 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 dic 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD. ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 set 2002Data della riunione per approvare il CVA
    08 gen 2009Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    James Alfred Lettice
    Peters Elworthy & Moore
    Salisbury House
    CB1 2LA Station Road
    Cambridge
    Praticante
    Peters Elworthy & Moore
    Salisbury House
    CB1 2LA Station Road
    Cambridge

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0