CRANDMILL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCRANDMILL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02475767
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CRANDMILL LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CRANDMILL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Vernon House
    23 Sicilian Avenue
    WC1A 2QS London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CRANDMILL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 set 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per CRANDMILL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    19 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 ago 2016

    13 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 ago 2016

    13 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da 10 Fitzroy Square London W1T 5HP a Vernon House 23 Sicilian Avenue London WC1A 2QS in data 28 set 2016

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 10 Fitzroy Square London W1T 5HP a 10 Fitzroy Square London W1T 5HP in data 27 ago 2015

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Suite a, 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill Nottingham NG1 5FS a 10 Fitzroy Square London W1T 5HP in data 27 ago 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Certificato di rimozione del liquidatore volontario

    1 pagine4.38

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 01 lug 2015

    17 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 01 lug 2014

    15 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Rsm Tenon Restructuring the Poynt 45 Wollaton Street Nottingham NG1 5FW* in data 07 lug 2014

    2 pagineAD01

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    2 pagineF10.2

    Indirizzo della sede legale modificato da * New Castle House Castle Boulevard Nottingham Nottinghamshire NG7 1FT England* in data 08 lug 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Conto per una società dormiente redatto al 29 set 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 mag 2013

    Stato del capitale al 30 mag 2013

    • Capitale: GBP 1,421,906
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 71 Queensway London W2 4QH England* in data 15 feb 2013

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 24 set 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 25 set 2010

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Diane Penfold come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di CRANDMILL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GALA CORAL SECRETARIES LIMITED
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Segretario
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    69240850005
    WILLITS, Harry Andrew
    23 Sicilian Avenue
    WC1A 2QS London
    Vernon House
    Amministratore
    23 Sicilian Avenue
    WC1A 2QS London
    Vernon House
    United KingdomBritish175965490001
    GALA CORAL NOMINEES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Amministratore
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    76454320002
    GALA CORAL PROPERTIES LIMITED
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Amministratore
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3720332
    154706420001
    ALLARD, Tyrone James
    Inis Smear
    Flemingston
    CF62 4QJ Barry
    South Glamorgan
    S Wales
    Segretario
    Inis Smear
    Flemingston
    CF62 4QJ Barry
    South Glamorgan
    S Wales
    British2343150002
    CHEATLE, Martyn David
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    British149874460001
    HODGES, Simon
    Meadowbank 102 Crosshill Street
    Lennoxtown
    G66 7HQ Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    Meadowbank 102 Crosshill Street
    Lennoxtown
    G66 7HQ Glasgow
    Lanarkshire
    British66090970001
    NOBLE, Michael Jeremy
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    Segretario
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    British32786810004
    OSZTREICHER, George
    44 Mill Road
    Lisvane
    CF14 0XL Cardiff
    South Glamorgan
    Segretario
    44 Mill Road
    Lisvane
    CF14 0XL Cardiff
    South Glamorgan
    British38265400001
    SINTON, Charles Blair Ritchie
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    Segretario
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    British52292450003
    SMERDON, Leigh
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Segretario
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Other89075910001
    ALLARD, Tyrone James
    Inis Smear
    Flemingston
    CF62 4QJ Barry
    South Glamorgan
    S Wales
    Amministratore
    Inis Smear
    Flemingston
    CF62 4QJ Barry
    South Glamorgan
    S Wales
    British2343150002
    CHISMAN, Ronald Neil
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    Amministratore
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    United KingdomBritish780950001
    CRONK, John Julian Tristam
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Amministratore
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    British6422100001
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    One The Shires
    RG41 4SZ Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    One The Shires
    RG41 4SZ Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish21686380003
    GRIFFITHS, Jonathan
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    Amministratore
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    British73691620003
    HARLEY, Susan Boyle
    Threeways Gills Hill Lane
    WD7 8DD Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    Threeways Gills Hill Lane
    WD7 8DD Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish41384040001
    JAMES, David Alan
    6 Cliffside
    CF64 5RG Penarth
    South Glamorgan
    Amministratore
    6 Cliffside
    CF64 5RG Penarth
    South Glamorgan
    British6644920001
    KELLY, John Michael
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish141916500001
    LACEY, Richard Edward
    33 Nettlecombe Avenue
    PO4 0QW Southsea
    Hampshire
    Amministratore
    33 Nettlecombe Avenue
    PO4 0QW Southsea
    Hampshire
    United KingdomBritish23299890001
    LAWRENCE, Raymond Geoffrey
    54 Llyswen Road
    Cyncoed
    CF2 6PP Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    54 Llyswen Road
    Cyncoed
    CF2 6PP Cardiff
    South Glamorgan
    British14582770001
    MATTINGLEY, Brian Roger
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    British22417130001
    MCCARVILL, James
    37 Brightside Avenue
    Uddingston
    G71 7NF Glasgow
    Amministratore
    37 Brightside Avenue
    Uddingston
    G71 7NF Glasgow
    British24036030002
    MICHELS, David Michael Charles
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    British4855250001
    OSZTREICHER, George
    44 Mill Road
    Lisvane
    CF14 0XL Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    44 Mill Road
    Lisvane
    CF14 0XL Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritish38265400001
    PAYNE, Ian Timothy
    The Elms 56 Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JZ Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    The Elms 56 Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JZ Solihull
    West Midlands
    British78974110002
    PENFOLD, Diane June
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Amministratore
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    United KingdomBritish59962430002
    ROBERTS, Edward Matthew Giles
    Gala Group Limited
    New Castle House Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Gala Group Limited
    New Castle House Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    British100607290001
    SANDERS, Philip John
    11 Wentworth Road
    Bloxwich
    WS3 3UN Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    11 Wentworth Road
    Bloxwich
    WS3 3UN Walsall
    West Midlands
    British42425320001
    SOWERBY, Richard Thomas Neville
    Oakmead Farm
    Ockham Lane
    KT13 8EN Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Oakmead Farm
    Ockham Lane
    KT13 8EN Cobham
    Surrey
    EnglandBritish47734920002
    STANLEY, Kate Emma
    5 The Barns
    West Leith
    HP23 6JJ Tring
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 The Barns
    West Leith
    HP23 6JJ Tring
    Hertfordshire
    British66637240001
    WAGGETT, Colin
    41 Spring Grove
    W4 3NH London
    Amministratore
    41 Spring Grove
    W4 3NH London
    British62266600001

    CRANDMILL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating security document
    Creato il 11 mag 2006
    Consegnato il 24 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 24 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security document
    Creato il 27 ott 2005
    Consegnato il 09 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 09 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security document
    Creato il 01 set 2005
    Consegnato il 20 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H high street acton london t/no AGL114684, f/h high street aldershot hants t/no HP517737, f/h anchor road aldridge walsall t/no WM167521 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 20 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creato il 11 feb 2005
    Consegnato il 18 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Senior Financeparties and the Mezzanine Finance Parties
    Transazioni
    • 18 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creato il 17 mar 2003
    Consegnato il 03 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party or any mezzanine finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Including 8-16 park chambers,park place,cardiff CF10 3DF; CYM5977; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Boston,London Branch,as Security Trustee for the Finance Parties and Themezzanine Finance Parties
    Transazioni
    • 03 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fifth supplemental and accession deed
    Creato il 21 dic 2000
    Consegnato il 11 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and liabilities (whether actual or contingent) which are at the date of the debenture or thereafter due owing or payable or expressed to be due owing or payable to any creditor (as defined) from or by any obligor (as defined) under or in connection with the facilities agreement,a hedging contract,the deposit agreement and charge on cash deposits or the debenture as such deeds and agreements may be amended or restated in the future
    Brevi particolari
    High street london W3 8BR,the ritz high street aldershot hants,essoldo milburn r oad nothumberland the real property (as defined) all plant machinery and equipment all right title and interest in the investments described in the continuation to form 395,goodwill,book debts.policies of insurance and by way of first floating charge all property and assets of the company for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New Yorkas Security Agent and Trustee
    Transazioni
    • 11 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CRANDMILL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    02 lug 2013Inizio della liquidazione
    18 ott 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Dilip K Dattani
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Praticante
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Jill Sandford
    Rivermead Court 7 Lewis Court Grove Park
    Enderby
    LE19 1SD Leicester
    Praticante
    Rivermead Court 7 Lewis Court Grove Park
    Enderby
    LE19 1SD Leicester
    Andrew Lawrence Hosking
    Quantuma Llp 10 Fitzroy Square
    W1T 5HP London
    Praticante
    Quantuma Llp 10 Fitzroy Square
    W1T 5HP London
    Simon James Bonney
    10 Fitzroy Square
    W1T 5HP London
    Praticante
    10 Fitzroy Square
    W1T 5HP London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0