PRC PUBLISHING LIMITED

PRC PUBLISHING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPRC PUBLISHING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02477813
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PRC PUBLISHING LIMITED?

    • Edizione di libri (58110) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova PRC PUBLISHING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    43 Great Ormond Street
    WC1N 3HZ London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PRC PUBLISHING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE PROMOTIONAL REPRINT COMPANY LIMITED06 mar 199006 mar 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di PRC PUBLISHING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 feb 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per PRC PUBLISHING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 mar 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    1 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2016

    7 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Gower Street London WC1E 6HD a 43 Great Ormond Street London WC1N 3HZ in data 24 nov 2016

    1 pagineAD01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 24 ago 2016

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c 17/08/2016
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 06 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 mar 2016

    Stato del capitale al 07 mar 2016

    • Capitale: GBP 110,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2015

    7 pagineAA

    Nomina di Mrs Zana Samantha Hanks come segretario in data 19 mag 2015

    2 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 06 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 apr 2015

    Stato del capitale al 02 apr 2015

    • Capitale: GBP 110,000
    SH01

    Cessazione della carica di Allan Conan Sams come segretario in data 26 mar 2015

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Allan Conan Sams come segretario in data 26 mar 2015

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2014

    7 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Old Magistrates Court 10 Southcombe Street London W14 0RA* in data 07 lug 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 06 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 apr 2014

    Stato del capitale al 17 apr 2014

    • Capitale: GBP 110,000
    SH01

    Cessazione della carica di Robin Wood come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Proffit come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2013

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PRC PUBLISHING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HANKS, Zana Samantha
    Great Ormond Street
    WC1N 3HZ London
    43
    England
    Segretario
    Great Ormond Street
    WC1N 3HZ London
    43
    England
    197807060001
    POWELL, Polly Augusta Marchant
    Great Ormond Street
    WC1N 3HZ London
    43
    England
    Amministratore
    Great Ormond Street
    WC1N 3HZ London
    43
    England
    EnglandBritish110229300002
    HAILSTONE, Timothy
    10 Talbot Road
    Highgate
    N6 4QR London
    Segretario
    10 Talbot Road
    Highgate
    N6 4QR London
    British13509200001
    NESS, Robert James
    247 Icknield Way
    SG6 4UE Letchworth
    Hertfordshire
    Segretario
    247 Icknield Way
    SG6 4UE Letchworth
    Hertfordshire
    British33929080001
    PHILLIPS, Kevin
    45 Lower Street
    GU27 2NY Haslemere
    Surrey
    Segretario
    45 Lower Street
    GU27 2NY Haslemere
    Surrey
    British44857580002
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Segretario
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    RANDS, Neil David George
    151 Abbotts Drive
    HA0 3SH North Wembley
    Middlesex
    Segretario
    151 Abbotts Drive
    HA0 3SH North Wembley
    Middlesex
    British21966770002
    SAMS, Allan Conan
    Gower Street
    WC1E 6HD London
    1
    England
    Segretario
    Gower Street
    WC1E 6HD London
    1
    England
    British107693020001
    WOOD, Robin Lee Knoyle
    55 Trinity Road
    SW19 8QY Wimbledon
    Segretario
    55 Trinity Road
    SW19 8QY Wimbledon
    British110229220004
    BARRY, Stephen Jeffrey
    3 Darnley Terrace
    W11 4RL London
    Amministratore
    3 Darnley Terrace
    W11 4RL London
    British24468010001
    BROWN, Cameron Michael
    10 Hillside
    SW19 4NH London
    Amministratore
    10 Hillside
    SW19 4NH London
    United KingdomBritish1654670001
    BUTTERFIELD, Nigel Robert Adamson
    Bullrush Farm Hillgrove
    Lurgashall
    GU28 9EP Petworth
    West Sussex
    Amministratore
    Bullrush Farm Hillgrove
    Lurgashall
    GU28 9EP Petworth
    West Sussex
    United KingdomBritish36186210001
    COLLINS, Samuel Alexander Mark
    71 Cadogan Square
    SW1 London
    Amministratore
    71 Cadogan Square
    SW1 London
    British63626140001
    HAILSTONE, Timothy
    Flat 6 28 Colville Road
    W11 2BS London
    Amministratore
    Flat 6 28 Colville Road
    W11 2BS London
    British13509200002
    JAITLY, Suneel
    27 Ferndown Gardens
    KT11 2BH Cobham
    Surrey
    Amministratore
    27 Ferndown Gardens
    KT11 2BH Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish44857620002
    LASSMAN, Peter
    Arkley Manor Rowley Lane
    Arkley
    EN5 3HS Barnet
    Hertfordshire
    Amministratore
    Arkley Manor Rowley Lane
    Arkley
    EN5 3HS Barnet
    Hertfordshire
    EnglandBritish3374500001
    LEAVER, Marcus Edward
    39 Faroe Road
    W14 0EL London
    Amministratore
    39 Faroe Road
    W14 0EL London
    British76685980003
    LENTON, Paul Richard
    27 Great Bushey Drive
    Totteridge
    N20 8QN London
    Amministratore
    27 Great Bushey Drive
    Totteridge
    N20 8QN London
    EnglandBritish82173510001
    MESSHAM, Joanne
    9 Ebner Street
    Wandsworth
    SW18 1BT London
    Amministratore
    9 Ebner Street
    Wandsworth
    SW18 1BT London
    British41015430002
    NEEDLEMAN, John Elliot
    Kerry 20 Christchurch Crescent
    WD7 8AH Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    Kerry 20 Christchurch Crescent
    WD7 8AH Radlett
    Hertfordshire
    British20117690001
    NESS, Robert James
    247 Icknield Way
    SG6 4UE Letchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    247 Icknield Way
    SG6 4UE Letchworth
    Hertfordshire
    EnglandBritish33929080001
    PHILLIPS, Kevin
    45 Lower Street
    GU27 2NY Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    45 Lower Street
    GU27 2NY Haslemere
    Surrey
    British44857580002
    PROFFIT, David Macer, Mr.
    Old Magistrates Court
    10 Southcombe Street
    W14 0RA London
    Amministratore
    Old Magistrates Court
    10 Southcombe Street
    W14 0RA London
    United KingdomBritish109190190002
    SANDERSON, Charles
    105 Castlehaven Road
    Camden
    NW1 8SJ London
    Amministratore
    105 Castlehaven Road
    Camden
    NW1 8SJ London
    British88028580001
    SIMPSON, Lisa Mary
    45 Lower Street
    GU27 2NY Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    45 Lower Street
    GU27 2NY Haslemere
    Surrey
    British74052460002
    STRACHAN, David Alistair
    Summerhill Cottage Summerhill Road
    DA1 2LP Dartford
    Kent
    Amministratore
    Summerhill Cottage Summerhill Road
    DA1 2LP Dartford
    Kent
    United KingdomBritish56866560001
    WOOD, Robin Lee Knoyle
    Old Magistrates Court
    10 Southcombe Street
    W14 0RA London
    Amministratore
    Old Magistrates Court
    10 Southcombe Street
    W14 0RA London
    UkBritish110229220004

    Chi sono le persone con controllo significativo di PRC PUBLISHING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mrs Polly Augusta Marchant Powell
    Great Ormond Street
    WC1N 3HZ London
    43
    England
    06 apr 2016
    Great Ormond Street
    WC1N 3HZ London
    43
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    PRC PUBLISHING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 13 mar 2007
    Consegnato il 16 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 23 nov 2005
    Consegnato il 09 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chrysalis Group PLC
    Transazioni
    • 09 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 09 apr 2001
    Consegnato il 26 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the composite guarantee and debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Chrysalis Books PLC
    Transazioni
    • 26 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 giu 2000
    Consegnato il 24 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Conance Limited
    Transazioni
    • 24 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 ott 1999
    Consegnato il 20 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Euro Sales Finance PLC
    Transazioni
    • 20 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 02 set 1998
    Consegnato il 10 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Stock trust deed and charge over assets
    Creato il 22 apr 1997
    Consegnato il 01 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    In favour of the chargee all monies due in relation to the £367,000 10% fixed rate loan stock issued by the company and secured by the charge
    Brevi particolari
    By way of a fixed charge all intellectual property rights belonging to the company. By way of a floating charge the company's undertaking and all their other property assets and undertakings both present and future including any uncalled capital together with any assets and rights mortgaged or charged under the fixed charge if and so far as such mortgage or charge is ineffective as a fixed charge.
    Persone aventi diritto
    • Limecourt Investments Limited
    Transazioni
    • 01 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 22 dic 1995
    Consegnato il 05 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a lease of even date
    Brevi particolari
    The initial rent deposit of £8,821 plus accrued net interest.
    Persone aventi diritto
    • Kestrel Properties Limited
    Transazioni
    • 05 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 05 ott 1995
    Consegnato il 07 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Co.
    Transazioni
    • 07 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit account agreement
    Creato il 28 feb 1995
    Consegnato il 03 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the lease of even date
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of the rent deposit account opened pursuant to the terms of this deed.
    Persone aventi diritto
    • Cadogan Estates Limited
    Transazioni
    • 03 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 26 lug 1994
    Consegnato il 02 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit account agreement
    Creato il 17 nov 1992
    Consegnato il 19 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 14/11/92
    Brevi particolari
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 17TH november 1992.
    Persone aventi diritto
    • Cadogan Estates Limited
    Transazioni
    • 19 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 lug 1991
    Consegnato il 19 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 26 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0