VHE HOLDINGS LIMITED

VHE HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVHE HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02478386
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VHE HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova VHE HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VHE HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VHE HOLDINGS PLC06 set 199306 set 1993
    VHE (HOLDINGS) LIMITED27 mar 199027 mar 1990
    SOVSHELFCO (NO. 57) LIMITED07 mar 199007 mar 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di VHE HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per VHE HOLDINGS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per VHE HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 mar 2015

    Stato del capitale al 09 mar 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Cessazione della carica di Stephen Stiff come amministratore in data 22 gen 2015

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Brian Ward May come amministratore in data 22 gen 2015

    2 pagineTM01

    Nomina di Mr John William Young Strachan Samuel come amministratore in data 22 gen 2015

    3 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2014

    6 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 mar 2014

    Stato del capitale al 03 mar 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2013

    6 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Approval of documents 09/08/2013
    RES13

    Nomina di Brian Ward May come amministratore

    4 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2012

    11 pagineAA

    Stato del capitale al 24 ott 2012

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2011

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    legacy

    6 pagineMG01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di VHE HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RENEW NOMINEES LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Segretario
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    41291250014
    SAMUEL, John William Young Strachan
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish3909060002
    RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    91993060004
    BARKER, Roger Winston
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    British59419910001
    GREASLEY, Antony Frederick
    Padside Hall
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    Padside Hall
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    North Yorkshire
    British69165360001
    LITTLEHALES, Richard
    Aisling Cottage
    Back Church Lane
    LS16 8DW Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Aisling Cottage
    Back Church Lane
    LS16 8DW Leeds
    West Yorkshire
    British57288230002
    PARKINSON, John
    Pinewoods Larchwood
    Scarcroft
    LS14 3BN Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Pinewoods Larchwood
    Scarcroft
    LS14 3BN Leeds
    West Yorkshire
    British10307790002
    THOMSON, Brian Malcolm
    Manor House Bawtry Road
    Hatfield Woodhouse
    Doncaster
    South Yorkshire
    Segretario
    Manor House Bawtry Road
    Hatfield Woodhouse
    Doncaster
    South Yorkshire
    British5774340002
    BARKER, Roger Winston
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    British59419910001
    BROADHEAD, Roy
    13 Crayburn Close
    HP8 4NZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    13 Crayburn Close
    HP8 4NZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British9110780001
    COOMBE, Andrew Jackson
    45 Stumperlowe Crescent Road
    S10 3PR Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    45 Stumperlowe Crescent Road
    S10 3PR Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish33999960001
    DAWES, John Brian
    Holly Lodge
    Arkleby
    CA7 2BT Wigton
    Cumbria
    Amministratore
    Holly Lodge
    Arkleby
    CA7 2BT Wigton
    Cumbria
    EnglandBritish10253750001
    FEAST, Roger
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    Amministratore
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    British66800550001
    GERRARD, Paul Daniel
    Highwood Bryants Bottom Road
    HP16 0JT Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Highwood Bryants Bottom Road
    HP16 0JT Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish41702130001
    GERRARD, Paul Daniel
    Highwood Bryants Bottom Road
    HP16 0JT Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Highwood Bryants Bottom Road
    HP16 0JT Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish41702130001
    GREASLEY, Antony Frederick
    Padside Hall
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Padside Hall
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish69165360001
    KING, Richard Anthony
    The Cross Johns Lane
    Blackley
    HX5 0TQ Elland
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Cross Johns Lane
    Blackley
    HX5 0TQ Elland
    West Yorkshire
    United KingdomBritish10844450001
    LAYCOCK, Michael
    33 Conniscliffe Road
    TS26 0BT Hartlepool
    Cleveland
    Amministratore
    33 Conniscliffe Road
    TS26 0BT Hartlepool
    Cleveland
    British520680001
    LITTLEHALES, Richard
    Aisling Cottage
    Back Church Lane
    LS16 8DW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Aisling Cottage
    Back Church Lane
    LS16 8DW Leeds
    West Yorkshire
    British57288230002
    MAY, Brian Ward
    Topcliffe
    YO7 3PB Thirsk
    Church Garth
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Topcliffe
    YO7 3PB Thirsk
    Church Garth
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish78419090001
    MCARTHUR, Alexander Nigel
    138 King Charles Road
    KT5 8QN Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    138 King Charles Road
    KT5 8QN Surbiton
    Surrey
    United KingdomBritish1571200001
    PARKINSON, John
    Larch Wood
    Scarcroft
    LS14 3BW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Larch Wood
    Scarcroft
    LS14 3BW Leeds
    West Yorkshire
    British10307790003
    PEARSON, Valerie
    Phoenix House
    Hawthorn Park
    LS14 1PQ Leeds
    Amministratore
    Phoenix House
    Hawthorn Park
    LS14 1PQ Leeds
    British82999480006
    SELLARS, Paul
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    Amministratore
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    EnglandBritish50761250001
    STIFF, Stephen
    Holgate Road
    WF8 4ND Pontefract
    60
    West Yorkshire
    Amministratore
    Holgate Road
    WF8 4ND Pontefract
    60
    West Yorkshire
    United KingdomBritish111161720001
    THOMSON, Brian Malcolm
    Amber Manor Farm
    Alice Head Road Stonedge
    S45 0DQ Ashover
    Derbyshire
    Amministratore
    Amber Manor Farm
    Alice Head Road Stonedge
    S45 0DQ Ashover
    Derbyshire
    British5774340006
    TOPPING, Geoffrey Austen
    3 Blyton Close
    HP9 2LX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    3 Blyton Close
    HP9 2LX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British21525990001
    UNDERWOOD, Philip John
    3 Derry Hill
    Menston
    LS29 6NE Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    3 Derry Hill
    Menston
    LS29 6NE Ilkley
    West Yorkshire
    British59420330008
    WALDRON, Brian Geoffrey
    Fir Tree Cottage 4 Chapel Lane
    Billingley
    S72 0HZ Barnsley
    South Yorkshire
    Amministratore
    Fir Tree Cottage 4 Chapel Lane
    Billingley
    S72 0HZ Barnsley
    South Yorkshire
    GibraltarBritish4324630001

    VHE HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 23 feb 2011
    Consegnato il 25 feb 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 25 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 05 gen 2005
    Consegnato il 20 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Creato il 19 nov 1998
    Consegnato il 21 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0