ISI DISTRIBUTION LTD

ISI DISTRIBUTION LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàISI DISTRIBUTION LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02478802
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ISI DISTRIBUTION LTD?

    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova ISI DISTRIBUTION LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Redwood 2 Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ISI DISTRIBUTION LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    IQ SYS LIMITED05 ott 200605 ott 2006
    INTERQUAD SYSTEMS LIMITED29 dic 200029 dic 2000
    INTERQUAD DISTRIBUTION LIMITED14 mag 199814 mag 1998
    EXOCOM INTERNATIONAL LIMITED03 lug 199003 lug 1990
    POWERBAND LIMITED08 mar 199008 mar 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di ISI DISTRIBUTION LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per ISI DISTRIBUTION LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 ago 2018

    9 pagineLIQ03

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 11 ago 2017

    LRESSP

    Stato del capitale al 27 giu 2017

    • Capitale: GBP 100
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account cancelled 20/06/2017
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 mar 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 lug 2016

    Stato del capitale al 19 lug 2016

    • Capitale: GBP 1,100
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2015

    17 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Appointment of dirs 12/10/2015
    RES13

    Cessazione della carica di Peter Hubbard come amministratore in data 29 giu 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Watts come amministratore in data 26 ott 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Howard Tuffnail come amministratore in data 26 ott 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Andy Gass come amministratore in data 26 ott 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 giu 2014

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 giu 2015

    Stato del capitale al 02 giu 2015

    • Capitale: GBP 1,100
    SH01

    Cessazione della carica di Paul Andrew Eccleston come amministratore in data 28 nov 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 mar 2014

    Stato del capitale al 25 mar 2014

    • Capitale: GBP 1,100
    SH01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 mar 2014 al 30 giu 2014

    3 pagineAA01

    Chi sono gli amministratori di ISI DISTRIBUTION LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OLLIS, Rachel Anne
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    178574660001
    GASS, Andrew
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    Amministratore
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    EnglandBritish49358720003
    TUFFNAIL, Howard
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    Amministratore
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United KingdomCanadian202334610001
    WATTS, David
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    Amministratore
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    EnglandBritish160214110001
    ARNETT, Edward Alan
    21 Clearwater Place
    Long Ditton
    KT6 4ET Surbiton
    Surrey
    Segretario
    21 Clearwater Place
    Long Ditton
    KT6 4ET Surbiton
    Surrey
    British84568350002
    HYAMS, Mitchell Spencer
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    British13800580002
    JOHNSON, Ian Paul
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    British136279590001
    PENNELLS, John Richard
    Enclave
    Wych Hill Way
    GU22 0AE Woking
    Surrey
    Segretario
    Enclave
    Wych Hill Way
    GU22 0AE Woking
    Surrey
    British7347950001
    TRAINER, Martin John
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    Segretario
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    British124180840001
    ARNETT, Edward Alan
    21 Clearwater Place
    Long Ditton
    KT6 4ET Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    21 Clearwater Place
    Long Ditton
    KT6 4ET Surbiton
    Surrey
    British84568350002
    CORNWALL, Douglas Charles
    Domaine De La Roche
    Le Bigard
    GY8 0HT Forest
    Guernsey
    Channel Islands
    Amministratore
    Domaine De La Roche
    Le Bigard
    GY8 0HT Forest
    Guernsey
    Channel Islands
    United KingdomBritish84669710001
    ECCLESTON, Paul Andrew
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish139879610001
    FANE, Sean Paul
    Nashgrove Lane
    Finchampstead
    RG40 4HG Wokingham
    131
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Nashgrove Lane
    Finchampstead
    RG40 4HG Wokingham
    131
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish67225450007
    HERRON, Bonnie Lea
    1959 Trotters Lane
    Stone Mountain
    30087 Georgia
    Usa
    Amministratore
    1959 Trotters Lane
    Stone Mountain
    30087 Georgia
    Usa
    American16958430002
    HUBBARD, Peter
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish167795150001
    HYAMS, Mitchell Spencer
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish13800580002
    JAMES, Philip John
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish118754760002
    JOHNSON, Ian Paul
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish136279590001
    MACPHERSON, William Robert George
    Benenden
    TN17 4LG Cranbrook
    Little Nineveh
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Benenden
    TN17 4LG Cranbrook
    Little Nineveh
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish132097710001
    MARTIN, Christian John
    Kingswood House
    Tag Lane Wargrave
    RG10 9ST Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Kingswood House
    Tag Lane Wargrave
    RG10 9ST Reading
    Berkshire
    EnglandBritish113992220001
    MCCORMICK, John Edgar
    5275 Cameron Forest Parkway
    FOREIGN Alpharetti
    Georgia
    Usa
    Amministratore
    5275 Cameron Forest Parkway
    FOREIGN Alpharetti
    Georgia
    Usa
    American16958460001
    MINNS, Gregory Leslie John
    113 Paddick Drive
    RG6 4HF Lower Earley
    Berkshire
    Amministratore
    113 Paddick Drive
    RG6 4HF Lower Earley
    Berkshire
    United KingdomBritish72170360001
    PENNELLS, John Richard
    Enclave
    Wych Hill Way
    GU22 0AE Woking
    Surrey
    Amministratore
    Enclave
    Wych Hill Way
    GU22 0AE Woking
    Surrey
    EnglandBritish7347950001
    RIGBY, James Peter
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish88633720001
    RIGBY, Peter, Sir
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish15654920006
    STRANGE, John Leland
    2714 Meadow Church Road
    FOREIGN Duluth
    Georgia
    Usa
    Amministratore
    2714 Meadow Church Road
    FOREIGN Duluth
    Georgia
    Usa
    American16958470001
    TRAINER, Martin John
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    Amministratore
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    EnglandBritish124180840001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ISI DISTRIBUTION LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Specialist Distribution Group (Sdg) Ltd
    Guildford Road
    Normandy
    GU3 2AW Guildford
    Redwood 2
    England
    06 apr 2016
    Guildford Road
    Normandy
    GU3 2AW Guildford
    Redwood 2
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione1769690
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    ISI DISTRIBUTION LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A fixed charge on book and other debts
    Creato il 04 nov 2011
    Consegnato il 10 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts and other debts and monetary claims and any rent licence fees or other payments due from any lessee, licensee or occupier of any immovable property wherever.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 21 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal assignment
    Creato il 04 nov 2011
    Consegnato il 10 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any credit balance due under the contract (the contract monies).
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 21 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 04 nov 2011
    Consegnato il 09 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all purchased debts which fail to vest effectively or absolutely in the security holder pursuant to the agreement see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transazioni
    • 09 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 21 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    All assets debenture
    Creato il 14 ott 2010
    Consegnato il 27 ott 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 27 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed & floating charge
    Creato il 15 mag 2009
    Consegnato il 27 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 27 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 ott 2007
    Consegnato il 03 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland, as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 03 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 giu 2004
    Consegnato il 05 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 15 nov 2000
    Consegnato il 23 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 23 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 nov 2000
    Consegnato il 07 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 mag 1999
    Consegnato il 13 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a guarantee agreement of even date and the deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Isc (Guernsey) Limited
    Transazioni
    • 13 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 feb 1999
    Consegnato il 16 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 3 february 1999
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Isc (Guernsey) Limited
    Transazioni
    • 16 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 28 gen 1999
    Consegnato il 02 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 dic 1998
    Consegnato il 23 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book and other debts present and future and the benefit of all contracts and policies of insurance and by way of floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company present and future.
    Persone aventi diritto
    • Euro Sales Finance PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ISI DISTRIBUTION LTD ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    11 ago 2017Inizio della liquidazione
    16 gen 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0