GOALTIME LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GOALTIME LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02478862 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GOALTIME LIMITED?
- Farmacia al dettaglio in negozi specializzati (47730) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova GOALTIME LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o WELL Merchants Warehouse Castle Street M3 4LZ Manchester England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di GOALTIME LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 11 gen 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GOALTIME LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per GOALTIME LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 Angel Square Manchester M60 0AG a C/O Well Merchants Warehouse Castle Street Manchester M3 4LZ in data 14 set 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 lug 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato C/O Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a C/O Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 11 gen 2015 al 30 giu 2015 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Caroline Jane Sellers come segretario in data 30 set 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 lug 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony John Smith il 27 feb 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr John Branson Nuttall il 27 feb 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 lug 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Sandbrook Park Sandbrook Way Rochdale Lancashire OL11 1SA United Kingdom* in data 04 dic 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 lug 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 lug 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2011 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2010 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony John Smith il 31 lug 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr John Branson Nuttall il 31 lug 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mrs Caroline Jane Sellers il 31 lug 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 lug 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GOALTIME LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTTALL, John Branson | Amministratore | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | England | British | 44967060003 | |||||
| SMITH, Anthony John | Amministratore | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | England | British | 137558680002 | |||||
| GUSH, Christine Janet | Segretario | 7 Denbigh Crescent Morriston SA6 6TG Swansea West Glamorgan | British | 59479880001 | ||||||
| LEWIS, Haydon Vivian | Segretario | 35 Heol Tawe Abercrave SA9 1XP Swansea West Glamorgan | British | 24348140001 | ||||||
| LEWIS, Janice | Segretario | Tudor Oaks Rhyd Y Gwern Close Badgers Wood CF83 3NN Rudry Caerphilly Gwent | British | 78801440001 | ||||||
| SELLERS, Caroline Jane | Segretario | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | British | 45801060004 | ||||||
| BATTY, Peter David | Amministratore | Church Hill Ingham LN1 2YE Lincoln 2 Lincolnshire United Kingdom | England | British | 140380300001 | |||||
| BRAITHWAITE, Neil | Amministratore | 74 Stockton Lane YO31 1BN York | England | British | 87486660004 | |||||
| BROCKLEHURST, Jonathan David | Amministratore | Larch House 29 Keele Road ST5 2JT Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | 49108820004 | ||||||
| FARQUHAR, Gordon Hillocks | Amministratore | 3 Apsley Grove Dorridge B93 8QP Solihull | United Kingdom | British | 125645380001 | |||||
| GUSH, Andrew Charles | Amministratore | 12 West Drive CF36 3LS Porthcawl Mid Glamorgan | British | 13022720003 | ||||||
| GUSH, Andrew Charles | Amministratore | 7 Denbigh Crescent Morriston SA6 6TG Swansea West Glamorgan | British | 13022720001 | ||||||
| GUSH, Christine Janet | Amministratore | 7 Denbigh Crescent Morriston SA6 6TG Swansea West Glamorgan | British | 59479880001 | ||||||
| HEWITT, Paul William | Amministratore | Hough Hall Newcastle Road Hough CW2 5JG Crewe Cheshire | England | British | 163759450001 | |||||
| LEWIS, Haydn Gethin | Amministratore | Tudor Oaks Badgers Wood Rudry CF83 3NN Caerphilly | British | 62666160001 | ||||||
| LEWIS, Janet Lesley | Amministratore | 31 Ashwood Drive Gellinudd Pontardawe | British | 13022740001 | ||||||
| PERRIN, Nicholas John | Amministratore | Westfield 5 Hough Lane SK9 2LG Wilmslow Cheshire | British | 80173660001 |
GOALTIME LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Creato il 04 lug 1997 Consegnato il 14 lug 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The freehold property known as land situate at bryn bedwas caerphilly title number wa 826977. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 27 apr 1990 Consegnato il 14 mag 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 26 church street, bedwas, gwent; and/or the proceeds of sale thereof. And the benefit and goodwill of the business.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 27 apr 1990 Consegnato il 14 mag 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Health centre pharmacy, william street, trethomas, gwent, and/or the proceeds of sale thereof. And the benefit and goodwill of the business.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 27 apr 1990 Consegnato il 11 mag 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0