AAA (UK) LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAAA (UK) LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02484222
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AAA (UK) LTD?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova AAA (UK) LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di AAA (UK) LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per AAA (UK) LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    6 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2016

    7 pagineAA

    legacy

    207 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    2 pagineAGREEMENT2

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 apr 2016

    Stato del capitale al 01 apr 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 mar 2015

    Stato del capitale al 13 mar 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Joanne Sarah Finch come amministratore in data 26 set 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 mar 2014

    Stato del capitale al 14 mar 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    6 pagineAA

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Nomina di Mr David Nigel Evans come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Martin Purkess come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Diane Mcintyre come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Schäfer come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di AAA (UK) LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    75473330004
    EVANS, David Nigel
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish134975040001
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish173703620001
    AHOOIE, Seyed Mahmood
    Three Gables
    Toft Road
    WA16 9EB Knutsford
    Cheshire
    Segretario
    Three Gables
    Toft Road
    WA16 9EB Knutsford
    Cheshire
    British55445500001
    FAZELYNIA, Farid
    47 Carlton Road
    Hale
    WA15 8RH Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    47 Carlton Road
    Hale
    WA15 8RH Altrincham
    Cheshire
    British75559080001
    JEFFERSON, Karen
    8 Bailey Close
    SN9 5HU Pewsey
    Wiltshire
    Segretario
    8 Bailey Close
    SN9 5HU Pewsey
    Wiltshire
    British79393480001
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    Segretario
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    British25660590003
    AHOOIE, Seyed Mahmood
    Three Gables
    Toft Road
    WA16 9EB Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Three Gables
    Toft Road
    WA16 9EB Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish55445500001
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British123612980001
    BREWER, Stephen
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    British79186090002
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Amministratore
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    British83126790001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British99525280001
    CREEDY, Peter Kevin
    Pine Ridge Hollow
    Longdown Road, Lower Bourne
    GU10 3JT Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Pine Ridge Hollow
    Longdown Road, Lower Bourne
    GU10 3JT Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish61327890003
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British127017870001
    FARENJANI, Ebrahim
    Greystoke Cavendish Road
    Bowdon
    WA14 2NX Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Greystoke Cavendish Road
    Bowdon
    WA14 2NX Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish25840800002
    FAZELYNIA, Annette
    47 Carlton Road
    Hale
    WA15 8RH Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    47 Carlton Road
    Hale
    WA15 8RH Altrincham
    Cheshire
    British44511110001
    FAZELYNIA, Farid
    47 Carlton Road
    Hale
    WA15 8RH Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    47 Carlton Road
    Hale
    WA15 8RH Altrincham
    Cheshire
    British75559080001
    FAZELYNIA, Vahid
    20 Longmeade Gardens
    SK9 1DA Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    20 Longmeade Gardens
    SK9 1DA Wilmslow
    Cheshire
    British77444080001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish158146620001
    HALFORD, Andrew Nigel
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    British33951180005
    HANFORD, Raymond Clifford
    Romney Cottage Park Horsley
    East Horsley
    KT24 5RZ Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Romney Cottage Park Horsley
    East Horsley
    KT24 5RZ Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritish45868080001
    JONES, David Leslie
    Three Oak Barn
    RH14 0PY Plaistow
    West Sussex
    Amministratore
    Three Oak Barn
    RH14 0PY Plaistow
    West Sussex
    British83517310001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Amministratore
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritish24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    NOWAK, Thomas, Dr
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomGerman174443800001
    PURKESS, Martin John
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish139360020001
    READ, Nicholas Jonathan
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish87149560001
    SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158146600001
    SMITH, Andrew Paul
    Little Park Hill
    White Hill Lane, Bletchingley
    RH1 4QY Redhill
    Surrey
    Amministratore
    Little Park Hill
    White Hill Lane, Bletchingley
    RH1 4QY Redhill
    Surrey
    British33025470005
    TOURNON, Emanuele
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomItalian103542080002
    TOWNSEND, John Raymond
    Knowle House
    Chapel Corner Hamstead Marshall
    RG20 0HP Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Knowle House
    Chapel Corner Hamstead Marshall
    RG20 0HP Newbury
    Berkshire
    British95223480001
    WEBB, Denys William
    Oakfield Stud
    Whitemoor Lane, Upper Basildon
    RG8 8SF Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Oakfield Stud
    Whitemoor Lane, Upper Basildon
    RG8 8SF Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish76074580001

    Chi sono le persone con controllo significativo di AAA (UK) LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3056112
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    AAA (UK) LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 12 mar 1999
    Consegnato il 13 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 apr 1991
    Consegnato il 30 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0