PATHTRACE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPATHTRACE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02485210
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PATHTRACE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova PATHTRACE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hadley House
    Bayshill Road
    GL50 3AW Cheltenham
    Gloucestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PATHTRACE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PATHTRACE PLC17 nov 199817 nov 1998
    TRULINE TECHNOLOGY LIMITED20 lug 199020 lug 1990
    SIDEMART LIMITED26 mar 199026 mar 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di PATHTRACE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per PATHTRACE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 24 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 gen 2016

    Stato del capitale al 25 gen 2016

    • Capitale: GBP .02
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 feb 2015

    Stato del capitale al 10 feb 2015

    • Capitale: GBP .02
    SH01

    Nomina di Mr David Anthony Mills come amministratore in data 07 ago 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Paul Smith come amministratore in data 07 ago 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Paolo Guglielmini come amministratore in data 07 ago 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2013

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 mar 2014

    Stato del capitale al 11 mar 2014

    • Capitale: GBP .02
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    6 pagineAA

    Ritiro della richiesta di cancellazione della società

    2 pagineDS02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 10 set 2013

    • Capitale: GBP 0.02
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account & capital redemption reserve be reduced 09/09/2013
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 24 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 apr 2012 al 31 dic 2011

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 24 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Mrs Julie Randall come segretario

    1 pagineAP03

    Nomina di Mrs Julie Randall come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di PATHTRACE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RANDALL, Julie
    Bayshill Road
    GL50 3AW Cheltenham
    Hadley House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Bayshill Road
    GL50 3AW Cheltenham
    Hadley House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    164091250001
    GUGLIELMINI, Paolo
    Bayshill Road
    GL50 3AW Cheltenham
    Hadley House
    Gloucestershire
    Amministratore
    Bayshill Road
    GL50 3AW Cheltenham
    Hadley House
    Gloucestershire
    SwitzerlandItalian191499610001
    MILLS, David Anthony
    Bayshill Road
    GL50 3AW Cheltenham
    Hadley House
    Gloucestershire
    Amministratore
    Bayshill Road
    GL50 3AW Cheltenham
    Hadley House
    Gloucestershire
    EnglandEnglish86006880001
    RANDALL, Julie Langhorne
    Bayshill Road
    GL50 3AW Cheltenham
    Hadley House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Bayshill Road
    GL50 3AW Cheltenham
    Hadley House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish163918890001
    LEE, Jonathan Neville Hastings
    West End House
    The Row, Elham
    CT4 6UP Canterbury
    Kent
    Segretario
    West End House
    The Row, Elham
    CT4 6UP Canterbury
    Kent
    British77781880004
    ROSE, Joanna
    45 Darby Green Lane
    Blackwater
    GU17 0DN Camberley
    Surrey
    Segretario
    45 Darby Green Lane
    Blackwater
    GU17 0DN Camberley
    Surrey
    British37684500001
    SYKES, Jonathan Michael
    15 Chinnock Close
    GU13 9SN Fleet
    Hampshire
    Segretario
    15 Chinnock Close
    GU13 9SN Fleet
    Hampshire
    British8052230001
    WALKER, Vernon Sidney
    7 Maryland
    Finchampstead
    RG40 4PB Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    7 Maryland
    Finchampstead
    RG40 4PB Wokingham
    Berkshire
    British189785280001
    GROVES, Jackie
    7 Newark Road
    GU20 6NE Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    7 Newark Road
    GU20 6NE Windlesham
    Surrey
    British42060880001
    LEE, Jonathan Neville Hastings
    West End House
    The Row, Elham
    CT4 6UP Canterbury
    Kent
    Amministratore
    West End House
    The Row, Elham
    CT4 6UP Canterbury
    Kent
    EnglandBritish77781880004
    NEADS, Martin Andrew
    Claremont House 18 Pasture Road
    SG6 3LP Letchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Claremont House 18 Pasture Road
    SG6 3LP Letchworth
    Hertfordshire
    British57376890001
    NUNN, Martin Robert
    63 Upper Queens Road
    TN24 8HL Ashford
    Kent
    Amministratore
    63 Upper Queens Road
    TN24 8HL Ashford
    Kent
    EnglandBritish11370530001
    OVERSTALL, John Kevin
    Longacre Chestnut Avenue
    KT13 0LA Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Longacre Chestnut Avenue
    KT13 0LA Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish9473030001
    PRYCE, Bryan Thomas
    Spens Cottage
    Lambden Road
    TN27 0RB Pluckley
    Kent
    Amministratore
    Spens Cottage
    Lambden Road
    TN27 0RB Pluckley
    Kent
    EnglandBritish38020340002
    ROSE, Joanna
    45 Darby Green Lane
    Blackwater
    GU17 0DN Camberley
    Surrey
    Amministratore
    45 Darby Green Lane
    Blackwater
    GU17 0DN Camberley
    Surrey
    British37684500001
    SIVITTER, Stephen John
    465 Oakpark Drive
    Tecumseh
    Ontario N8n 4p1
    Canada
    Amministratore
    465 Oakpark Drive
    Tecumseh
    Ontario N8n 4p1
    Canada
    British102618770001
    SMITH, Richard Paul
    Bayshill Road
    GL50 3AW Cheltenham
    Hadley House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Bayshill Road
    GL50 3AW Cheltenham
    Hadley House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish155010530001
    STEATHAM, Brian Charles
    Lavender Cottage
    Heath Ride
    RG11 3QJ Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Lavender Cottage
    Heath Ride
    RG11 3QJ Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish8052270001
    SYKES, Jonathan Michael
    15 Chinnock Close
    GU13 9SN Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    15 Chinnock Close
    GU13 9SN Fleet
    Hampshire
    British8052230001
    WALKER, Vernon Sidney
    7 Maryland
    Finchampstead
    RG40 4PB Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    7 Maryland
    Finchampstead
    RG40 4PB Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish189785280001

    PATHTRACE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 06 dic 2006
    Consegnato il 15 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 15 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 gen 2006
    Consegnato il 04 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the group to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 45 boulten road reading berkshire and l/h propery k/a the sub lease of unit 22 langthwaite grange industrial estate south kirkby west yorkshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 dic 2001
    Consegnato il 04 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage land on the south east side of lidgate crescent south kirby west yorkshire t/n WYK464974. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 09 mar 1992
    Consegnato il 13 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 20 dic 1991
    Consegnato il 04 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H factory 45 boulton rd reading berkshire t/n bk 38477.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 04 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 20 dic 1991
    Consegnato il 04 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 04 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 24 lug 1991
    Consegnato il 02 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 29 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0