LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02491595 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED?
- Agenzie pubblicitarie (73110) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o MSQ PARTNERS LIMITED 90 Tottenham Court Road W1T 4TJ London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| DVL SMITH (MSQH) LIMITED | 08 mar 2006 | 08 mar 2006 |
| CITIGATE DVL SMITH LIMITED | 09 ago 2000 | 09 ago 2000 |
| D V L SMITH GROUP LIMITED | 31 mar 1998 | 31 mar 1998 |
| D.V.L. SMITH LIMITED | 14 giu 1993 | 14 giu 1993 |
| D.V.L. SMITH & ASSOCIATES LIMITED | 10 apr 1990 | 10 apr 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 28 feb 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 10 Rathbone Place London W1T 1HP England a C/O Browne Jacobson Llp 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA | 1 pagine | AD02 | ||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata C/O Msq Partners Limited 90 Tottenham Court Road London W1T 4TJ | 1 pagine | AD04 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 28 feb 2015 | 17 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 apr 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 10 Rathbone Place London W1T 1HP | 1 pagine | AD03 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 10 Rathbone Place London W1T 1HP | 1 pagine | AD02 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 28 feb 2014 | 18 pagine | AA | ||||||||||||||
Memorandum e Statuto | 10 pagine | MA | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 024915950006 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Msq Partners Ltd 6 York Street London W1U 6PL a C/O Msq Partners Limited 90 Tottenham Court Road London W1T 4TJ in data 13 ago 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 024915950008, creata il 16 lug 2014 | 59 pagine | MR01 | ||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 024915950007, creata il 16 lug 2014 | 55 pagine | MR01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 apr 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 28 feb 2013 | 17 pagine | AA | ||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 024915950006 | 17 pagine | MR01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Daniel Yardley come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Dean Wright come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAH, Ashish | Segretario | c/o Msq Partners Limited Tottenham Court Road W1T 4TJ London 90 England | 164776630001 | |||||||
| REID, Peter David | Amministratore | c/o Msq Partners Limited Tottenham Court Road W1T 4TJ London 90 England | England | British | 147274580002 | |||||
| YARDLEY, Daniel John | Amministratore | c/o Msq Partners Limited Tottenham Court Road W1T 4TJ London 90 England | England | British | 180507300001 | |||||
| BRIGDEN, Colin John | Segretario | c/o Media Square Plc York Street W1U 6PL London 6 United Kingdom | 147341370001 | |||||||
| BUTTERWORTH, Michael Guy | Segretario | The Woodman, Howe Street, Great Waltham CM3 1BA Chelmsford | British | 76600500002 | ||||||
| CLARKE, Martin John | Segretario | 105 Congleton Road SK11 7XD Macclesfield Cheshire | British | 53461320002 | ||||||
| LEES, Jennifer Kathryn | Segretario | 15-17 Huntsworth Mews NW1 6DD London | British | 24587010002 | ||||||
| NICHOLS, Richard Stephen | Segretario | 3a Devonshire Road AL5 4TJ Harpenden Hertfordshire | British | 54128690001 | ||||||
| SMITH, Josephine Mary | Segretario | Waverley 8 Pump Lane CM16 6PR Epping Green Essex | British | 96496420001 | ||||||
| WINFIELD, Bruce Malcolm | Segretario | 22 Hillhouse Close RH10 4YY Turners Hill West Sussex | British | 147948820001 | ||||||
| BROWN, Joseph | Amministratore | 16 Drayton Gardens Winchmore Hill N21 2NS London | England | British | 77616350001 | |||||
| BURNS, Graeme Ian, Mr. | Amministratore | 29 Moody Street CW12 4AN Congleton Cheshire | United Kingdom | British | 75720570001 | |||||
| BUTTERWORTH, Michael Guy | Amministratore | The Woodman, Howe Street, Great Waltham CM3 1BA Chelmsford | England | British | 76600500002 | |||||
| CONNAUGHTON, John | Amministratore | 10 Hawarden Road E17 6NS London | British | 56652120002 | ||||||
| CONNAUGHTON, John | Amministratore | 111 Lindsey Street CM16 6RE Epping Essex | British | 56652120001 | ||||||
| DEXTER, Andrew John | Amministratore | 1 Novara Row Calabria Road Highbury N5 1JL London | United Kingdom | British | 33183620006 | |||||
| FLETCHER, Jonathan | Amministratore | 25 Ronver Road Lee SE12 0NR London | British | 77616450001 | ||||||
| GROGAN, Aunia Judith | Amministratore | 44b Cecilia Road Hackney E8 2ER London | British | 56652070001 | ||||||
| HURST, Katharine Louise Florence | Amministratore | 135 Widdenham Road N7 9SF London | British | 93216430001 | ||||||
| MULHOLLAND, Gavin | Amministratore | 9 Lynton Avenue North Finchley N12 9JH London | England | British | 93216470001 | |||||
| NICHOLS, Richard Stephen | Amministratore | 15a Rothamsted Avenue AL5 2DD Harpenden Hertfordshire | England | British | 54128690003 | |||||
| SELMAN, Roger Malcolm | Amministratore | 5 Vineries Bank Milespit Hill Mill Hill NW7 2RP London | United Kingdom | British | 10691510002 | |||||
| SMITH, David Van Lloyd, Dr | Amministratore | Flat 169 Free Trade Wharf 340 The Highway E1W 3EU London | England | British | 26665360003 | |||||
| SMITH, Josephine Mary | Amministratore | Waverley 8 Pump Lane CM16 6PR Epping Green Essex | British | 96496420001 | ||||||
| SOADY, Kevin James | Amministratore | 29 Richmond Avenue N1 0NB London | British | 61604720001 | ||||||
| STEEDS, Kevin Barrie | Amministratore | 20 Fortismere Avenue Muswell Hill N10 3BL London | British | 14119150003 | ||||||
| WHITE, Jonathan Christian | Amministratore | 80 Victory Road Wanstead E11 1UL London | British | 93041570001 | ||||||
| WINFIELD, Bruce Malcolm | Amministratore | 22 Hillhouse Close RH10 4YY Turners Hill West Sussex | United Kingdom | British | 147948820001 | |||||
| WORTHINGTON, David Howard | Amministratore | c/o Media Square Plc York Street W1U 6PL London 6 United Kingdom | England | British | 23127210001 | |||||
| WRIGHT, David Ernest | Amministratore | The Priory 23 Matham Road KT8 0SX East Molesey Surrey | British | 14119160001 | ||||||
| WRIGHT, Dean Anthony | Amministratore | c/o Msq Partners Ltd York Street W1U 6PL London 6 England | England | British | 159138180001 |
LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 16 lug 2014 Consegnato il 21 lug 2014 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 16 lug 2014 Consegnato il 18 lug 2014 | In corso | ||
Breve descrizione Description of all registered intellectual property rights subject to this security can be found in schedule 5 of the debenture. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 27 set 2013 Consegnato il 04 ott 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental debenture | Creato il 06 feb 2012 Consegnato il 23 feb 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 08 dic 2011 Consegnato il 29 dic 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Any sum standing to the credit of an account whether in sterling or any other currency or currency unit and the debt from time to time owing by the bank represented by that sum see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 08 dic 2011 Consegnato il 20 dic 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Accession deed | Creato il 04 nov 2005 Consegnato il 17 nov 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture deed | Creato il 13 mar 1998 Consegnato il 17 mar 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0