LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED

LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02491595
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Agenzie pubblicitarie (73110) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o MSQ PARTNERS LIMITED
    90 Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DVL SMITH (MSQH) LIMITED08 mar 200608 mar 2006
    CITIGATE DVL SMITH LIMITED09 ago 200009 ago 2000
    D V L SMITH GROUP LIMITED31 mar 199831 mar 1998
    D.V.L. SMITH LIMITED14 giu 199314 giu 1993
    D.V.L. SMITH & ASSOCIATES LIMITED10 apr 199010 apr 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 10 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 apr 2016

    Stato del capitale al 14 apr 2016

    • Capitale: GBP 380,000
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 10 Rathbone Place London W1T 1HP England a C/O Browne Jacobson Llp 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA

    1 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata C/O Msq Partners Limited 90 Tottenham Court Road London W1T 4TJ

    1 pagineAD04

    Bilancio redatto al 28 feb 2015

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 apr 2015

    Stato del capitale al 10 apr 2015

    • Capitale: GBP 380,000
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 10 Rathbone Place London W1T 1HP

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 10 Rathbone Place London W1T 1HP

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 28 feb 2014

    18 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    10 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Various agreements as listed 16/07/2014
    RES13

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 024915950006 in pieno

    4 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Msq Partners Ltd 6 York Street London W1U 6PL a C/O Msq Partners Limited 90 Tottenham Court Road London W1T 4TJ in data 13 ago 2014

    1 pagineAD01

    Iscrizione dell'ipoteca 024915950008, creata il 16 lug 2014

    59 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 024915950007, creata il 16 lug 2014

    55 pagineMR01

    Bilancio annuale redatto al 10 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 apr 2014

    Stato del capitale al 10 apr 2014

    • Capitale: GBP 380,000
    SH01

    Bilancio redatto al 28 feb 2013

    17 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 024915950006

    17 pagineMR01

    Nomina di Mr Daniel Yardley come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Dean Wright come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHAH, Ashish
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Segretario
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    164776630001
    REID, Peter David
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Amministratore
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritish147274580002
    YARDLEY, Daniel John
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Amministratore
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritish180507300001
    BRIGDEN, Colin John
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Segretario
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    147341370001
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    Segretario
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    British76600500002
    CLARKE, Martin John
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    British53461320002
    LEES, Jennifer Kathryn
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    Segretario
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    British24587010002
    NICHOLS, Richard Stephen
    3a Devonshire Road
    AL5 4TJ Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    3a Devonshire Road
    AL5 4TJ Harpenden
    Hertfordshire
    British54128690001
    SMITH, Josephine Mary
    Waverley
    8 Pump Lane
    CM16 6PR Epping Green
    Essex
    Segretario
    Waverley
    8 Pump Lane
    CM16 6PR Epping Green
    Essex
    British96496420001
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Segretario
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    British147948820001
    BROWN, Joseph
    16 Drayton Gardens
    Winchmore Hill
    N21 2NS London
    Amministratore
    16 Drayton Gardens
    Winchmore Hill
    N21 2NS London
    EnglandBritish77616350001
    BURNS, Graeme Ian, Mr.
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    United KingdomBritish75720570001
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    Amministratore
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    EnglandBritish76600500002
    CONNAUGHTON, John
    10 Hawarden Road
    E17 6NS London
    Amministratore
    10 Hawarden Road
    E17 6NS London
    British56652120002
    CONNAUGHTON, John
    111 Lindsey Street
    CM16 6RE Epping
    Essex
    Amministratore
    111 Lindsey Street
    CM16 6RE Epping
    Essex
    British56652120001
    DEXTER, Andrew John
    1 Novara Row
    Calabria Road Highbury
    N5 1JL London
    Amministratore
    1 Novara Row
    Calabria Road Highbury
    N5 1JL London
    United KingdomBritish33183620006
    FLETCHER, Jonathan
    25 Ronver Road
    Lee
    SE12 0NR London
    Amministratore
    25 Ronver Road
    Lee
    SE12 0NR London
    British77616450001
    GROGAN, Aunia Judith
    44b Cecilia Road
    Hackney
    E8 2ER London
    Amministratore
    44b Cecilia Road
    Hackney
    E8 2ER London
    British56652070001
    HURST, Katharine Louise Florence
    135 Widdenham Road
    N7 9SF London
    Amministratore
    135 Widdenham Road
    N7 9SF London
    British93216430001
    MULHOLLAND, Gavin
    9 Lynton Avenue
    North Finchley
    N12 9JH London
    Amministratore
    9 Lynton Avenue
    North Finchley
    N12 9JH London
    EnglandBritish93216470001
    NICHOLS, Richard Stephen
    15a Rothamsted Avenue
    AL5 2DD Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    15a Rothamsted Avenue
    AL5 2DD Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish54128690003
    SELMAN, Roger Malcolm
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    Amministratore
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    United KingdomBritish10691510002
    SMITH, David Van Lloyd, Dr
    Flat 169 Free Trade Wharf
    340 The Highway
    E1W 3EU London
    Amministratore
    Flat 169 Free Trade Wharf
    340 The Highway
    E1W 3EU London
    EnglandBritish26665360003
    SMITH, Josephine Mary
    Waverley
    8 Pump Lane
    CM16 6PR Epping Green
    Essex
    Amministratore
    Waverley
    8 Pump Lane
    CM16 6PR Epping Green
    Essex
    British96496420001
    SOADY, Kevin James
    29 Richmond Avenue
    N1 0NB London
    Amministratore
    29 Richmond Avenue
    N1 0NB London
    British61604720001
    STEEDS, Kevin Barrie
    20 Fortismere Avenue
    Muswell Hill
    N10 3BL London
    Amministratore
    20 Fortismere Avenue
    Muswell Hill
    N10 3BL London
    British14119150003
    WHITE, Jonathan Christian
    80 Victory Road
    Wanstead
    E11 1UL London
    Amministratore
    80 Victory Road
    Wanstead
    E11 1UL London
    British93041570001
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Amministratore
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    United KingdomBritish147948820001
    WORTHINGTON, David Howard
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    EnglandBritish23127210001
    WRIGHT, David Ernest
    The Priory
    23 Matham Road
    KT8 0SX East Molesey
    Surrey
    Amministratore
    The Priory
    23 Matham Road
    KT8 0SX East Molesey
    Surrey
    British14119160001
    WRIGHT, Dean Anthony
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    England
    Amministratore
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    England
    EnglandBritish159138180001

    LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 16 lug 2014
    Consegnato il 21 lug 2014
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Nvm Private Equity Limited
    Transazioni
    • 21 lug 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 16 lug 2014
    Consegnato il 18 lug 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Description of all registered intellectual property rights subject to this security can be found in schedule 5 of the debenture.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Agent for National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 lug 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 set 2013
    Consegnato il 04 ott 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 04 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental debenture
    Creato il 06 feb 2012
    Consegnato il 23 feb 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 23 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 08 dic 2011
    Consegnato il 29 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of an account whether in sterling or any other currency or currency unit and the debt from time to time owing by the bank represented by that sum see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 08 dic 2011
    Consegnato il 20 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Accession deed
    Creato il 04 nov 2005
    Consegnato il 17 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture deed
    Creato il 13 mar 1998
    Consegnato il 17 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0