LANCASTER TRUCK AND VAN SOUTH WEST LIMITED

LANCASTER TRUCK AND VAN SOUTH WEST LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLANCASTER TRUCK AND VAN SOUTH WEST LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02493511
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LANCASTER TRUCK AND VAN SOUTH WEST LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova LANCASTER TRUCK AND VAN SOUTH WEST LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    770 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LANCASTER TRUCK AND VAN SOUTH WEST LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JOHN HEWITT GROUP LIMITED15 gen 199115 gen 1991
    BONDCO NO 310 LIMITED19 apr 199019 apr 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di LANCASTER TRUCK AND VAN SOUTH WEST LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per LANCASTER TRUCK AND VAN SOUTH WEST LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    A9BW6WU0

    Stato del capitale al 30 lug 2020

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19
    A99X0J74

    legacy

    1 pagineSH20
    A99X0J7C

    legacy

    1 pagineCAP-SS
    A99X0J6O

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X9681S0Z

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1
    L8AYCTCJ

    legacy

    49 paginePARENT_ACC
    L8DDWXNM

    legacy

    3 pagineAGREEMENT1
    L8DDWXNU

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mag 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01
    X86ET86I

    Cessazione della carica di Matthew Bishop come amministratore in data 01 gen 2019

    1 pagineTM01
    X7WRQ22Y

    Nomina di Mr David John Muir come amministratore in data 01 gen 2019

    2 pagineAP01
    X7WP0PWP

    legacy

    44 paginePARENT_ACC
    A7FF21CG

    legacy

    3 pagineAGREEMENT1
    A7FF20KG

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1
    L7FEVKTN

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mag 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01
    X771OWTK

    legacy

    3 pagineAGREEMENT1
    A6G00LWW

    legacy

    49 paginePARENT_ACC
    A6G0H8KY

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1
    A6G0H8LA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    X673OIYG

    legacy

    51 paginePARENT_ACC
    A5GH9HGZ

    legacy

    3 pagineAGREEMENT1
    A5GH9HGR

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1
    A5GH9HGJ

    Chi sono gli amministratori di LANCASTER TRUCK AND VAN SOUTH WEST LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FINCH, Mark
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    175736510001
    FINCH, Mark Charles
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary175612870001
    MUIR, David John
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director254017640001
    HEWITT, Dianne Joan
    50 Coniston Road
    Ogwell
    TQ12 6YJ Newton Abbot
    Devon
    Segretario
    50 Coniston Road
    Ogwell
    TQ12 6YJ Newton Abbot
    Devon
    British26721660002
    MACNAMARA, Richard James
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    149314910001
    WATSON, Deirdre Mary Alison
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Segretario
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Uk74385360001
    MATHESON & CO LIMITED
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    Segretario
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    1947590001
    BEATTIE, Craig Alan
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director177627900001
    BEYNON, Peter
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritishGroup Finance Director38504390006
    BISHOP, Matthew
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director206755450002
    HERBERT, Mark Philip
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director123285980005
    HEWITT, Dianne Joan
    50 Coniston Road
    Ogwell
    TQ12 6YJ Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    50 Coniston Road
    Ogwell
    TQ12 6YJ Newton Abbot
    Devon
    BritishFinancial Controller26721660002
    HEWITT, John
    50 Coniston Road
    Ogwell
    TQ12 6YJ Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    50 Coniston Road
    Ogwell
    TQ12 6YJ Newton Abbot
    Devon
    BritishManaging Director26721670001
    HOUSTON, Samuel George
    Flat 59 Medland House
    11 Branch Road
    E14 7JT London
    Amministratore
    Flat 59 Medland House
    11 Branch Road
    E14 7JT London
    BritishFinance Director75730290003
    JONES, Alun Morton
    Fen Walk
    IP12 4BG Woodbridge
    Fen House
    Suffolk
    United Kingdom
    Amministratore
    Fen Walk
    IP12 4BG Woodbridge
    Fen House
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector12785600004
    MACNAMARA, Richard James
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary149294820002
    POTTS, Derek
    55 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SJ Colchester
    Essex
    Amministratore
    55 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SJ Colchester
    Essex
    United KingdomBritishFinance Director52485510001
    RITCHIE, John Muir
    High House
    Snipe Farm Road
    IP13 6SL Clopton
    Suffolk
    Amministratore
    High House
    Snipe Farm Road
    IP13 6SL Clopton
    Suffolk
    BritishDirector22325820001
    SHELFORD, Michael
    The Old School House
    Woodleigh
    TQ7 Kingsbridge
    Devon
    Amministratore
    The Old School House
    Woodleigh
    TQ7 Kingsbridge
    Devon
    BritishDirector49260550001
    SMITH, Michael Charles
    The Cottage The Pightle
    North Heath Chieveley
    RG16 8UD Newbury
    Berks
    Amministratore
    The Cottage The Pightle
    North Heath Chieveley
    RG16 8UD Newbury
    Berks
    BritishChief Executive25636860001
    WATSON, Deirdre Mary Alison
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Amministratore
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    EnglandUkCompany Secretary74385360001
    WILLIAMS, Steven Wyn
    199 Finchampstead Road
    RG40 3HE Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    199 Finchampstead Road
    RG40 3HE Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director54580940001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LANCASTER TRUCK AND VAN SOUTH WEST LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    06 apr 2016
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione563599
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    LANCASTER TRUCK AND VAN SOUTH WEST LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge
    Creato il 27 lug 1994
    Consegnato il 02 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to the principal charge dated 31ST december 1990
    Brevi particolari
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 feb 1992
    Consegnato il 04 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and under the terms of this charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a premises on the east side of heron rd, sowton, exeter. Tile no DN110819. By way of floating security the undertaking and all property assets and rights.etc. See form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Shell U.K. Limited.
    Transazioni
    • 04 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A registered charge
    Creato il 31 dic 1990
    Consegnato il 15 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that l/h property on the east side ofheron rd sowton exeter title no:DN110819 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdepts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery (including trade fixtures.).
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 31 dic 1990
    Consegnato il 10 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A fixed charge on all book & other debts owing to the company. Floating charge over undertaking and all property and assets present and future including (book debts) (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 15 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 dic 1990
    Consegnato il 03 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land and premises being: land and premises at heren road, sowton industrial estate, exeter, devon.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 29 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0