VHC SUB-HOLDINGS (UK)
Panoramica
Nome della società | VHC SUB-HOLDINGS (UK) |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società privata a responsabilità illimitata |
Numero di società | 02494621 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di VHC SUB-HOLDINGS (UK)?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova VHC SUB-HOLDINGS (UK)?
Indirizzo della sede legale | Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road LU1 3YT Luton England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di VHC SUB-HOLDINGS (UK)?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
TELSAMON LIMITED | 20 apr 1990 | 20 apr 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di VHC SUB-HOLDINGS (UK)?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per VHC SUB-HOLDINGS (UK)?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 giu 2019 al 31 dic 2018 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Stefan Fesser come amministratore in data 30 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2017 al 30 giu 2018 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 26 mar 2016 | 24 pagine | RP04AR01 | ||||||||||
Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 26 mar 2015 | 24 pagine | RP04AR01 | ||||||||||
Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 26 mar 2014 | 25 pagine | RP04AR01 | ||||||||||
Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 26 mar 2013 | 24 pagine | RP04AR01 | ||||||||||
Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 26 mar 2012 | 24 pagine | RP04AR01 | ||||||||||
Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 26 mar 2011 | 24 pagine | RP04AR01 | ||||||||||
Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 26 mar 2010 | 23 pagine | RP04AR01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 mar 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Gm Holdings Uk No. 3 Limited come persona con controllo significativo il 18 set 2017 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Borland come amministratore in data 28 feb 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen Norman come amministratore in data 01 feb 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Rory Vincent Harvey come amministratore in data 10 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , Griffin House Uk1-101-135, Osborne Road, Luton, Bedfordshire, LU1 3YT a Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road Luton LU1 3YT in data 21 ago 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Thexton come amministratore in data 31 lug 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 26 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di VHC SUB-HOLDINGS (UK)?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGI, Rabiya Sultana | Segretario | Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Uk1-101-135 England | British | Solicitor | 29667260003 | |||||
HIGHNAM, James Charles | Amministratore | Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Uk1-101-135 England | France | British | Finance Director | 203514510001 | ||||
HOPE, Peter Thomas | Amministratore | Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Uk1-101-135 England | England | British | Director | 191426120001 | ||||
NORMAN, Stephen | Amministratore | Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Uk1-101-135 England | France | French | Director | 243325520001 | ||||
WRIGHT, Michael | Amministratore | Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Uk 1-101-135 Bedfordshire England | England | British | Director | 169818050001 | ||||
BENJAMIN, David John | Segretario | 205 Lauderdale Mansions Lauderdale Road W9 1LZ London | British | Solicitor | 54205850001 | |||||
BENJAMIN, Keith John | Segretario | 77 Northumberland Road CV32 6HQ Leamington Spa Warwickshire | British | Solicitor | 34539180005 | |||||
BENJAMIN, Keith John | Segretario | 205 Lauderdale Mansions Lauderdale Road W9 1LZ London | British | 34539180001 | ||||||
GALVIN, Lesley | Segretario | 49 Bradbourne Vale Road TN13 3QG Sevenoaks Kent | British | 84807040001 | ||||||
MCCRUM, David | Segretario | 50 Rylett Road W12 9ST London | British | 24283060003 | ||||||
ALDRED, Duncan Neil | Amministratore | Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road LU1 3YT Luton Bedfordshire | England | British | Director | 148250160001 | ||||
BENJAMIN, Keith John | Amministratore | 77 Northumberland Road CV32 6HQ Leamington Spa Warwickshire | United Kingdom | British | Solicitor | 34539180005 | ||||
BORLAND, David | Amministratore | Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road LU1 3YT Luton Bedfordshire England | England | British | Director | 181024620001 | ||||
BRANSTON, Giles Winthorpe | Amministratore | Brookfield Highgate West Hill N6 6AT London 35 | United Kingdom | British | Solicitor | 136881450001 | ||||
BURKUTEAN, Harry Gunther | Amministratore | 20c Douglas Road AL5 2EW Harpenden Hertfordshire | German | Director Of Finance | 74805050001 | |||||
CRAY, Martyn | Amministratore | Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Uk1-101-135 Bedfordshire England | United Kingdom | British | Director | 94376250001 | ||||
EBBERT, William Andrew | Amministratore | Griffin House Osbourne Road LU1 3YT Luton Beds | American | Company Executive | 47601510002 | |||||
FELDSTEIN, Eric | Amministratore | General Motors Co-Ordination Centre Nv FOREIGN Regional Treasury Ctr Neerveldstraat 107b-1200 Belgium | American | Company Executive | 26515840001 | |||||
FESSER, Stefan | Amministratore | Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Uk1-101-135 Bedfordshire | England | German | Director | 185749240001 | ||||
FRAGOSO, Miguel | Amministratore | Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Uk1-101-135 Bedfordshire England | England | British | Chief Engineer | 138074880002 | ||||
FRANCAVILLA, Antonio | Amministratore | Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road LU1 3YT Luton Bedfordshire | Uk | American Canadian | Plant Manager Director | 150485030001 | ||||
FULCHER, John Robert | Amministratore | 101-135 Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Uk1 Bedfordshire England | England | British | Director Of Finance | 76025290001 | ||||
GALVIN, Lesley | Amministratore | 49 Bradbourne Vale Road TN13 3QG Sevenoaks Kent | British | Solicitor | 84807040001 | |||||
GILSON, Andrew Robert | Amministratore | Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road LU1 3YT Luton Bedfordshire | England | British | Custiomer Experience & Corp Strategy Director | 153325350001 | ||||
GOLDEN, Charles | Amministratore | Griffin House Osborne Road LU1 3YT Luton | British | Chairman And Managing Director | 38950280001 | |||||
HARVEY, Rory Vincent | Amministratore | Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Uk1-101-135 England | Germany | British | Chairman And Managing Director | 202453920001 | ||||
HENSON, Gary Leonard | Amministratore | Griffin House Osborne Road LU1 3YT Luton Beds | American | Company Executive | 8886420001 | |||||
JAMES, Mark Neville | Amministratore | 9 Arden Grove AL5 4SJ Harpenden Hertfordshire | British | Finance Director | 74597070002 | |||||
JUNG, Werner Heinrich | Amministratore | 28 St Stephens Avenue AL3 4AD St Albans Hertfordshire | German | Company Director | 59090000003 | |||||
KIBE, Alfred Kamanja | Amministratore | Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Uk1-101-135 Bedfordshire England | England | American | Director | 201392050001 | ||||
KLAGES, Hennig A W | Amministratore | Griffin House Osborne Road LU1 3YT Luton Beds | German | 23380350001 | ||||||
MILLWARD, Philip | Amministratore | Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road LU1 3YT Luton Bedfordshire | England | British | Hr Director | 84519620002 | ||||
MOLYNEUX, Richard John | Amministratore | Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road LU1 3YT Luton Bedfordshire | United Kingdom | British | Finance Director | 310811830001 | ||||
PARFITT, Christopher William | Amministratore | Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road LU1 3YT Luton Bedfordshire | England | British | Director | 77006150003 | ||||
REILLY, David Nicholas | Amministratore | Crowholt George Street Woburn MK17 9PX Milton Keynes | British | Managing Director | 51668350005 |
Chi sono le persone con controllo significativo di VHC SUB-HOLDINGS (UK)?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holdings Uk No.3 Limited | 06 apr 2016 | Osborne Road LU1 3YT Luton Uk1-101-135, Griffin House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
VHC SUB-HOLDINGS (UK) ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Share charge | Creato il 07 lug 2009 Consegnato il 15 lug 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Shares in general motor UK limited and dividends, see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 21 dic 1992 Consegnato il 22 dic 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to clause 5 (b) of the option agreement dated 6/10/92 and to which the company has acceded by virtue of a deed of adherence dated 17/12/92 | |
Brevi particolari First legal mortgage the bonds, the secondary coupons and the talons including all its right title and interest in and to the above and further including all voting and other rights benefits and advantages whatsoever (see form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 18 dic 1991 Consegnato il 24 dic 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to clause 5 (b) of a call agreement dated 5/11/91 (as amended by an agreement dated 13/11/91 and to which the company has acceded by virtue of a deed of adherence dated 4/12/91 | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage, the bonds, the secondary coupons and the talons including all its right title and interest in an to the bonds secondary coupons and talons see 395 for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0