VHC SUB-HOLDINGS (UK)

VHC SUB-HOLDINGS (UK)

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVHC SUB-HOLDINGS (UK)
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 02494621
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VHC SUB-HOLDINGS (UK)?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova VHC SUB-HOLDINGS (UK)?

    Indirizzo della sede legale
    Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VHC SUB-HOLDINGS (UK)?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TELSAMON LIMITED20 apr 199020 apr 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di VHC SUB-HOLDINGS (UK)?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per VHC SUB-HOLDINGS (UK)?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 giu 2019 al 31 dic 2018

    1 pagineAA01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Stefan Fesser come amministratore in data 30 giu 2018

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2017 al 30 giu 2018

    1 pagineAA01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 26 mar 2016

    24 pagineRP04AR01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 26 mar 2015

    24 pagineRP04AR01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 26 mar 2014

    25 pagineRP04AR01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 26 mar 2013

    24 pagineRP04AR01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 26 mar 2012

    24 pagineRP04AR01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 26 mar 2011

    24 pagineRP04AR01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 26 mar 2010

    23 pagineRP04AR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 mar 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Gm Holdings Uk No. 3 Limited come persona con controllo significativo il 18 set 2017

    2 paginePSC05

    Cessazione della carica di David Borland come amministratore in data 28 feb 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Norman come amministratore in data 01 feb 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Rory Vincent Harvey come amministratore in data 10 gen 2018

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da , Griffin House Uk1-101-135, Osborne Road, Luton, Bedfordshire, LU1 3YT a Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road Luton LU1 3YT in data 21 ago 2017

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Christopher Thexton come amministratore in data 31 lug 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio annuale redatto al 26 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 apr 2016

    Stato del capitale al 20 apr 2016

    • Capitale: GBP 1,784,863,425
    SH01
    Note
    DataNota
    18 apr 2018Clarification A second filed AR01 was registered on 18/04/2018.

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    15 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di VHC SUB-HOLDINGS (UK)?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NAGI, Rabiya Sultana
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    England
    Segretario
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    England
    BritishSolicitor29667260003
    HIGHNAM, James Charles
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    England
    Amministratore
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    England
    FranceBritishFinance Director203514510001
    HOPE, Peter Thomas
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    England
    Amministratore
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    England
    EnglandBritishDirector191426120001
    NORMAN, Stephen
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    England
    Amministratore
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    England
    FranceFrenchDirector243325520001
    WRIGHT, Michael
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk 1-101-135
    Bedfordshire
    England
    Amministratore
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk 1-101-135
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritishDirector169818050001
    BENJAMIN, David John
    205 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LZ London
    Segretario
    205 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LZ London
    BritishSolicitor54205850001
    BENJAMIN, Keith John
    77 Northumberland Road
    CV32 6HQ Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    77 Northumberland Road
    CV32 6HQ Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishSolicitor34539180005
    BENJAMIN, Keith John
    205 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LZ London
    Segretario
    205 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LZ London
    British34539180001
    GALVIN, Lesley
    49 Bradbourne Vale Road
    TN13 3QG Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    49 Bradbourne Vale Road
    TN13 3QG Sevenoaks
    Kent
    British84807040001
    MCCRUM, David
    50 Rylett Road
    W12 9ST London
    Segretario
    50 Rylett Road
    W12 9ST London
    British24283060003
    ALDRED, Duncan Neil
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector148250160001
    BENJAMIN, Keith John
    77 Northumberland Road
    CV32 6HQ Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    77 Northumberland Road
    CV32 6HQ Leamington Spa
    Warwickshire
    United KingdomBritishSolicitor34539180005
    BORLAND, David
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    England
    Amministratore
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritishDirector181024620001
    BRANSTON, Giles Winthorpe
    Brookfield
    Highgate West Hill
    N6 6AT London
    35
    Amministratore
    Brookfield
    Highgate West Hill
    N6 6AT London
    35
    United KingdomBritishSolicitor136881450001
    BURKUTEAN, Harry Gunther
    20c Douglas Road
    AL5 2EW Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    20c Douglas Road
    AL5 2EW Harpenden
    Hertfordshire
    GermanDirector Of Finance74805050001
    CRAY, Martyn
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    Amministratore
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    United KingdomBritishDirector94376250001
    EBBERT, William Andrew
    Griffin House
    Osbourne Road
    LU1 3YT Luton
    Beds
    Amministratore
    Griffin House
    Osbourne Road
    LU1 3YT Luton
    Beds
    AmericanCompany Executive47601510002
    FELDSTEIN, Eric
    General Motors Co-Ordination Centre Nv
    FOREIGN Regional Treasury Ctr Neerveldstraat 107b-1200
    Belgium
    Amministratore
    General Motors Co-Ordination Centre Nv
    FOREIGN Regional Treasury Ctr Neerveldstraat 107b-1200
    Belgium
    AmericanCompany Executive26515840001
    FESSER, Stefan
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    Amministratore
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    EnglandGermanDirector185749240001
    FRAGOSO, Miguel
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    Amministratore
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritishChief Engineer138074880002
    FRANCAVILLA, Antonio
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    UkAmerican CanadianPlant Manager Director150485030001
    FULCHER, John Robert
    101-135 Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1
    Bedfordshire
    England
    Amministratore
    101-135 Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritishDirector Of Finance76025290001
    GALVIN, Lesley
    49 Bradbourne Vale Road
    TN13 3QG Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    49 Bradbourne Vale Road
    TN13 3QG Sevenoaks
    Kent
    BritishSolicitor84807040001
    GILSON, Andrew Robert
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    EnglandBritishCustiomer Experience & Corp Strategy Director153325350001
    GOLDEN, Charles
    Griffin House
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Amministratore
    Griffin House
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    BritishChairman And Managing Director38950280001
    HARVEY, Rory Vincent
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    England
    Amministratore
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    England
    GermanyBritishChairman And Managing Director202453920001
    HENSON, Gary Leonard
    Griffin House
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Beds
    Amministratore
    Griffin House
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Beds
    AmericanCompany Executive8886420001
    JAMES, Mark Neville
    9 Arden Grove
    AL5 4SJ Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    9 Arden Grove
    AL5 4SJ Harpenden
    Hertfordshire
    BritishFinance Director74597070002
    JUNG, Werner Heinrich
    28 St Stephens Avenue
    AL3 4AD St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    28 St Stephens Avenue
    AL3 4AD St Albans
    Hertfordshire
    GermanCompany Director59090000003
    KIBE, Alfred Kamanja
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    Amministratore
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    EnglandAmericanDirector201392050001
    KLAGES, Hennig A W
    Griffin House
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Beds
    Amministratore
    Griffin House
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Beds
    German23380350001
    MILLWARD, Philip
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    EnglandBritishHr Director84519620002
    MOLYNEUX, Richard John
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    United KingdomBritishFinance Director310811830001
    PARFITT, Christopher William
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector77006150003
    REILLY, David Nicholas
    Crowholt George Street
    Woburn
    MK17 9PX Milton Keynes
    Amministratore
    Crowholt George Street
    Woburn
    MK17 9PX Milton Keynes
    BritishManaging Director51668350005

    Chi sono le persone con controllo significativo di VHC SUB-HOLDINGS (UK)?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Holdings Uk No.3 Limited
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Uk1-101-135, Griffin House
    England
    06 apr 2016
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Uk1-101-135, Griffin House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House, England And Wales
    Numero di registrazione07549094
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    VHC SUB-HOLDINGS (UK) ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Share charge
    Creato il 07 lug 2009
    Consegnato il 15 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Shares in general motor UK limited and dividends, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale
    Transazioni
    • 15 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 21 dic 1992
    Consegnato il 22 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to clause 5 (b) of the option agreement dated 6/10/92 and to which the company has acceded by virtue of a deed of adherence dated 17/12/92
    Brevi particolari
    First legal mortgage the bonds, the secondary coupons and the talons including all its right title and interest in and to the above and further including all voting and other rights benefits and advantages whatsoever (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Citibank (Channel Islands) LTD
    Transazioni
    • 22 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 18 dic 1991
    Consegnato il 24 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to clause 5 (b) of a call agreement dated 5/11/91 (as amended by an agreement dated 13/11/91 and to which the company has acceded by virtue of a deed of adherence dated 4/12/91
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage, the bonds, the secondary coupons and the talons including all its right title and interest in an to the bonds secondary coupons and talons see 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 24 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0