BRACKNELL (123) LIMITED

BRACKNELL (123) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRACKNELL (123) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02499732
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRACKNELL (123) LIMITED?

    • (5242) /
    • (5243) /

    Dove si trova BRACKNELL (123) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o C/O, BDO STOY HAYWARD LLP
    BDO STOY HAYWARD LLP
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRACKNELL (123) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SOCK SHOP HOLDINGS LIMITED20 ago 199020 ago 1990
    FULLCHANCE LIMITED08 mag 199008 mag 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRACKNELL (123) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al

    Quali sono le ultime deposizioni per BRACKNELL (123) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 mag 2011

    5 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 dic 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 giu 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 dic 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 giu 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 dic 2008

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 giu 2008

    5 pagine4.68

    legacy

    1 pagine287

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dimissioni di un liquidatore

    1 pagine4.33

    legacy

    1 pagine287

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    5 pagine3.6

    legacy

    1 pagine405(2)

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Chi sono gli amministratori di BRACKNELL (123) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HARRISON, Christopher Thomas
    183 High Storrs Road
    S11 7LH Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    183 High Storrs Road
    S11 7LH Sheffield
    South Yorkshire
    British40351490001
    HARRISON, Christopher Thomas
    183 High Storrs Road
    S11 7LH Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    183 High Storrs Road
    S11 7LH Sheffield
    South Yorkshire
    BritishFinance Dir40351490001
    HINCHLIFFE, Stephen Leonard
    Long Acres Newfield Lane
    Dore
    S17 3DA Sheffield
    Amministratore
    Long Acres Newfield Lane
    Dore
    S17 3DA Sheffield
    BritishDirector4235010002
    COLLINS, Robert Bruce
    50 Courtway
    TW2 7SN Twickenham
    Middlesex
    Segretario
    50 Courtway
    TW2 7SN Twickenham
    Middlesex
    New ZealanderAccountant40223610002
    DOUGLAS, James Barclay
    Hill House Silchester Road
    Little London
    RG26 5EP Tadley
    Hampshire
    Segretario
    Hill House Silchester Road
    Little London
    RG26 5EP Tadley
    Hampshire
    British159117650001
    COLLINS, Robert Bruce
    50 Courtway
    TW2 7SN Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    50 Courtway
    TW2 7SN Twickenham
    Middlesex
    New ZealanderAccountant40223610002
    DENNING, Roland John
    Swallowfield Grange
    The Street
    RG7 1RE Swallowfield
    Berkshire
    Amministratore
    Swallowfield Grange
    The Street
    RG7 1RE Swallowfield
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director95991510001
    DOUGLAS, James Barclay
    Hill House Silchester Road
    Little London
    RG26 5EP Tadley
    Hampshire
    Amministratore
    Hill House Silchester Road
    Little London
    RG26 5EP Tadley
    Hampshire
    United KingdomBritishCompany Director159117650001
    FITCH, William
    Foxhall
    19 Broomhill Park
    BT9 6JB Belfast
    Antrim
    Amministratore
    Foxhall
    19 Broomhill Park
    BT9 6JB Belfast
    Antrim
    BritishChartered Accountant49478560001
    JONES, Alan
    43 Clover Field
    Clayton Le Woods
    PR6 7RU Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    43 Clover Field
    Clayton Le Woods
    PR6 7RU Chorley
    Lancashire
    BritishDirector37996360001
    MACLELLAN, Alexander David
    The Bower
    Kilbarchan
    PA10 2PD Renfrewshire
    Amministratore
    The Bower
    Kilbarchan
    PA10 2PD Renfrewshire
    ScotlandBritishInvestment Manager66440950001
    OLASO, Juan
    Brown Gables Forest Edge Road Crow
    Blashford
    BH24 3PF Ringwood
    Hampshire
    Amministratore
    Brown Gables Forest Edge Road Crow
    Blashford
    BH24 3PF Ringwood
    Hampshire
    SpanishCompany Director57057930001
    PEARS, Edmund Richard Harry
    The Old Manor House
    Little Comberton
    WR10 3ER Pershore
    Worcestershire
    Amministratore
    The Old Manor House
    Little Comberton
    WR10 3ER Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritishCompany Director97621600001
    SMITH, Christopher Winston
    7 The Avenue
    Sneyd Park
    BS9 1PD Bristol
    Amministratore
    7 The Avenue
    Sneyd Park
    BS9 1PD Bristol
    United KingdomBritishChartered Accountant37052960001

    BRACKNELL (123) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 07 feb 1996
    Consegnato il 27 feb 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility documents (as defined therein) including, without limitation, the guaranteed liabilities (as defined in the cross guarantee) (as defined therein)
    Brevi particolari
    The various properties as listed in the schedule to the form 395 inclusive of 81 union street, aberdeen; 1 burton street, bath and 22 donegal place, belfast. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • United Mizrahi Bank Limited
    Transazioni
    • 27 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 1996Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 14 feb 2003Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (405 (2))
      • Numero di pratica 1
    Debenture
    Creato il 26 mag 1994
    Consegnato il 10 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Murray Johnstone Limited
    Transazioni
    • 10 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mar 1994
    Consegnato il 14 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself and as a trustee for any person(s) to whom the indebtedness or any part thereof is assigned or transferred from time to time under the terms of the trust deed dated 31 march 1994 and this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Murray Johnstone Limited
    Transazioni
    • 14 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 dic 1993
    Consegnato il 14 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a trust deed dated 30TH decmber 1993
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Murray Johnstone Limited
    Transazioni
    • 14 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 31 mar 1993
    Consegnato il 14 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £78218.00 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurances particulars of which are set out on the paper apart to form 395 see form 395 M97C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 14 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of rental deposit
    Creato il 23 ott 1991
    Consegnato il 25 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 23.7.82
    Brevi particolari
    The sum of £25,000 in a specifically designated deposit account in the name of astrea preperties bv together with any other sums paid into the account pursuant to the terms of the said deed of rental deposit.
    Persone aventi diritto
    • Astrea Properties Bv
    Transazioni
    • 25 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 06 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed.
    Creato il 16 ago 1991
    Consegnato il 03 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The due and promp performance of the coverants and warranty of the part of the company and I nfavour of mepc mayfair properties united as contained in the lease or in the deed.
    Brevi particolari
    The security deposit being £14,250 held in the name of the company.
    Persone aventi diritto
    • Mepc Mayfair Propeties Limited
    Transazioni
    • 03 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 06 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 mag 1991
    Consegnato il 07 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Governor & Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 11 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed.
    Creato il 03 ago 1990
    Consegnato il 23 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of this charge.
    Brevi particolari
    All the company's freehold and leasehold property (if any) both present and future and all buildings & fixtures, fixed plant & machinery from time to time all books debts both present & future and the benefit of all rights (see form M395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Murray Johnstone Limited(As Trustee).
    Transazioni
    • 23 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 06 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BRACKNELL (123) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 feb 1996Data dello strumento
    Ricevitore amministrativo nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Anthony Brittain Thompson
    Po Box 730
    20 Farringdon Street
    EC4A 4PP London
    Praticante
    Po Box 730
    20 Farringdon Street
    EC4A 4PP London
    Michael David Blake
    20 Farringdon Street
    London
    EC4A 4PP
    Praticante
    20 Farringdon Street
    London
    EC4A 4PP
    2
    DataTipo
    14 feb 2012Data di scioglimento
    10 dic 1996Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Peter Richard Copp
    8 Baker Street
    London
    W1M 1DA
    Praticante
    8 Baker Street
    London
    W1M 1DA
    Malcolm Cohen
    Bdo Stoy Hayward Llp
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Praticante
    Bdo Stoy Hayward Llp
    8 Baker Street
    W1U 3LL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0