SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED

SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02501443
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Eboracum Way
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ARTFRESH LIMITED11 mag 199011 mag 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di John Daniel Mclaughlin come amministratore in data 02 ago 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Hugo Charles Kimber come amministratore in data 02 ago 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Abhishek Goenka come amministratore in data 10 lug 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Jonathan David Ross come amministratore in data 23 gen 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2018

    13 pagineAA

    legacy

    46 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Iscrizione dell'ipoteca 025014430010, creata il 29 nov 2018

    32 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 025014430011, creata il 29 nov 2018

    50 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 025014430009 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Jacqueline Susan Rigby come amministratore in data 11 mag 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2017

    13 pagineAA

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    48 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Cessazione della carica di Alistair Rodger come amministratore in data 31 mag 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mr. John Daniel Mclaughlin come amministratore in data 03 mag 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr. Jonathan David Ross come amministratore in data 03 mag 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms. Jacqueline Susan Rigby come amministratore in data 03 mag 2017

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KERKAR, Ajay Ajit Peter
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    Yorkshire
    Amministratore
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    Yorkshire
    United KingdomIndian171005990001
    BADDELEY, Robert Gregory
    2 Devisdale Grange
    Groby Road Bowdon
    WA14 2BY Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    2 Devisdale Grange
    Groby Road Bowdon
    WA14 2BY Altrincham
    Cheshire
    British28024220004
    CULLEN, Dominique
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    Yorkshire
    Segretario
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    Yorkshire
    195246320001
    MAY, Timothy William
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    England
    Segretario
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    England
    192246940001
    WILLIAMSON, Alexandra Dilys
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    British100325220002
    WRAY, Mark Christopher
    32 Hillcrest Avenue
    Nether Poppleton
    YO2 6LD York
    Segretario
    32 Hillcrest Avenue
    Nether Poppleton
    YO2 6LD York
    British25762230002
    ALLAN, Leslie Stewart
    78 Honor Oak Road
    SE23 3RR London
    Amministratore
    78 Honor Oak Road
    SE23 3RR London
    British1704690001
    ATKINS, Jane Louise
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    Yorkshire
    Amministratore
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    Yorkshire
    United KingdomBritish207125210001
    ATKINSON, Richard Westaway
    Smithy Lane Farm
    Rainow
    SK10 5UP Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Smithy Lane Farm
    Rainow
    SK10 5UP Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritish111861370001
    BADDELEY, Robert Gregory
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Great BritainBritish28024220020
    BALI, Navneet
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish83088120002
    BRIGHT, Neil Irvine
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish180993450001
    CREW, James Robert
    123 Hale Road
    Hale
    WA15 9HQ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    123 Hale Road
    Hale
    WA15 9HQ Altrincham
    Cheshire
    British15842470001
    CUST, Nicholas Pury
    Crookhill
    The Village Skelton
    YO3 6XY York
    Amministratore
    Crookhill
    The Village Skelton
    YO3 6XY York
    United KingdomBritish159977730001
    DAVIES, Martin William Oliver
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish98399000002
    FENNEMORE, Roger Arnold
    25 Chapel Street
    Woburn Sands
    MK17 8PG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    25 Chapel Street
    Woburn Sands
    MK17 8PG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British9399600002
    FERRIN, Eamonn
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    Amministratore
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United KingdomIrish146776900001
    GOENKA, Abhishek
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    Yorkshire
    Amministratore
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    Yorkshire
    United KingdomIndian192234860001
    HOPE, Stuart Malcolm Ronald
    8 Nesbitt Square
    Coxwell Road
    SE19 3AB London
    Amministratore
    8 Nesbitt Square
    Coxwell Road
    SE19 3AB London
    British49358260001
    JARVIS, Susan
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    Yorkshire
    Amministratore
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    Yorkshire
    United KingdomBritish199100680002
    JONES, Raymond Anthony Patrick
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish60728450002
    KIMBER, Hugo Charles
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    Yorkshire
    Amministratore
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    Yorkshire
    EnglandBritish113847000002
    LEPPARD, Martin Neal
    Claverdon Manor
    Manor Lane
    CV35 8NH Claverdon
    Warwickshire
    Amministratore
    Claverdon Manor
    Manor Lane
    CV35 8NH Claverdon
    Warwickshire
    EnglandBritish155863600001
    MAY, Timothy William
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    England
    EnglandBritish27408660003
    MCLAUGHLIN, John Daniel
    30 Millbank
    SW1P 4DU London
    3rd Floor, C/O Holidaybreak Ltd
    England
    Amministratore
    30 Millbank
    SW1P 4DU London
    3rd Floor, C/O Holidaybreak Ltd
    England
    United KingdomBritish230948990001
    MICHEL, Carl Heinrich
    2 College Place
    Hortensia Road
    SW10 0QZ London
    Amministratore
    2 College Place
    Hortensia Road
    SW10 0QZ London
    EnglandBritish107791560001
    MOUNSER, Ian Peter
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish50419570001
    NEYLON, Darren Lee
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    Yorkshire
    Amministratore
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    Yorkshire
    EnglandEnglish69978820001
    REGAN, Frank
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish35768770001
    RIGBY, Jacqueline Susan, Dr
    30 Millbank
    SW1P 4DU London
    3rd Floor, C/O Holidaybreak Ltd
    England
    Amministratore
    30 Millbank
    SW1P 4DU London
    3rd Floor, C/O Holidaybreak Ltd
    England
    EnglandBritish230918770001
    RODGER, Alistair
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    Yorkshire
    Amministratore
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    Yorkshire
    United KingdomBritish246630430001
    ROSS, Jonathan David
    Millbank
    SW1P 4DU London
    3rd Floor, C/O Holidaybreak Ltd
    England
    Amministratore
    Millbank
    SW1P 4DU London
    3rd Floor, C/O Holidaybreak Ltd
    England
    EnglandBritish48869790001
    WADHAMS, Tim
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    Yorkshire
    Amministratore
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    Yorkshire
    United KingdomBritish206620140001
    WILLIAMSON, Alexandra Dilys
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish100325220002
    WRAY, Mark Christopher
    The Granary Church Lane
    Nether Poppleton
    YO26 6LF York
    Amministratore
    The Granary Church Lane
    Nether Poppleton
    YO26 6LF York
    United KingdomBritish25762230003

    Chi sono le persone con controllo significativo di SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Malvern Travel Limited
    30 Millbank
    SW1P 4DU London
    3rd Floor
    England
    06 apr 2016
    30 Millbank
    SW1P 4DU London
    3rd Floor
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUk Companies Act 2006
    Luogo di registrazioneUk Companies Registry
    Numero di registrazione10049427
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 29 nov 2018
    Consegnato il 05 dic 2018
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Yes Bank Limited, Ifsc Banking Unit (As Lender (as Defined in the Debenture))
    Transazioni
    • 05 dic 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 29 nov 2018
    Consegnato il 05 dic 2018
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Yes Bank Limited, Ifsc Banking Unit (As Lender (as Defined in the Share Charge))
    Transazioni
    • 05 dic 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 11 mag 2016
    Consegnato il 17 mag 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    A fixed charge over the intellectual property right in respect of the trademark with trademark number 3289501 and other intellectual property rights detailed in part 4 of schedule 1 to the charging instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Axis Bank Limited, Difc Branch (As Security Agent for the Secured Parties from Time to Time (as Defined in the Instrument))
    Transazioni
    • 17 mag 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 ago 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 04 set 2014
    Consegnato il 15 set 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 set 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 13 apr 2016Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 23 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    English law security agreement
    Creato il 29 giu 2012
    Consegnato il 13 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 apr 2016Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 23 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 09 mag 2008
    Consegnato il 16 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Hartford manor hartford northwich t/no CH424893. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 16 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 01 ago 2000
    Consegnato il 16 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities of each charging company (as defined) to the chargee and the security beneficiaries (or any of them) under the banking documents to which such charging company is a party
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed to the debenture dated 3RD february 1995
    Creato il 09 feb 1998
    Consegnato il 11 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities at the date of the supplemental deed or thereafter due owing or incurred by the company to national westminster bank PLC (the "security trustee") and to the beneficiaries (as defined) or any of them (whether under the facility agreements,and the facility documents as defined or otherwise) and by guarantee the obligations of each other company and any other subsidiary of the parent (the guaranteed obligations)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 lug 1995
    Consegnato il 14 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security agent and trustee for and on behalf of the beneficiaries (as defined therein) on any account whatsoever whether under any of the facility agreements, the facility documents (as defined therein) or otherwise
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 14 giu 1990
    Consegnato il 29 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompanys and/or superbreak mini holidayslimited under the terms of the charge to the chargee.
    Brevi particolari
    (See doc M247 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 05 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 14 giu 1990
    Consegnato il 29 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee under or by virtue of the indemnity and/or clause 17.4 of a facilities agreement dated 14/06/90
    Brevi particolari
    All the companys right, title and interest in and to all moneys the collateral in whatever. Currency at the date of the security agreement or atany time standing to the credit of the. Account designated barclays bank PLC re artfresh limited with barclays bank finance company. Jersey limited see doc M249 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 05 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0