SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02501443 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Eboracum Way Heworth Green YO31 7RE York Yorkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ARTFRESH LIMITED | 11 mag 1990 | 11 mag 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||
Cessazione della carica di John Daniel Mclaughlin come amministratore in data 02 ago 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Hugo Charles Kimber come amministratore in data 02 ago 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Abhishek Goenka come amministratore in data 10 lug 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Jonathan David Ross come amministratore in data 23 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2018 | 13 pagine | AA | ||
legacy | 46 pagine | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
Iscrizione dell'ipoteca 025014430010, creata il 29 nov 2018 | 32 pagine | MR01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca 025014430011, creata il 29 nov 2018 | 50 pagine | MR01 | ||
Soddisfazione dell'onere 025014430009 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Jacqueline Susan Rigby come amministratore in data 11 mag 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2017 | 13 pagine | AA | ||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||
legacy | 48 pagine | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
Cessazione della carica di Alistair Rodger come amministratore in data 31 mag 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr. John Daniel Mclaughlin come amministratore in data 03 mag 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr. Jonathan David Ross come amministratore in data 03 mag 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Ms. Jacqueline Susan Rigby come amministratore in data 03 mag 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Chi sono gli amministratori di SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KERKAR, Ajay Ajit Peter | Amministratore | Heworth Green YO31 7RE York Eboracum Way Yorkshire | United Kingdom | Indian | 171005990001 | |||||
| BADDELEY, Robert Gregory | Segretario | 2 Devisdale Grange Groby Road Bowdon WA14 2BY Altrincham Cheshire | British | 28024220004 | ||||||
| CULLEN, Dominique | Segretario | Heworth Green YO31 7RE York Eboracum Way Yorkshire | 195246320001 | |||||||
| MAY, Timothy William | Segretario | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire England | 192246940001 | |||||||
| WILLIAMSON, Alexandra Dilys | Segretario | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | British | 100325220002 | ||||||
| WRAY, Mark Christopher | Segretario | 32 Hillcrest Avenue Nether Poppleton YO2 6LD York | British | 25762230002 | ||||||
| ALLAN, Leslie Stewart | Amministratore | 78 Honor Oak Road SE23 3RR London | British | 1704690001 | ||||||
| ATKINS, Jane Louise | Amministratore | Heworth Green YO31 7RE York Eboracum Way Yorkshire | United Kingdom | British | 207125210001 | |||||
| ATKINSON, Richard Westaway | Amministratore | Smithy Lane Farm Rainow SK10 5UP Macclesfield Cheshire | England | British | 111861370001 | |||||
| BADDELEY, Robert Gregory | Amministratore | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | Great Britain | British | 28024220020 | |||||
| BALI, Navneet | Amministratore | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 83088120002 | |||||
| BRIGHT, Neil Irvine | Amministratore | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 180993450001 | |||||
| CREW, James Robert | Amministratore | 123 Hale Road Hale WA15 9HQ Altrincham Cheshire | British | 15842470001 | ||||||
| CUST, Nicholas Pury | Amministratore | Crookhill The Village Skelton YO3 6XY York | United Kingdom | British | 159977730001 | |||||
| DAVIES, Martin William Oliver | Amministratore | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | England | British | 98399000002 | |||||
| FENNEMORE, Roger Arnold | Amministratore | 25 Chapel Street Woburn Sands MK17 8PG Milton Keynes Buckinghamshire | British | 9399600002 | ||||||
| FERRIN, Eamonn | Amministratore | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire | United Kingdom | Irish | 146776900001 | |||||
| GOENKA, Abhishek | Amministratore | Heworth Green YO31 7RE York Eboracum Way Yorkshire | United Kingdom | Indian | 192234860001 | |||||
| HOPE, Stuart Malcolm Ronald | Amministratore | 8 Nesbitt Square Coxwell Road SE19 3AB London | British | 49358260001 | ||||||
| JARVIS, Susan | Amministratore | Heworth Green YO31 7RE York Eboracum Way Yorkshire | United Kingdom | British | 199100680002 | |||||
| JONES, Raymond Anthony Patrick | Amministratore | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 60728450002 | |||||
| KIMBER, Hugo Charles | Amministratore | Heworth Green YO31 7RE York Eboracum Way Yorkshire | England | British | 113847000002 | |||||
| LEPPARD, Martin Neal | Amministratore | Claverdon Manor Manor Lane CV35 8NH Claverdon Warwickshire | England | British | 155863600001 | |||||
| MAY, Timothy William | Amministratore | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire England | England | British | 27408660003 | |||||
| MCLAUGHLIN, John Daniel | Amministratore | 30 Millbank SW1P 4DU London 3rd Floor, C/O Holidaybreak Ltd England | United Kingdom | British | 230948990001 | |||||
| MICHEL, Carl Heinrich | Amministratore | 2 College Place Hortensia Road SW10 0QZ London | England | British | 107791560001 | |||||
| MOUNSER, Ian Peter | Amministratore | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 50419570001 | |||||
| NEYLON, Darren Lee | Amministratore | Heworth Green YO31 7RE York Eboracum Way Yorkshire | England | English | 69978820001 | |||||
| REGAN, Frank | Amministratore | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 35768770001 | |||||
| RIGBY, Jacqueline Susan, Dr | Amministratore | 30 Millbank SW1P 4DU London 3rd Floor, C/O Holidaybreak Ltd England | England | British | 230918770001 | |||||
| RODGER, Alistair | Amministratore | Heworth Green YO31 7RE York Eboracum Way Yorkshire | United Kingdom | British | 246630430001 | |||||
| ROSS, Jonathan David | Amministratore | Millbank SW1P 4DU London 3rd Floor, C/O Holidaybreak Ltd England | England | British | 48869790001 | |||||
| WADHAMS, Tim | Amministratore | Heworth Green YO31 7RE York Eboracum Way Yorkshire | United Kingdom | British | 206620140001 | |||||
| WILLIAMSON, Alexandra Dilys | Amministratore | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 100325220002 | |||||
| WRAY, Mark Christopher | Amministratore | The Granary Church Lane Nether Poppleton YO26 6LF York | United Kingdom | British | 25762230003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malvern Travel Limited | 06 apr 2016 | 30 Millbank SW1P 4DU London 3rd Floor England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 29 nov 2018 Consegnato il 05 dic 2018 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 29 nov 2018 Consegnato il 05 dic 2018 | In corso | ||
Breve descrizione N/A. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 11 mag 2016 Consegnato il 17 mag 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione A fixed charge over the intellectual property right in respect of the trademark with trademark number 3289501 and other intellectual property rights detailed in part 4 of schedule 1 to the charging instrument. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 04 set 2014 Consegnato il 15 set 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| English law security agreement | Creato il 29 giu 2012 Consegnato il 13 lug 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and each other chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 09 mag 2008 Consegnato il 16 mag 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Hartford manor hartford northwich t/no CH424893. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 01 ago 2000 Consegnato il 16 ago 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations and liabilities of each charging company (as defined) to the chargee and the security beneficiaries (or any of them) under the banking documents to which such charging company is a party | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed to the debenture dated 3RD february 1995 | Creato il 09 feb 1998 Consegnato il 11 feb 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations and liabilities at the date of the supplemental deed or thereafter due owing or incurred by the company to national westminster bank PLC (the "security trustee") and to the beneficiaries (as defined) or any of them (whether under the facility agreements,and the facility documents as defined or otherwise) and by guarantee the obligations of each other company and any other subsidiary of the parent (the guaranteed obligations) | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 26 lug 1995 Consegnato il 14 ago 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee as security agent and trustee for and on behalf of the beneficiaries (as defined therein) on any account whatsoever whether under any of the facility agreements, the facility documents (as defined therein) or otherwise | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 14 giu 1990 Consegnato il 29 giu 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from thecompanys and/or superbreak mini holidayslimited under the terms of the charge to the chargee. | |
Brevi particolari (See doc M247 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 14 giu 1990 Consegnato il 29 giu 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from thecompany to the chargee under or by virtue of the indemnity and/or clause 17.4 of a facilities agreement dated 14/06/90 | |
Brevi particolari All the companys right, title and interest in and to all moneys the collateral in whatever. Currency at the date of the security agreement or atany time standing to the credit of the. Account designated barclays bank PLC re artfresh limited with barclays bank finance company. Jersey limited see doc M249 for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0