ANGLIAN STRAW LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ANGLIAN STRAW LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02501581 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ANGLIAN STRAW LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova ANGLIAN STRAW LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 6th Floor 33 Holborn EC1N 2HT London England England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ANGLIAN STRAW LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BANKS ODAM DENNICK LIMITED | 25 mag 1990 | 25 mag 1990 |
| ELDEE (NO 8) LIMITED | 14 mag 1990 | 14 mag 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ANGLIAN STRAW LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per ANGLIAN STRAW LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 mag 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Octopus Company Secretarial Services Limited come segretario in data 15 nov 2018 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sharna Ludlow come segretario in data 15 nov 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Stephen Latham il 07 set 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kamalika Ria Banerjee come segretario in data 19 feb 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 mag 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Kamalika Ria Banerjee come segretario in data 30 ott 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr Paul Stephen Latham come amministratore in data 15 ago 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Matthew George Setchell il 20 feb 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Tim James Senior come amministratore in data 06 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 6th Floor 33 Holborn London England EC1N 2HT | 2 pagine | AD04 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Company Secretary Sharna Ludlow il 31 mag 2016 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Nomina di Company Secretary Sharna Ludlow come segretario in data 06 mag 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Karen Ward come segretario in data 06 mag 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 6 Deben Mill Business Centre Old Maltings Approach Woodbridge Suffolk IP12 1BL a 6th Floor 33 Holborn London England EC1N 2HT in data 01 apr 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 mar 2016 al 30 giu 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Nomina di Karen Ward come segretario in data 05 gen 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ANGLIAN STRAW LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTOPUS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | Holborn EC1N 2HT London 33 England England |
| 253893850001 | ||||||||||
| LATHAM, Paul Stephen | Amministratore | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | United Kingdom | British | 146527710002 | |||||||||
| SETCHELL, Matthew George | Amministratore | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | England | British | 157021230004 | |||||||||
| WILKINSON, Edwin John | Amministratore | Deben Mill Business Centre Old Maltings Approach IP12 1BL Woodbridge 6 Suffolk United Kingdom | England | British | 86926370001 | |||||||||
| BANERJEE, Kamalika Ria | Segretario | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | 239579240001 | |||||||||||
| HELPS, Annabelle Penney | Segretario | 112 Cromwell Tower Barbican EC2Y 8DD London | Australian | 81687520005 | ||||||||||
| LUDLOW, Sharna | Segretario | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | 207937290001 | |||||||||||
| MCINNES, Charles Malcolm | Segretario | 20 Willoughby Close Alveston BS35 3RW Bristol | British | 81330480001 | ||||||||||
| MUIR, David Scott | Segretario | 29 Fieldgate Lane CV8 1BT Kenilworth Warwickshire | British | 21883690003 | ||||||||||
| THOMSON, Colin Newman | Segretario | 16 Rutland Gardens SG19 1JG Sandy Bedfordshire | British | 36211260001 | ||||||||||
| WARD, Karen | Segretario | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | 204126910001 | |||||||||||
| WILLIAMS, David James, Dr | Segretario | Steepholme Pen Y Lan Road NP10 8RW Newport | British | 155170640001 | ||||||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Segretario | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 60471940015 | |||||||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Segretario | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 60471940015 | |||||||||||
| ALLISON, Stuart Conyers | Amministratore | Hambleton Wellcreek Road PE14 8PE Outwell Norfolk | United Kingdom | British | 14745230001 | |||||||||
| ANTHONY, Paul | Amministratore | Wentworth House St Leonards Hill SL4 4AT Windsor Berkshire | British | 81406540001 | ||||||||||
| BANKS, Richard Lewin | Amministratore | Chestnut House Mill Lane SG19 1NH Sandy Bedfordshire | England | British | 1724090001 | |||||||||
| BRYANT, John | Amministratore | Down Street W1J 7AJ London 7 | England | British | 16812800002 | |||||||||
| BRYANT, John | Amministratore | Down Street W1J 7AJ London 7 | England | British | 16812800002 | |||||||||
| CHAMBERLAIN, Michael Edward | Amministratore | Tithe Cottage Broad Drove Gayton Kings Lynn Norfolk | British | 22573340001 | ||||||||||
| CHILTON, Malcolm David | Amministratore | 20 Prosper Meadow DY6 8BA Kingswinford West Midlands | United Kingdom | British | 145829100001 | |||||||||
| HARRISON, Albert Malcolm | Amministratore | Rosecot Coton Road Nether Whitacre Coleshill B46 2EY Birmingham | British | 60272090001 | ||||||||||
| JOHNSON, David Brown Eunson | Amministratore | 7 Warnington Drive Bessacarr DN4 6SJ Doncaster South Yorkshire | United Kingdom | British | 2906120001 | |||||||||
| KAY, Ian Andrew | Amministratore | 17 Jenner Street Seaforth New South Wales 2092 Australia | British | 102259090001 | ||||||||||
| MCDONALD, David Andrew | Amministratore | Cherith Church Lane Chew Stoke BS40 8TU Bristol Avon | England | British | 67201010001 | |||||||||
| MUIR, David Scott | Amministratore | 29 Fieldgate Lane CV8 1BT Kenilworth Warwickshire | Uk | British | 21883690003 | |||||||||
| ODAM, Joseph | Amministratore | Haynes Farm Thorney Road Eye PE6 7UA Peterborough Cambridgeshire | British | 2419000001 | ||||||||||
| ODAM, Joseph | Amministratore | Haynes Farm Thorney Road Eye PE6 7UA Peterborough Cambridgeshire | British | 2419000001 | ||||||||||
| OWENS, David William | Amministratore | The Garden House Marlow Bridge Lane SL7 1RH Marlow Buckinghamshire | England | British | 110731260001 | |||||||||
| ROWLANDS, John Lewis | Amministratore | The Elms Lucas Lane Ashwell SG7 5LN Baldock Hertfordshire | United Kingdom | British | 2950030001 | |||||||||
| SENIOR, Timothy James, Dr | Amministratore | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | England | British | 244462470001 | |||||||||
| SKERTCHLY, Paul Clifford | Amministratore | Dormer Cottage Hardwick Close Knott Park KT22 0HZ Oxshott Surrey | England | British | 82622600002 | |||||||||
| STANLEY, Martin Stephen William | Amministratore | IP12 | United Kingdom | British | 67692310003 | |||||||||
| STANLEY, Martin Stephen William | Amministratore | IP12 | United Kingdom | British | 67692310003 | |||||||||
| TAYLOR, Philip Jonathan | Amministratore | Halfway Foley Terrace WR14 4RQ Malvern Worcestershire | United Kingdom | British | 33556640001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ANGLIAN STRAW LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epr Ely Limited | 06 apr 2016 | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ANGLIAN STRAW LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 09 set 1998 Consegnato il 29 set 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0