THE TABLEY HOUSE COLLECTION TRUST
Panoramica
Nome della società | THE TABLEY HOUSE COLLECTION TRUST |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale, esenzione dall'uso di 'Limited' |
Numero di società | 02502359 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | No |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE TABLEY HOUSE COLLECTION TRUST?
- Gestione di siti e edifici storici e di attrazioni turistiche simili (91030) / Attività artistiche, sportive e di divertimento
Dove si trova THE TABLEY HOUSE COLLECTION TRUST?
Indirizzo della sede legale | The University Of Manchester G.005 John Owens Building Oxford Road M13 9PL Manchester England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE TABLEY HOUSE COLLECTION TRUST?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 ott 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 lug 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 ott 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per THE TABLEY HOUSE COLLECTION TRUST?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 15 mag 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 29 mag 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 15 mag 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per THE TABLEY HOUSE COLLECTION TRUST?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Bilancio di micro-entità redatto al 31 ott 2023 | 3 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2022 | 11 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di James Andrew Hopkins come amministratore in data 31 lug 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 ott 2021 | 3 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Ms Margaret Anne Bradbury come amministratore in data 12 nov 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2020 | 11 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2019 | 9 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Kathryn Jane Harrison come amministratore in data 22 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2018 | 9 pagine | AA | ||
Nomina di Doctor James Andrew Hopkins come amministratore in data 01 nov 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O the University of Manchester G.010 John Owens Building Oxford Road Manchester M13 9PL England a The University of Manchester G.005 John Owens Building Oxford Road Manchester M13 9PL in data 06 giu 2019 | 1 pagine | AD01 | ||
Cessazione della carica di Kieth Bradley come amministratore in data 01 nov 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2017 | 9 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2016 | 8 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2015 | 9 pagine | AA | ||
Bilancio annuale redatto al 15 mag 2016, non è stata fornita alcuna lista dei soci | 6 pagine | AR01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mary Clare Pye il 19 mag 2016 | 2 pagine | CH01 | ||
Chi sono gli amministratori di THE TABLEY HOUSE COLLECTION TRUST?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISSELL, Louise Virginia Anne | Segretario | G.005 John Owens Building Oxford Road M13 9PL Manchester The University Of Manchester England | British | 132663530001 | ||||||
BRADBURY, Margaret Anne | Amministratore | G.005 John Owens Building Oxford Road M13 9PL Manchester The University Of Manchester England | England | British | Director | 151014670001 | ||||
COOPER, Carole Hazel | Amministratore | G.005 John Owens Building Oxford Road M13 9PL Manchester The University Of Manchester England | United Kingdom | British | Administrator | 101112290001 | ||||
LYNSKEY, Karen | Amministratore | Nursing Home Tabley Lane, Chester Road Tabley WA16 0HB Knutsford Tabley House Cheshire | United Kingdom | British | Matron | 140762280001 | ||||
PYE, Mary Clare | Amministratore | G.005 John Owens Building Oxford Road M13 9PL Manchester The University Of Manchester England | United Kingdom | British | Teacher | 42452210001 | ||||
TETLOW, Christopher Bruce | Amministratore | G.005 John Owens Building Oxford Road M13 9PL Manchester The University Of Manchester England | England | British | Retired | 35398400001 | ||||
WEBB, Sarah | Amministratore | G.005 John Owens Building Oxford Road M13 9PL Manchester The University Of Manchester England | United Kingdom | British | Administrator | 140709700001 | ||||
HARRISON, Kathryn Jane | Segretario | Lomax Wifes Farm Coal Pit Road Smithills BL1 7PA Bolton | British | 60901700005 | ||||||
BECK, Edward Oliver John | Amministratore | Chester Road Tabley WA16 0HF Knutsford Tabley Grange Cheshire | Uk | British | Chartered Surveyor | 193323630001 | ||||
BECK, Edward Oliver John | Amministratore | Tabley Grange Nether Tabley WA16 0HF Knutsford Cheshire | Uk | British | Chartered Surveyor | 193323630001 | ||||
BRADLEY, Kieth, Lord | Amministratore | c/o The University Of Manchester Oxford Road M13 9PL Manchester G.010 John Owens Building England | United Kingdom | British | Member Of The House Of Lords | 150690940001 | ||||
BRIERLEY, Ronald | Amministratore | 52 Trafford Road SK9 7DN Alderley Edge Cheshire | British | Company Director | 9599180001 | |||||
CHALMERS, Jean Pringle | Amministratore | 72 Hill Top Avenue Cheadle Hulme SK8 7JA Cheadle Cheshire | United Kingdom | British | General Manager Nursing Home | 20753650002 | ||||
CLAXTON, David John | Amministratore | 38 Elmsleigh Road Heald Green SK8 3UE Cheadle Cheshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 22953290002 | ||||
COX, Charles Brian, Professor | Amministratore | 20 Park Gates Drive Cheadle Hulme SK8 7DF Cheadle Cheshire | British | University Professor | 9599190001 | |||||
DAVIES, Rhys, Judge Sir | Amministratore | 6 Rushton Street M20 6RP Manchester Lancashire | British | Judge | 67033730001 | |||||
GASKELL, Simon James, Professor | Amministratore | 10 Park Road Hale WA15 9NJ Altrincham Cheshire | British | Vice-President | 88390770001 | |||||
GORDON, David, Professor | Amministratore | Chisholm Building Brunswick Street M13 9PL Manchester | British | University Vice President | 84757150002 | |||||
HADFIELD, Iris | Amministratore | Fairfield House Dale Brow SK10 4BH Prestbury Cheshire | English | 25932320001 | ||||||
HARRISON, Kathryn Jane | Amministratore | G.005 John Owens Building Oxford Road M13 9PL Manchester The University Of Manchester England | England | British | Adminstrator | 152021820001 | ||||
HOPKINS, James Andrew, Doctor | Amministratore | G.005 John Owens Building Oxford Road M13 9PL Manchester The University Of Manchester England | England | British | University Historian & Head Of Heritage | 259288150001 | ||||
HUGHES, John Craig | Amministratore | Lansdowne Crescent W11 2NT London 41a | United Kingdom | Us | Company Director | 84916320001 | ||||
MCKEOWN, Stephen Patrick | Amministratore | 46 Carrwood Road SK9 5DN Wilmslow Cheshire | England | British | Consultant Psychiatrist | 87519910001 | ||||
MCLEOD, Donald Reginald | Amministratore | Oaklands Colshaw Lane SK11 9LZ Siddington Cheshire | Great Britain | British | Company Director | 9599220002 | ||||
MORGAN, Valerie Elsie | Amministratore | Warren Wood Lower Kinnerton CH4 9AE Chester Cheshire | British | Matron | 42569560001 | |||||
PAYNE, Nicholas Milne | Amministratore | The Mount Whirley SK11 9BP Macclesfield Cheshire | Great Britain | British | Company Director | 43038180001 | ||||
ROBERTS, Garth Henry | Amministratore | 15 Pine Road M20 6UY Manchester Lancashire | British | Retired | 29788820001 | |||||
SLADE, Derek Harrison | Amministratore | Whitestone 32 Ramillies Avenue Cheadle Hulme SK8 7AL Cheadle Cheshire | British | Retired | 30303860001 | |||||
WELLAND, Dennis Sydney Reginald, Emeritus Professor | Amministratore | The White Cottage 188 Longhurst Lane Mellor SK6 5PN Stockport Cheshire | British | Professor (Retired) | 22938340001 | |||||
WILSON, Kenneth Adrian Raymond | Amministratore | 179 Kings Road KT2 5JH Kingston Upon Thames Surrey | England | British | Company Director | 51898330001 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per THE TABLEY HOUSE COLLECTION TRUST?
Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
---|---|---|
15 mag 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0