EMAP INSIGHT LIMITED
Panoramica
| Nome della società | EMAP INSIGHT LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02502812 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EMAP INSIGHT LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova EMAP INSIGHT LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Greater London House Hampstead Road NW1 7EJ London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EMAP INSIGHT LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| EMAP DORMANT 3 LIMITED | 09 dic 2005 | 09 dic 2005 |
| MIXMAG LIMITED | 09 dic 1996 | 09 dic 1996 |
| D M C PUBLISHING LIMITED | 17 mag 1990 | 17 mag 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EMAP INSIGHT LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per EMAP INSIGHT LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessazione della carica di Emily Henrietta Gestetner come amministratore in data 29 giu 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di John Keith Gulliver come amministratore in data 11 giu 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Duncan Anthony Painter il 02 apr 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Duncan Anthony Painter come amministratore in data 22 dic 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Martyn John Hindley come amministratore in data 22 dic 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Taylor come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 30 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Martyn John Hindley il 30 set 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ms Shanny Looi il 01 mar 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Martyn John Hindley il 01 mar 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Emily Henrietta Gestetner il 01 mar 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Christopher Nigel John Taylor il 01 mar 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Helen Frances Hay come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Helen Frances Hay come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 225 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di EMAP INSIGHT LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOI, Shanny | Segretario | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House | British | 129906110001 | ||||||
| GULLIVER, John Keith | Amministratore | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House | United Kingdom | British | 170112360001 | |||||
| PAINTER, Duncan Anthony | Amministratore | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House | England | British | 132649960001 | |||||
| ANDERS, Philip William | Segretario | 5 Fitzwilliams Court Greatford PE9 4QQ Stamford Lincolnshire | British | 42645630003 | ||||||
| ELSDON, Kate | Segretario | 51 Sackville Crescent Harold Wood RM3 0EH Romford Essex | British | 107227940002 | ||||||
| GILES, Nicholas David Martin | Segretario | 8 Pyms Gardens Abbotsley PE19 6UR St Neots Cambs | British | 85529870001 | ||||||
| HAY, Helen Frances | Segretario | MK43 7BB Odell The Old Stable Yard Beds | 146425680001 | |||||||
| HENSON, Mark Richard | Segretario | 5 Hazeland Steading PE10 0PW Morton Lincolnshire | British | 104630800001 | ||||||
| HOGG, Marianne Lisa | Segretario | 43b Norroy Road Putney SW15 1PQ London | British | 101383970001 | ||||||
| LEES, Barbara | Segretario | Milford Street CB1 2LP Cambridge 15a Cambridgeshire | Other | 79614280001 | ||||||
| NAREBOR, Torugbene Eniyekeye | Segretario | 10 Portland Road ME7 2NP Gillingham Kent | British | 120147010002 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Segretario | Sennen Grange Road MK43 7EU Felmersham North Bedfordshire | British | 16754910001 | ||||||
| WHITEHEAD, Christine | Segretario | Cut Heath House Parsonage Lane SL2 3PA Farnham Common Buckinghamshire | British | 3277810003 | ||||||
| ANDERS, Philip William | Amministratore | 5 Fitzwilliams Court Greatford PE9 4QQ Stamford Lincolnshire | England | British | 42645630003 | |||||
| BHAKTA-JONES, Nilema | Amministratore | 7b Wolseley Road N8 8RR London | United Kingdom | British | 124888590001 | |||||
| COLE, Christopher Michael | Amministratore | Lucas Avenue HA2 9JU Harrow 30 Middlesex England | United Kingdom | British | 133510510001 | |||||
| ELSDON, Kate | Amministratore | 51 Sackville Crescent Harold Wood RM3 0EH Romford Essex | British | 107227940002 | ||||||
| FOLLAND, Nicholas James | Amministratore | Strethall House Strethall CB11 4XJ Saffron Walden Essex | United Kingdom | British | 73711450003 | |||||
| GESTETNER, Emily Henrietta | Amministratore | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House | United Kingdom | British | 138386390001 | |||||
| GILES, Nicholas David Martin | Amministratore | 8 Pyms Gardens Abbotsley PE19 6UR St Neots Cambs | British | 85529870001 | ||||||
| HENSON, Mark Richard | Amministratore | 5 Hazeland Steading PE10 0PW Morton Lincolnshire | United Kingdom | British | 104630800001 | |||||
| HINDLEY, Martyn John | Amministratore | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House | England | British | 134332760002 | |||||
| HOGG, Marianne Lisa | Amministratore | 15 Roskell Road SW15 1DS London | British | 101383970002 | ||||||
| LAVELLI, John Stephen | Amministratore | 2 Nathans Close AL6 9QB Welwyn Hertfordshire | British | 56438160001 | ||||||
| MOLONEY, Thomas Charles | Amministratore | 20 Queen Elizabeths Walk N16 0HX London | United Kingdom | British | 15672060004 | |||||
| NAREBOR, Torugbene Eniyekeye | Amministratore | 10 Portland Road ME7 2NP Gillingham Kent | British | 120147010002 | ||||||
| PHILLIPS, Alison Barbara | Amministratore | The Gatehouse 1 Rhymers Gate Wyton PE17 2JR Huntingdon | Uk | British | 61837750001 | |||||
| TAYLOR, Christopher Nigel John | Amministratore | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House | British | 130943020001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Amministratore | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | England | British | 135181230001 | |||||
| WHITEHEAD, Christine | Amministratore | Cut Heath House Parsonage Lane SL2 3PA Farnham Common Buckinghamshire | British | 3277810003 | ||||||
| WHITEHOUSE, Thomas Richard | Amministratore | Cut Heath House Parsonage Lane Farnham Common SL2 3PA Slough Buckinghamshire | British | 58982570001 |
EMAP INSIGHT LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit agreement | Creato il 19 dic 1994 Consegnato il 06 gen 1995 | In corso | Importo garantito The payment of the rents and other sums reserved by and the performance and observance of the company's obligations to the lessor in the underlease of even date | |
Brevi particolari The credit balance on the company's deposit account at midland bank PLC at 2 craven road paddington london W2 including all monies paid into the account in accordance with the agreement dated 19 december 1994. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 18 giu 1991 Consegnato il 24 giu 1991 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0