WOOLLEY GRANGE LIMITED

WOOLLEY GRANGE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWOOLLEY GRANGE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02503442
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WOOLLEY GRANGE LIMITED?

    • (5510) /

    Dove si trova WOOLLEY GRANGE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Von Essen House Roman Way
    Bath Business Park, Peasedown St. John
    BA2 8SG Bath
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di WOOLLEY GRANGE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per WOOLLEY GRANGE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Nomina di Blakelaw Secretaries Limited come segretario

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Gd Secretarial Services Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da 6th Floor 90 Fetter Lane London EC4A 1PT in data 08 lug 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 18 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 giu 2011

    Stato del capitale al 23 giu 2011

    • Capitale: GBP 22,661.72
    SH01

    Nomina di David Duggins come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Davis come amministratore

    2 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    8 pagineAA

    Stato del capitale al 06 ago 2010

    • Capitale: GBP 22,661.72
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12

    Bilancio annuale redatto al 18 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Gd Secretarial Services Limited il 18 mag 2010

    2 pagineCH04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    3 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di WOOLLEY GRANGE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BLAKELAW SECRETARIES LIMITED
    Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Harbour Court
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Harbour Court
    Hampshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1914417
    38915800008
    DUGGINS, David
    Roman Way
    Bath Business Park Peasedown St John
    BA2 8SG Bath
    Von Essen House
    Amministratore
    Roman Way
    Bath Business Park Peasedown St John
    BA2 8SG Bath
    Von Essen House
    United KingdomBritish160494140001
    CHAPMAN, Nigel Peter
    Fairfields
    Murrells End Hartpury
    GL19 3DF Gloucester
    Gloucestershire
    Segretario
    Fairfields
    Murrells End Hartpury
    GL19 3DF Gloucester
    Gloucestershire
    British65368830001
    NARES, Anthony James Brewis
    Blakeford House Broad Street
    Kings Stanley
    GL10 3PN Stonehouse
    Gloucestershire
    Segretario
    Blakeford House Broad Street
    Kings Stanley
    GL10 3PN Stonehouse
    Gloucestershire
    British9038030001
    GD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Goodman Derrick
    90 Fetter Lane
    EC4A 1PT London
    Sixth Floor
    Segretario
    Goodman Derrick
    90 Fetter Lane
    EC4A 1PT London
    Sixth Floor
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02471626
    66216820001
    BANTOFT, Stephen Edward
    West Wing 1
    Stoneleigh Abbey
    CV8 2LF Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    West Wing 1
    Stoneleigh Abbey
    CV8 2LF Kenilworth
    Warwickshire
    British77913960001
    CHAPMAN, Heather Elizabeth Lindsay
    Fairfields
    Murrells End, Hartpury
    GL19 3DF Gloucester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Fairfields
    Murrells End, Hartpury
    GL19 3DF Gloucester
    Gloucestershire
    British25825840002
    CHAPMAN, Nigel Peter
    Fairfields
    Murrells End Hartpury
    GL19 3DF Gloucester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Fairfields
    Murrells End Hartpury
    GL19 3DF Gloucester
    Gloucestershire
    British65368830001
    CLARK, Paul Andrew
    Villa Marina
    12 Sea Front Road
    PE25 3BQ Skegness
    Lincolnshire
    Amministratore
    Villa Marina
    12 Sea Front Road
    PE25 3BQ Skegness
    Lincolnshire
    British81036490001
    DAVIS, Andrew
    Henlade House
    Henlade
    TA3 5NB Taunton
    Somerset
    Amministratore
    Henlade House
    Henlade
    TA3 5NB Taunton
    Somerset
    United KingdomBritish77124350001
    DICKINSON, William Nicholas
    Friday House
    Friday Street
    GL2 7JP Arlingham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Friday House
    Friday Street
    GL2 7JP Arlingham
    Gloucestershire
    British37024940003
    EDWARDS, John Selous Llewellyn
    50 Muswell Hill Road
    N10 3JR London
    Amministratore
    50 Muswell Hill Road
    N10 3JR London
    British4342980001
    GALLOP, Ruth Sarah
    4 Park Terrace
    High Street
    SG10 6BT Much Hadham
    Herts
    Amministratore
    4 Park Terrace
    High Street
    SG10 6BT Much Hadham
    Herts
    British99901410002
    HEARTON-GEE, Frank Watts
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Henley On Thames
    Oxfordshire
    British80992640001
    KEARTON GEE, Frank Watts
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    EnglandBritish16914130001
    NARES, Anthony James Brewis
    Blakeford House Broad Street
    Kings Stanley
    GL10 3PN Stonehouse
    Gloucestershire
    Amministratore
    Blakeford House Broad Street
    Kings Stanley
    GL10 3PN Stonehouse
    Gloucestershire
    EnglandBritish9038030001
    NEWLING WARD, David Patrick
    The Old Rectory
    Bix
    RG9 6BP Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Bix
    RG9 6BP Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    British37025130001
    RUSSELL, William Anthony Bowater
    50 The Burying Hill Road
    Greenwich Connecticut 06831
    FOREIGN Usa
    Amministratore
    50 The Burying Hill Road
    Greenwich Connecticut 06831
    FOREIGN Usa
    British35223330002

    WOOLLEY GRANGE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 11 ago 2006
    Consegnato il 18 ago 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and by each other chargor and each other person named as group company to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 18 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 14 giu 2006
    Consegnato il 17 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 17 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 ott 2003
    Consegnato il 15 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or luxury family hotels three PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 ott 2003
    Consegnato il 15 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or luxury family hotels three PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Woolley grange hotel, bradford on avon,wiltshire, t/n WT69859.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 03 lug 2003
    Consegnato il 17 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or luxury family hotels three PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 apr 2002
    Consegnato il 24 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or lhm PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold land and premises k/a woolley grange hotel woolley green bradford on avon t/n WT69859.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 gen 1997
    Consegnato il 05 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a trust deed dated 16 january 1997
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • John Selous Llewellyn Edwards(The Trustees (as Defined))
    • Frank Watts Kearton Gee
    Transazioni
    • 05 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 gen 1997
    Consegnato il 27 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Woolley grange bradford-on-avon wiltshire t/no;-WT69859.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 17 gen 1997
    Consegnato il 22 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    Brevi particolari
    Woolley grange hotel woolley green bradford-on-avon wiltshire t/no wt 69859. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Assurance PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 set 1991
    Consegnato il 02 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 30 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 mar 1991
    Consegnato il 11 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Woolley grange hotel, woolley green bradford-on-avon, wiltshire t/n 69859.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 30 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenant and debenture
    Creato il 08 feb 1991
    Consegnato il 01 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £400,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a deed of legal charge dated 16/2/90 and this charge.
    Brevi particolari
    All the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Wimbledon & South West Finance PLC
    Transazioni
    • 01 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0