NSIP (ETS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNSIP (ETS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02504173
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NSIP (ETS) LIMITED?

    • Attività di supporto per l'estrazione di petrolio e gas naturale (09100) / Attività estrattive

    Dove si trova NSIP (ETS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Suite 1, 3rd Floor 11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NSIP (ETS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CH4 PIPELINES LIMITED28 lug 200328 lug 2003
    CALENERGY GAS (PIPELINES) LIMITED08 dic 199708 dic 1997
    POWER TOWER LIMITED06 lug 199006 lug 1990
    HASTESPOT LIMITED21 mag 199021 mag 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di NSIP (ETS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per NSIP (ETS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Thomas Jack Robert Luypaert il 08 giu 2020

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Thomas Jack Robert Luypaert il 30 gen 2020

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Kellas North Sea 2 Limited come persona con controllo significativo il 30 gen 2020

    2 paginePSC05

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew David Hessell il 30 gen 2020

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Guy Robert Maurice Appleton il 30 gen 2020

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 14 st. George Street London W1S 1FE United Kingdom a Suite 1, 3rd Floor 11-12 st James's Square London SW1Y 4LB in data 04 feb 2020

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Thomas Jack Robert Luypaert come amministratore in data 30 gen 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Guillaume Jacques Robert Friedel come amministratore in data 30 gen 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephane Julien Ifker come amministratore in data 30 gen 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark John Crosbie come amministratore in data 30 gen 2020

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Guillaume Jacques Robert Friedel il 01 ago 2019

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Antin North Sea 2 Limited come persona con controllo significativo il 16 set 2019

    2 paginePSC05

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    24 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 025041730011 in pieno

    4 pagineMR04

    Seconda presentazione per la nomina di Mr Mark John Crosbie come amministratore

    6 pagineRP04AP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Guillaume Jacques Robert Friedel il 20 giu 2018

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    25 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 14 st George Street London London W1S 1FE a 14 st. George Street London W1S 1FE in data 05 lug 2018

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Antin North Sea 2 Limited come persona con controllo significativo il 15 feb 2018

    2 paginePSC05

    Chi sono gli amministratori di NSIP (ETS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    APPLETON, Guy Robert Maurice
    7th Floor, The Silver Fin Building
    455 Union Street
    AB11 6DB Aberdeen
    Kellas Midstream Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    7th Floor, The Silver Fin Building
    455 Union Street
    AB11 6DB Aberdeen
    Kellas Midstream Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish156848840001
    HESSELL, Andrew David
    7th Floor, The Silver Fin Building
    455 Union Street
    AB11 6DB Aberdeen
    Kellas Midstream Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    7th Floor, The Silver Fin Building
    455 Union Street
    AB11 6DB Aberdeen
    Kellas Midstream Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish221140270001
    LUYPAERT, Thomas Jack Robert
    Throgmorton Avenue
    EC2N 2DL London
    12
    United Kingdom
    Amministratore
    Throgmorton Avenue
    EC2N 2DL London
    12
    United Kingdom
    United KingdomFrench264133230002
    GILES, Gail Valerie
    North Sundaysight
    Bellingham
    NE48 2JE Hexham
    Northumberland
    Segretario
    North Sundaysight
    Bellingham
    NE48 2JE Hexham
    Northumberland
    British108926390001
    HOBDEN, Brian
    40 Woodburn Crescent
    AB15 8JX Aberdeen
    Segretario
    40 Woodburn Crescent
    AB15 8JX Aberdeen
    British81368370001
    KIRK, Philip Andrew
    5 Old Deer Park Gardens
    TW9 2TN Richmond
    Surrey
    Segretario
    5 Old Deer Park Gardens
    TW9 2TN Richmond
    Surrey
    British84103730001
    MISTRY, Bhavna
    37 Warren Road
    Whitton
    TW2 7DH Twickenham
    Middlesex
    Segretario
    37 Warren Road
    Whitton
    TW2 7DH Twickenham
    Middlesex
    British87625170001
    SPARKES, Michael Jack
    The Pantiles Main Street
    Thorney
    NG23 7BS Newark
    Nottinghamshire
    Segretario
    The Pantiles Main Street
    Thorney
    NG23 7BS Newark
    Nottinghamshire
    British43902400001
    WAITE, Simon Nicholas
    2 Chestnut Lane
    AB31 5PH Banchory
    Aberdeenshire
    Segretario
    2 Chestnut Lane
    AB31 5PH Banchory
    Aberdeenshire
    British117008750002
    CENTRICA SECRETARIES LIMITED
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Segretario
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4049225
    146095800001
    WEIL, GOTSHAL & MANGES (LONDON) LLP
    Fetter Lane
    EC4A 1AY London
    110
    United Kingdom
    Segretario
    Fetter Lane
    EC4A 1AY London
    110
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneOC400678
    199087250001
    ABEL, Gregory Edward
    4710 George Mills Parkway 402
    50265 West Des Moines
    Iowa
    United States
    Amministratore
    4710 George Mills Parkway 402
    50265 West Des Moines
    Iowa
    United States
    UsaCanadian52806480009
    BEGBIE, Roderick Mcintosh
    11 Kepplestone Gardens
    AB15 4DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    11 Kepplestone Gardens
    AB15 4DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    British115205850001
    BRICKNELL, Bruce David Neil
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish184345640001
    CLAYTON, Marie-Louise
    309 North Deeside Road
    AB13 0DL Aberdeen
    Amministratore
    309 North Deeside Road
    AB13 0DL Aberdeen
    British103782580001
    CONNOR, Phillip Eric
    Billy Hill House
    Stanley
    DL15 9QS Crook
    County Durham
    Amministratore
    Billy Hill House
    Stanley
    DL15 9QS Crook
    County Durham
    EnglandEnglish72946860001
    CROSBIE, Mark John
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    Amministratore
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    United KingdomBritish211079810001
    DAVIES, John George
    Cotchet Barn Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Cotchet Barn Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    British54724650001
    DIXON, Ronald
    1 Berkley Avenue
    NE21 5NN Blaydon
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Berkley Avenue
    NE21 5NN Blaydon
    Tyne & Wear
    EnglandBritish2318270001
    FRIEDEL, Guillaume Jacques Robert
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    Amministratore
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    United StatesFrench189459340023
    GILES, Gail Valerie
    North Sundaysight
    Bellingham
    NE48 2JE Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    North Sundaysight
    Bellingham
    NE48 2JE Hexham
    Northumberland
    EnglandBritish108926390001
    GROVES, Alan
    37 Avondale Road
    Ponteland
    NE20 9NA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    37 Avondale Road
    Ponteland
    NE20 9NA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British2318230001
    GUGEN, Francis Robert
    Down Street
    W1J 7AJ London
    7
    Amministratore
    Down Street
    W1J 7AJ London
    7
    United KingdomBritish388450006
    HANAFIN, Vincent Mark
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Amministratore
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United KingdomBritish131999620002
    IFKER, Stephane Julien
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    Amministratore
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    FranceFrench229631470001
    KIRK, Philip Andrew
    5 Old Deer Park Gardens
    TW9 2TN Richmond
    Surrey
    Amministratore
    5 Old Deer Park Gardens
    TW9 2TN Richmond
    Surrey
    British84103730001
    LE POIDEVIN, Andrew Daryl
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Amministratore
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    EnglandBritish4958800007
    LINGE, Kenneth
    Drystones Heugh House Lane
    NE47 6ND Haydon Bridge
    Northumberland
    Amministratore
    Drystones Heugh House Lane
    NE47 6ND Haydon Bridge
    Northumberland
    EnglandBritish52698930001
    LUMSDEN, Roy Andrew
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Amministratore
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United KingdomBritish199053700001
    MORRIS, David Richard
    Churchfield 1 Top Street
    Wing
    LE15 8SE Oakham
    Leicestershire
    Amministratore
    Churchfield 1 Top Street
    Wing
    LE15 8SE Oakham
    Leicestershire
    United KingdomBritish36692700001
    MURPHY, Jonathan David
    74 Beaconsfield Place
    AB15 4AJ Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    74 Beaconsfield Place
    AB15 4AJ Aberdeen
    Aberdeenshire
    British115205970001
    OZSANLAV, Richard
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish147826530002
    PICOTTE, Christopher
    200 Clarendon Street 55th Floor
    MA 02117 Boston
    Arclight Capital Partners Llc
    Usa
    Amministratore
    200 Clarendon Street 55th Floor
    MA 02117 Boston
    Arclight Capital Partners Llc
    Usa
    American116230600001
    ROGER, Jonathan Leslie
    AB15
    Amministratore
    AB15
    United KingdomBritish124423900001
    ROGER, Jonathan Leslie
    AB15
    Amministratore
    AB15
    United KingdomBritish124423900001

    Chi sono le persone con controllo significativo di NSIP (ETS) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    Suite 1, 3rd Floor
    United Kingdom
    21 dic 2017
    11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    Suite 1, 3rd Floor
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione10778448
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3186121
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    NSIP (ETS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 26 mar 2018
    Consegnato il 26 mar 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbc Europe Limited
    Transazioni
    • 26 mar 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 24 gen 2007
    Consegnato il 31 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the chargor's rights to and title and interest from time to time in the whole of its property,assets,rights and revenues,whatsoever and wheresoever,present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 31 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Bond and floating charge
    Creato il 22 gen 2007
    Consegnato il 31 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge over the assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 31 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 21 lug 2006
    Consegnato il 28 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's rights to and title and interest from time to time in the relevant project accounts, all account proceeds, by way of first floating charge all the company's rights to and title and interest from time to time in the whole of its property, assets, rights and revenues. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V. (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 28 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third supplemental deed of amendment to a note purchase agreement dated 23 december 2003 and
    Creato il 27 gen 2006
    Consegnato il 09 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the senior finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    If any borrower or the issuer makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of all or any part of the junior liabilities or the subordianted liabilies or the junior lender or any subordianted lender recieves all or any amount in cash, the junior lender will hold any amount so received on trust for the collateral agent,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag (The Collateral Agent)
    Transazioni
    • 09 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First supplemental deed of amendment to a guarantee and debenture dated 23 december 2003 and
    Creato il 27 gen 2006
    Consegnato il 09 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or CH4 energy limited to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag (The Collateral Agent)
    Transazioni
    • 09 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second supplemental deed of amendment dated 23 december 2005
    Creato il 23 dic 2005
    Consegnato il 10 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the parent or the company to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag (The Collateral Agent)
    Transazioni
    • 10 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 23 dic 2003
    Consegnato il 13 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the parent or the company to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag
    Transazioni
    • 13 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 ago 2003
    Consegnato il 04 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 04 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 01 lug 1999
    Consegnato il 14 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each borrower (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document to which such borrower is a party
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 giu 1998
    Consegnato il 22 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each borrower (as defined) to the chargee as agent and trustee for each finance party (as defined) under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all its respective present and future right and title to and interest in the charged assets by way of first floating charge all its assets and undertaking whatsoever and wheresoever both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0