NSIP (ETS) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | NSIP (ETS) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02504173 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NSIP (ETS) LIMITED?
- Attività di supporto per l'estrazione di petrolio e gas naturale (09100) / Attività estrattive
Dove si trova NSIP (ETS) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Suite 1, 3rd Floor 11-12 St James's Square SW1Y 4LB London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di NSIP (ETS) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CH4 PIPELINES LIMITED | 28 lug 2003 | 28 lug 2003 |
| CALENERGY GAS (PIPELINES) LIMITED | 08 dic 1997 | 08 dic 1997 |
| POWER TOWER LIMITED | 06 lug 1990 | 06 lug 1990 |
| HASTESPOT LIMITED | 21 mag 1990 | 21 mag 1990 |
Quali sono gli ultimi bilanci di NSIP (ETS) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per NSIP (ETS) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Thomas Jack Robert Luypaert il 08 giu 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Thomas Jack Robert Luypaert il 30 gen 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Modifica dei dettagli di Kellas North Sea 2 Limited come persona con controllo significativo il 30 gen 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew David Hessell il 30 gen 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Guy Robert Maurice Appleton il 30 gen 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 14 st. George Street London W1S 1FE United Kingdom a Suite 1, 3rd Floor 11-12 st James's Square London SW1Y 4LB in data 04 feb 2020 | 1 pagine | AD01 | ||
Nomina di Mr Thomas Jack Robert Luypaert come amministratore in data 30 gen 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Guillaume Jacques Robert Friedel come amministratore in data 30 gen 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Stephane Julien Ifker come amministratore in data 30 gen 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Mark John Crosbie come amministratore in data 30 gen 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Guillaume Jacques Robert Friedel il 01 ago 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Modifica dei dettagli di Antin North Sea 2 Limited come persona con controllo significativo il 16 set 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 24 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Soddisfazione dell'onere 025041730011 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Seconda presentazione per la nomina di Mr Mark John Crosbie come amministratore | 6 pagine | RP04AP01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Guillaume Jacques Robert Friedel il 20 giu 2018 | 2 pagine | CH01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 25 pagine | AA | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 14 st George Street London London W1S 1FE a 14 st. George Street London W1S 1FE in data 05 lug 2018 | 1 pagine | AD01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Modifica dei dettagli di Antin North Sea 2 Limited come persona con controllo significativo il 15 feb 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||
Chi sono gli amministratori di NSIP (ETS) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLETON, Guy Robert Maurice | Amministratore | 7th Floor, The Silver Fin Building 455 Union Street AB11 6DB Aberdeen Kellas Midstream Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 156848840001 | |||||||||
| HESSELL, Andrew David | Amministratore | 7th Floor, The Silver Fin Building 455 Union Street AB11 6DB Aberdeen Kellas Midstream Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 221140270001 | |||||||||
| LUYPAERT, Thomas Jack Robert | Amministratore | Throgmorton Avenue EC2N 2DL London 12 United Kingdom | United Kingdom | French | 264133230002 | |||||||||
| GILES, Gail Valerie | Segretario | North Sundaysight Bellingham NE48 2JE Hexham Northumberland | British | 108926390001 | ||||||||||
| HOBDEN, Brian | Segretario | 40 Woodburn Crescent AB15 8JX Aberdeen | British | 81368370001 | ||||||||||
| KIRK, Philip Andrew | Segretario | 5 Old Deer Park Gardens TW9 2TN Richmond Surrey | British | 84103730001 | ||||||||||
| MISTRY, Bhavna | Segretario | 37 Warren Road Whitton TW2 7DH Twickenham Middlesex | British | 87625170001 | ||||||||||
| SPARKES, Michael Jack | Segretario | The Pantiles Main Street Thorney NG23 7BS Newark Nottinghamshire | British | 43902400001 | ||||||||||
| WAITE, Simon Nicholas | Segretario | 2 Chestnut Lane AB31 5PH Banchory Aberdeenshire | British | 117008750002 | ||||||||||
| CENTRICA SECRETARIES LIMITED | Segretario | Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Millstream Berkshire |
| 146095800001 | ||||||||||
| WEIL, GOTSHAL & MANGES (LONDON) LLP | Segretario | Fetter Lane EC4A 1AY London 110 United Kingdom |
| 199087250001 | ||||||||||
| ABEL, Gregory Edward | Amministratore | 4710 George Mills Parkway 402 50265 West Des Moines Iowa United States | Usa | Canadian | 52806480009 | |||||||||
| BEGBIE, Roderick Mcintosh | Amministratore | 11 Kepplestone Gardens AB15 4DH Aberdeen Aberdeenshire | British | 115205850001 | ||||||||||
| BRICKNELL, Bruce David Neil | Amministratore | Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Millstream Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 184345640001 | |||||||||
| CLAYTON, Marie-Louise | Amministratore | 309 North Deeside Road AB13 0DL Aberdeen | British | 103782580001 | ||||||||||
| CONNOR, Phillip Eric | Amministratore | Billy Hill House Stanley DL15 9QS Crook County Durham | England | English | 72946860001 | |||||||||
| CROSBIE, Mark John | Amministratore | St. George Street W1S 1FE London 14 United Kingdom | United Kingdom | British | 211079810001 | |||||||||
| DAVIES, John George | Amministratore | Cotchet Barn Blackdown GU27 3BS Haslemere Surrey | British | 54724650001 | ||||||||||
| DIXON, Ronald | Amministratore | 1 Berkley Avenue NE21 5NN Blaydon Tyne & Wear | England | British | 2318270001 | |||||||||
| FRIEDEL, Guillaume Jacques Robert | Amministratore | St. George Street W1S 1FE London 14 United Kingdom | United States | French | 189459340023 | |||||||||
| GILES, Gail Valerie | Amministratore | North Sundaysight Bellingham NE48 2JE Hexham Northumberland | England | British | 108926390001 | |||||||||
| GROVES, Alan | Amministratore | 37 Avondale Road Ponteland NE20 9NA Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 2318230001 | ||||||||||
| GUGEN, Francis Robert | Amministratore | Down Street W1J 7AJ London 7 | United Kingdom | British | 388450006 | |||||||||
| HANAFIN, Vincent Mark | Amministratore | Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Millstream Berkshire | United Kingdom | British | 131999620002 | |||||||||
| IFKER, Stephane Julien | Amministratore | St. George Street W1S 1FE London 14 United Kingdom | France | French | 229631470001 | |||||||||
| KIRK, Philip Andrew | Amministratore | 5 Old Deer Park Gardens TW9 2TN Richmond Surrey | British | 84103730001 | ||||||||||
| LE POIDEVIN, Andrew Daryl | Amministratore | Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Millstream Berkshire | England | British | 4958800007 | |||||||||
| LINGE, Kenneth | Amministratore | Drystones Heugh House Lane NE47 6ND Haydon Bridge Northumberland | England | British | 52698930001 | |||||||||
| LUMSDEN, Roy Andrew | Amministratore | Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Millstream Berkshire | United Kingdom | British | 199053700001 | |||||||||
| MORRIS, David Richard | Amministratore | Churchfield 1 Top Street Wing LE15 8SE Oakham Leicestershire | United Kingdom | British | 36692700001 | |||||||||
| MURPHY, Jonathan David | Amministratore | 74 Beaconsfield Place AB15 4AJ Aberdeen Aberdeenshire | British | 115205970001 | ||||||||||
| OZSANLAV, Richard | Amministratore | Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Millstream Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 147826530002 | |||||||||
| PICOTTE, Christopher | Amministratore | 200 Clarendon Street 55th Floor MA 02117 Boston Arclight Capital Partners Llc Usa | American | 116230600001 | ||||||||||
| ROGER, Jonathan Leslie | Amministratore | AB15 | United Kingdom | British | 124423900001 | |||||||||
| ROGER, Jonathan Leslie | Amministratore | AB15 | United Kingdom | British | 124423900001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di NSIP (ETS) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kellas North Sea 2 Limited | 21 dic 2017 | 11-12 St James's Square SW1Y 4LB London Suite 1, 3rd Floor United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Gb Gas Holdings Limited | 06 apr 2016 | Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Millstream Berkshire United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
NSIP (ETS) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 26 mar 2018 Consegnato il 26 mar 2018 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione N/A. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 24 gen 2007 Consegnato il 31 gen 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All of the chargor's rights to and title and interest from time to time in the whole of its property,assets,rights and revenues,whatsoever and wheresoever,present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond and floating charge | Creato il 22 gen 2007 Consegnato il 31 gen 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Floating charge over the assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 lug 2006 Consegnato il 28 lug 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All the company's rights to and title and interest from time to time in the relevant project accounts, all account proceeds, by way of first floating charge all the company's rights to and title and interest from time to time in the whole of its property, assets, rights and revenues. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Third supplemental deed of amendment to a note purchase agreement dated 23 december 2003 and | Creato il 27 gen 2006 Consegnato il 09 feb 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any group company to the senior finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari If any borrower or the issuer makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of all or any part of the junior liabilities or the subordianted liabilies or the junior lender or any subordianted lender recieves all or any amount in cash, the junior lender will hold any amount so received on trust for the collateral agent,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| First supplemental deed of amendment to a guarantee and debenture dated 23 december 2003 and | Creato il 27 gen 2006 Consegnato il 09 feb 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or CH4 energy limited to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Second supplemental deed of amendment dated 23 december 2005 | Creato il 23 dic 2005 Consegnato il 10 gen 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the parent or the company to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 23 dic 2003 Consegnato il 13 gen 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the parent or the company to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 ago 2003 Consegnato il 04 set 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental debenture | Creato il 01 lug 1999 Consegnato il 14 lug 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each borrower (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document to which such borrower is a party | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 05 giu 1998 Consegnato il 22 giu 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities of each borrower (as defined) to the chargee as agent and trustee for each finance party (as defined) under each finance document (as defined) | |
Brevi particolari By way of first fixed charge all its respective present and future right and title to and interest in the charged assets by way of first floating charge all its assets and undertaking whatsoever and wheresoever both present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0